TOWER MCASHBACK 3 LLP

  • Visión general
  • Resumen
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTOWER MCASHBACK 3 LLP
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada (LLP)
    Número de empresa OC307476
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Dónde se encuentra TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Dirección de la sede social
    Abbey House
    25 Clarendon Road
    RH1 1QZ Redhill
    Surrey
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    TOWER TAXI TECHNOLOGY 35 LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP30 mar 200430 mar 2004

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2015

    3 páginasAA

    Se modificaron los datos del miembro para Mr Simon Charles Maclucas el 12 abr 2015

    3 páginasLLCH01

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2015

    123 páginasLLAR01

    Se modificaron los datos del miembro para Colin Mark Patterson el 09 sept 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Dr Patrick Michael Holmes el 10 oct 2014

    2 páginasLLCH01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 mar 2014

    3 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 27 mar 2014

    123 páginasLLAR01

    Se modificaron los datos del miembro para Mr William Roger Knight el 25 mar 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Ivan John Dodd el 06 abr 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Steven Andrew Sics el 20 abr 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Christopher Craig Wood el 30 mar 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Thomas Mark Harmer Nichols el 11 abr 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Colin Mark Patterson el 18 mar 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Dr Amit Pandey el 01 mar 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Simon Philip Howard el 01 jul 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Mr Michael Antony Pearson el 01 abr 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Mr William Van Marle el 01 mar 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Mr William Roger Knight el 01 feb 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Kevin Ian Simm el 01 feb 2014

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Doctor Isidcra Ranjit-Singh el 30 jun 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Saranjit Singh Nandhra el 01 mar 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Dr Thomas Christopher Haw el 10 may 2013

    2 páginasLLCH01

    Se modificaron los datos del miembro para Gavin Robert Duthie Ralston el 01 ene 2014

    2 páginasLLCH01

    ¿Quiénes son los directivos de TOWER MCASHBACK 3 LLP?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FOX, Peter David
    Piano House
    Warningcamp
    BN18 9QL Arundel
    Miembro designado de LLP
    Piano House
    Warningcamp
    BN18 9QL Arundel
    England141525970001
    SMITH, Simon Alan
    56 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    Miembro designado de LLP
    56 Brantwood Road
    Herne Hill
    SE24 0DJ London
    United Kingdom141416390001
    WRIGHT, John
    Sticklynch
    West Pennard
    BA6 8NA Glastonbury
    Pennard House
    Somerset
    England
    Miembro designado de LLP
    Sticklynch
    West Pennard
    BA6 8NA Glastonbury
    Pennard House
    Somerset
    England
    England141596470002
    AMROLIA, Zarthustra Jal
    13 Albert Place
    W8 5PD London
    Miembro de LLP
    13 Albert Place
    W8 5PD London
    England141595700001
    ANDREWS, Michael David
    15 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    Miembro de LLP
    15 Slayleigh Lane
    Fulwood
    S10 3RF Sheffield
    United Kingdom141320080001
    BARNETT, Michael Forsyth, Dr
    Middleton-On-Leven
    TS15 0JX Yarm,
    Foxgloves
    Cleveland,
    United Kingdom
    Miembro de LLP
    Middleton-On-Leven
    TS15 0JX Yarm,
    Foxgloves
    Cleveland,
    United Kingdom
    England141595720002
    BENATAR, Brian, Dr
    20 Park Street
    Salford
    M7 4NE Manchester
    Miembro de LLP
    20 Park Street
    Salford
    M7 4NE Manchester
    United Kingdom141528570001
    BENNETT, Adam St John
    Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    14
    Kent
    England
    Miembro de LLP
    Moat Farm
    TN2 5XG Tunbridge Wells
    14
    Kent
    England
    England86287430002
    BISHOP, David Glyn
    Craig Meadows
    Ringmer
    BN8 5FB Lewes
    35
    East Sussex
    Miembro de LLP
    Craig Meadows
    Ringmer
    BN8 5FB Lewes
    35
    East Sussex
    United Kingdom61752700003
    BOOTH, John Alan
    Healey Barn
    Quarry View Lower Healey
    OL12 0SY Rochdale
    Miembro de LLP
    Healey Barn
    Quarry View Lower Healey
    OL12 0SY Rochdale
    England141320100001
    BRAHMA, Arun Kevin
    19 Elm Road
    Didsbury
    M20 6XD Manchester
    Miembro de LLP
    19 Elm Road
    Didsbury
    M20 6XD Manchester
    England141434280001
    CALVER, Stephen Robert
    29 Beaulieu Gardens
    West Bridgford
    NG2 7TL Nottingham
    Miembro de LLP
    29 Beaulieu Gardens
    West Bridgford
    NG2 7TL Nottingham
    United Kingdom141595740001
    CARR, Terence John
    1 Highview Place
    Strood Gate
    RH17 7RZ Wivelsfield Green
    Miembro de LLP
    1 Highview Place
    Strood Gate
    RH17 7RZ Wivelsfield Green
    England10933850004
    COHEN, Harvey Stewart
    17 Links Drive
    WD6 3PP Borehamwood
    Miembro de LLP
    17 Links Drive
    WD6 3PP Borehamwood
    England141216890001
    CRAIG WOOD, Christopher
    101 Repulse Bay Road
    Hong Kong
    Apt 15c , The Repulse Bay Apartments
    Hong Kong
    Miembro de LLP
    101 Repulse Bay Road
    Hong Kong
    Apt 15c , The Repulse Bay Apartments
    Hong Kong
    Hong Kong141595760002
    CREMER, Jane Elizabeth
    32 Bowlease Gardens
    Bessacarr
    DN4 6AP Doncaster
    Miembro de LLP
    32 Bowlease Gardens
    Bessacarr
    DN4 6AP Doncaster
    England141693190001
    CROSS, Ian Anderson
    The White House Barn
    Fell Lane Cracoe
    BD23 6LE Skipton
    Miembro de LLP
    The White House Barn
    Fell Lane Cracoe
    BD23 6LE Skipton
    England141527730001
    CURRAN, Patrick Brian
    Corringales
    Dunmow Road, Hatfield Heath
    CM22 7BN Bishop's Stortford
    Miembro de LLP
    Corringales
    Dunmow Road, Hatfield Heath
    CM22 7BN Bishop's Stortford
    United Kingdom86262450003
    DICKENS, Paul, Dr
    5 Hardwick Gardens
    Hardwick Mount
    SK17 6PL Buxton
    Miembro de LLP
    5 Hardwick Gardens
    Hardwick Mount
    SK17 6PL Buxton
    England141595780001
    DODD, Ivan John
    Seltops Close
    GU6 7JW Cranleigh
    15
    Surrey
    England
    Miembro de LLP
    Seltops Close
    GU6 7JW Cranleigh
    15
    Surrey
    England
    England141595800002
    DOHERTY, Norinne
    Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    22
    Middlesex
    England
    Miembro de LLP
    Deerings Drive
    HA5 2NZ Pinner
    22
    Middlesex
    England
    United Kingdom141595790002
    DOUGLAS, Fiona Isabel
    Barns Farm House
    Barns Farm Lane
    RH20 4AH Storrington
    Miembro de LLP
    Barns Farm House
    Barns Farm Lane
    RH20 4AH Storrington
    United Kingdom68770170002
    EDWARD, Malcolm Greig
    Lordswood Road
    B17 9DB Birmingham
    54
    England
    Miembro de LLP
    Lordswood Road
    B17 9DB Birmingham
    54
    England
    United Kingdom141595820002
    ETHERINGTON, Patrick
    24 St. Leonards Road
    East Sheen
    SW14 7LX London
    Miembro de LLP
    24 St. Leonards Road
    East Sheen
    SW14 7LX London
    United Kingdom141595840001
    FAULL, Maurice Leon
    3 Windlesham Gardens
    BN1 3AJ Brighton
    Miembro de LLP
    3 Windlesham Gardens
    BN1 3AJ Brighton
    England3942660004
    FEETUM, Leonard Paul
    4b Edifici El Pui
    Avinguda El Traves
    La Massana
    Ad 400
    Principal D'Andorra
    Miembro de LLP
    4b Edifici El Pui
    Avinguda El Traves
    La Massana
    Ad 400
    Principal D'Andorra
    Andorra141406020001
    FENTON, William James Timothy
    The Warenne
    New Way Lane, Hurstpierpoint
    BN6 9BD Hassocks
    Miembro de LLP
    The Warenne
    New Way Lane, Hurstpierpoint
    BN6 9BD Hassocks
    England141595860001
    FINNERTY, Christopher
    Pinfold Close
    Thornhill
    WF12 0SQ Dewsbury
    1
    West Yorkshire
    England
    Miembro de LLP
    Pinfold Close
    Thornhill
    WF12 0SQ Dewsbury
    1
    West Yorkshire
    England
    United Kingdom141320230002
    GLAISTER, Justin Lee
    25 Luxborough Street
    W1U 5AR London
    Flat 2
    Miembro de LLP
    25 Luxborough Street
    W1U 5AR London
    Flat 2
    United Kingdom142650880001
    GOODALL, Graham Lionel, Dr
    Lee Lane
    SL6 6NU Maidenhead
    The Coach House
    Berkshire
    England
    Miembro de LLP
    Lee Lane
    SL6 6NU Maidenhead
    The Coach House
    Berkshire
    England
    United Kingdom141314030002
    GREENWOOD, Nigel
    Whealden House
    The Street, Warninglid
    RH17 5TR Haywards Heath
    Miembro de LLP
    Whealden House
    The Street, Warninglid
    RH17 5TR Haywards Heath
    England141595880001
    GREGORY, Michael David
    Melbourne
    Wellington Terrace
    BS21 7PS Clevedon
    Flat 1
    Avon
    England
    Miembro de LLP
    Melbourne
    Wellington Terrace
    BS21 7PS Clevedon
    Flat 1
    Avon
    England
    United Kingdom141525460002
    GREY, Keith William, Dr
    3 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    Miembro de LLP
    3 Hove Park Way
    BN3 6PS Hove
    United Kingdom141527810001
    GRIFFIN, Janet Mary
    Wothorpe Towers
    Wothorpe On The Hill
    PE9 3JG Stamford
    Miembro de LLP
    Wothorpe Towers
    Wothorpe On The Hill
    PE9 3JG Stamford
    United Kingdom66248740003
    GRIGGS, Glenn Andrew
    Broomhill Road
    IG8 9HA Woodford Green
    28
    Essex
    England
    Miembro de LLP
    Broomhill Road
    IG8 9HA Woodford Green
    28
    Essex
    England
    United Kingdom104373770002

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0