PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP

PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP

  • Visión general
  • Resumen
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada (LLP)
    Número de empresa OC319739
    JurisdicciónInglaterra/Gales
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Dónde se encuentra PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Dirección de la sede social
    2nd Floor, 48 Beak Street
    W1F 9RL London
    England
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta05 abr 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la sociedad de responsabilidad limitada del registro

    3 páginasLLDS01

    Declaración de confirmación presentada el 30 abr 2017 con actualizaciones

    4 páginasLLCS01

    Domicilio social registrado cambiado de 1/1a Bakery Court London End Beaconsfield Buckinghamshire HP9 2FN a 2nd Floor, 48 Beak Street London W1F 9RL el 09 may 2017

    1 páginasLLAD01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 05 abr 2016

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 30 abr 2016

    3 páginasLLAR01

    change-corporate-member-limited-liability-partnership-with-name-change-date

    1 páginasLLCH02

    Cese del nombramiento de Glyn Selwyn Williams como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Alistair Robert Winrow-Campbell como miembro el 21 feb 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Nigel David Walder como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Philip Stevens como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Martin James Westall como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Anthony George Fieming Philip como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Dominic Kevin O'carroll como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Brendan O Rourke como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Nicola Jane Merson como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Stuart Ian Kirk como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Kulvinder Singh Lall como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de David Mark Kirk como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Kenneth Alan Macpherson como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Matthew Robert Vincent Dickinson como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Eric William Jones como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Jason James Drewett como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    Cese del nombramiento de Tudor Michael Costigan como miembro el 21 dic 2015

    1 páginasLLTM01

    ¿Quiénes son los directivos de PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    PRESCIENCE FILM FINANCE LIMITED
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Miembro designado de LLP corporativo
    London End
    HP9 2FN Beaconsfield
    1/1a Bakery Court
    Buckinghamshire
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro04885246
    142484570001
    SMITH & WILLIAMSON INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United Kingdom
    Miembro designado de LLP corporativo
    Moorgate
    EC2R 6AY London
    25
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro00976145
    141341430001
    ARNOLD, Robert John Dart
    The Old Forge
    Shere Road, Ewhurst
    GU6 7PJ Cranleigh
    Miembro de LLP
    The Old Forge
    Shere Road, Ewhurst
    GU6 7PJ Cranleigh
    England142214600001
    BROWN, Graham Maxwell
    Field Corner
    Buckland Village
    HP22 5HY Aylesbury
    Miembro de LLP
    Field Corner
    Buckland Village
    HP22 5HY Aylesbury
    England141279640001
    COOK, Wayne Anthony
    Forge Cottage 35 South Street
    Draycott
    DE72 3PP Derby
    Miembro de LLP
    Forge Cottage 35 South Street
    Draycott
    DE72 3PP Derby
    England141279770001
    COSTIGAN, Tudor Michael
    Sandal Road
    KT3 5AP New Malden
    26
    Surrey
    England
    Miembro de LLP
    Sandal Road
    KT3 5AP New Malden
    26
    Surrey
    England
    England142214610001
    DICKINSON, Matthew Robert Vincent
    73 Downton Road
    SP2 8AT Salisbury
    Miembro de LLP
    73 Downton Road
    SP2 8AT Salisbury
    United Kingdom142214620001
    DREWETT, Jason James, Dr
    Dunadry House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Miembro de LLP
    Dunadry House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    United Kingdom142214630001
    JONES, Eric William
    14-18 Heddon Street
    Prescience
    W1B 4DA London
    Debello House
    England
    Miembro de LLP
    14-18 Heddon Street
    Prescience
    W1B 4DA London
    Debello House
    England
    England141869900002
    KIRK, David Mark
    Longacre
    Paddock Hill, Mobberley
    WA16 7DH Knutsford
    Miembro de LLP
    Longacre
    Paddock Hill, Mobberley
    WA16 7DH Knutsford
    United Kingdom93313960002
    KIRK, Stuart Ian
    Topps Cottage, Congleton Road
    Nether Alderley
    SK10 4TP Macclesfield
    Miembro de LLP
    Topps Cottage, Congleton Road
    Nether Alderley
    SK10 4TP Macclesfield
    United Kingdom93313950001
    LALL, Kulvinder Singh, Dr
    77 Hainault Road
    IG7 5DL Chigwell
    Miembro de LLP
    77 Hainault Road
    IG7 5DL Chigwell
    England46745000001
    MACPHERSON, Kenneth Alan
    10 Milburn Walk
    KT18 3JN Epsom
    Surrey
    Miembro de LLP
    10 Milburn Walk
    KT18 3JN Epsom
    Surrey
    United Kingdom142214710001
    MERSON, Nicola Jane
    Wyfold Lodge Cottage
    Wyfold
    RG4 9HU Reading
    Miembro de LLP
    Wyfold Lodge Cottage
    Wyfold
    RG4 9HU Reading
    United Kingdom142214660001
    O ROURKE, Brendan
    31 Frankfurt Road
    Herne Hill
    SE24 9NX London
    Miembro de LLP
    31 Frankfurt Road
    Herne Hill
    SE24 9NX London
    United Kingdom141462050001
    O'CARROLL, Dominic Kevin, Mr.
    The Pines
    4 Chaworth Close
    KT16 0LS Ottershaw
    Miembro de LLP
    The Pines
    4 Chaworth Close
    KT16 0LS Ottershaw
    United Kingdom141455790001
    PHILIP, Anthony George Fieming
    New Barn Farm
    Sibford Gower
    OX15 5RY Banbury
    Miembro de LLP
    New Barn Farm
    Sibford Gower
    OX15 5RY Banbury
    United Kingdom142214680001
    STEVENS, Andrew Philip
    Bridge Cottage
    Henley
    TA10 9BH Langport
    Miembro de LLP
    Bridge Cottage
    Henley
    TA10 9BH Langport
    England142214690001
    WALDER, Nigel David
    19 Courthope Road
    Wimbledon Village
    SW19 7RD London
    Miembro de LLP
    19 Courthope Road
    Wimbledon Village
    SW19 7RD London
    England73052250001
    WESTALL, Martin James
    Charlton All Saints
    SP5 4HD Salisbury
    Charlton Manor Farm
    Miembro de LLP
    Charlton All Saints
    SP5 4HD Salisbury
    Charlton Manor Farm
    England152755570001
    WILLIAMS, Glyn Selwyn
    Cock Lane
    HP13 6XJ High Wycombe
    69a
    Buckinghamshire
    Miembro de LLP
    Cock Lane
    HP13 6XJ High Wycombe
    69a
    Buckinghamshire
    England141906630004
    WINROW-CAMPBELL, Alistair Robert
    Maldon House
    Blockley
    GL56 Moreton-In-Marsh
    Miembro de LLP
    Maldon House
    Blockley
    GL56 Moreton-In-Marsh
    United Kingdom142214700001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    30 abr 2017La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene PRESCIENCE FILM PARTNERS 2.2 LLP alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Charge and deed of assignment
    Creado el 07 sept 2007
    Entregado el 25 sept 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Fixed charge all right title and interest in and to the film all pre print elements all positive prints all soundtrack elements any and all documents all machinery all present and future deposit and other accounts all cash all physical properties of every kind relating to the film the proceeds of anyand/or all of the foregoing. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Cinefinance Insurance Services, Llc
    Transacciones
    • 25 sept 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Legal charge
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 03 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1000,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Breve descripción
    Charge over the property assets and interest in respect of a film provisionally entitled the edge of love.
    Personas con derecho
    • British Broadcasting Corporation
    Transacciones
    • 03 jul 2007Registro de un cargo (395)
    • 12 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 20 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the collateral all pre-print elements all prints soundtrack elements any and all documents receipts or books in respect to the film entitled "the egde of love". See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge and deed of assignment
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 29 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Us$8,353,132 and all other sums from time to time from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All right title and interest in and to the film entitled "the best time of our lives" and all collateral allied ancillary and subsidiary rights and all properties and things of value. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Allied Irish Banks PLC
    Transacciones
    • 29 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge and deed of assignment
    Creado el 14 jun 2007
    Entregado el 25 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    All pre-print elements capable of producing prints or additional pre-print elements including without limitation master negatives... All positive prints negatives prints exposed film developed film... In relation to the film.
    Personas con derecho
    • Finance Wales Investments (4) Limited
    Transacciones
    • 25 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 11 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Debenture
    Creado el 08 jun 2007
    Entregado el 20 jun 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee on any account whatsoever
    Breve descripción
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 20 jun 2007Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)
    Charge over a dedicated security account
    Creado el 05 sept 2006
    Entregado el 07 sept 2006
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All monies due or to become due to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Breve descripción
    Assigns the benefit of the monies now held from time to time in the dedicated security account. By way of fixed and floating charge the right title and interest in and to the dedicated security account and all sums standing to the credit in the dedicated security account. See the mortgage charge document for full details.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 07 sept 2006Registro de un cargo (395)
    • 02 feb 2015Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0