SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Visión general
| Nombre de la empresa | SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada (LLP) |
| Número de empresa | OC320522 |
| Jurisdicción | Inglaterra/Gales |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Dónde se encuentra SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP?
| Dirección de la sede social | 63/66 Hatton Garden 5th Floor, Suite 23 EC1N 8LE London England |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la sociedad de responsabilidad limitada del registro | 4 páginas | LLDS01 | ||
Se modificaron los datos del miembro para Mr Anthony Richard Clarke el 07 jul 2022 | 2 páginas | LLCH01 | ||
Cessation de Paul Scott Thomas en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 1 páginas | LLPSC07 | ||
Cessation de Christopher Neil Hunter Gordon en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 1 páginas | LLPSC07 | ||
Cessation de Anthony Richard Clarke en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 1 páginas | LLPSC07 | ||
Cessation de Mark Thomas Boggett en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 1 páginas | LLPSC07 | ||
Notification de The Summit Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 2 páginas | LLPSC02 | ||
Notification de Pi Capital (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 2 páginas | LLPSC02 | ||
Notification de Cavendish Capital Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 29 oct 2018 | 2 páginas | LLPSC02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | LLCS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart John Mccaffer como miembro el 06 ago 2021 | 1 páginas | LLTM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | LLCS01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 13 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | LLCS01 | ||
Nombramiento de Cn Hunter Gordon Life Interest Trust como socio el 12 sept 2019 | 2 páginas | LLAP02 | ||
Cese del nombramiento de James Ashley Bruegger como miembro el 01 jun 2020 | 1 páginas | LLTM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de V22 50 Worship Street London EC2A 2EA England a 63/66 Hatton Garden 5th Floor, Suite 23 London EC1N 8LE el 05 nov 2019 | 1 páginas | LLAD01 | ||
Nombramiento de Christina Elizabeth Maria Duffy como socio el 14 ago 2019 | 2 páginas | LLAP01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 13 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | LLCS01 | ||
Cese del nombramiento de Christina Elizabeth Maria Duffy como miembro el 10 sept 2018 | 1 páginas | LLTM01 | ||
Cese del nombramiento de Tecf Llc como miembro el 10 sept 2018 | 1 páginas | LLTM01 | ||
¿Quiénes son los directivos de SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGGETT, Mark Thomas | Miembro designado de LLP | Claremont Road Hadley Wood EN4 0HP Barnet 26 Hertfordshire | United Kingdom | 151268190001 | ||||||
| CLARKE, Anthony Richard | Miembro designado de LLP | Hatton Garden 5th Floor, Suite 23 EC1N 8LE London 63/66 England | England | 46175540004 | ||||||
| HUNTER GORDON, Christopher Neil | Miembro designado de LLP | Colne Park Colne Engaine CO6 2QL Colchester | England | 1802880002 | ||||||
| THOMAS, Paul Scott | Miembro designado de LLP | 3 Haversham Place N6 6NG London | England | 45773400003 | ||||||
| ALLAN, John Douglas | Miembro de LLP | 21a Town Walls SY1 1TN Shrewsbury | United Kingdom | 142021680001 | ||||||
| ARKLEY, Alistair Grant | Miembro de LLP | Hurworth Moor House Hurworth Moor DL2 1QG Darlington | United Kingdom | 16410280002 | ||||||
| BOSSOM, Bruce Charles | Miembro de LLP | Overbury Court Overbury GL20 7NP Tewkesbury | United Kingdom | 32773150001 | ||||||
| BOSSOM, Penelope Jane | Miembro de LLP | Overbury Court Overbury GL20 7NP Tewkesbury | United Kingdom | 142021700001 | ||||||
| BRAITHWAITE, Charles Antony Elliott | Miembro de LLP | Haughton Castle Haughton NE46 4AY Hexham | United Kingdom | 142021660001 | ||||||
| BURNS, Richard Ronald James | Miembro de LLP | 31 Saxe Coburg Place EH3 5BP Edinburgh | Scotland | 710280003 | ||||||
| DUFFY, Brian Scott Alan | Miembro de LLP | Dane End House Dane End SG12 0LR Ware | United Kingdom | 142021710001 | ||||||
| DUFFY, Christina Elizabeth Maria | Miembro de LLP | Dane End SG12 0LR Ware Dane End House England | England | 261488080001 | ||||||
| FISHER, Leon Philip | Miembro de LLP | 146 Lady Byron Lane Copt Heath Knowle B93 9BA Solihull | United Kingdom | 24295000001 | ||||||
| GAMMELL, Andrew John | Miembro de LLP | Laguna House Murthly PH1 4HE Perth | Scotland | 45276630001 | ||||||
| GEMMELL, Gavin John Norman | Miembro de LLP | 14 Midmar Gardens EH10 6DZ Edinburgh | Scotland | 477280001 | ||||||
| GLOAG, Ann Heron | Miembro de LLP | Beaufort Castle IV4 7BB Beauly | Scotland | 107808610001 | ||||||
| HECHT, Harry Edgar Bedrich | Miembro de LLP | 21 Brueton Avenue B91 3EN Solihull | United Kingdom | 142021500001 | ||||||
| JACKSON, Alan Roy | Miembro de LLP | Weston Hall Farm Old Warwick Road Rowington CV35 7BT Warwick | England | 15450390002 | ||||||
| JONES, Malcolm Bennett | Miembro de LLP | Plas Cambria, The Fisheries Afonwen CH7 5UW Mold | Wales | 31053410002 | ||||||
| LINDEN, Brian Andrew | Miembro de LLP | 5 Scarth Road SW13 0ND London | England | 36233000004 | ||||||
| LOWE, Brian Ewing | Miembro de LLP | Meadowcroft Newstead Farm Lane TS14 8DJ Guisborough | United Kingdom | 14175990001 | ||||||
| MOORE, Thomas Francis | Miembro de LLP | The Old Surgery Ercall Heath TF10 8NH Newport | United Kingdom | 18379190003 | ||||||
| OWEN, Charles Salisbury St John | Miembro de LLP | The Street Goodnestone CT3 1PJ Canterbury The Dower House Kent United Kingdom | England | 142839660002 | ||||||
| PAINTING, Robert Philip | Miembro de LLP | 5 Boultbee Road B72 1DW Sutton Coldfield | United Kingdom | 9389800001 | ||||||
| PAWLE, Oliver John Woodforde | Miembro de LLP | 33 Blenkarne Road SW11 6HZ London | England | 18017220001 | ||||||
| QUINN, Christopher Ernest | Miembro de LLP | Portland House Bainton Road PE9 4RT Tallington | United Kingdom | 109955260001 | ||||||
| RANKIN, John Mark | Miembro de LLP | Bredons Norton GL20 7EZ Tewkesbury Homer Lodge Glos Uk | England | 63367970001 | ||||||
| RUTTERFORD, Michael David | Miembro de LLP | 22/14 Kinellan Road EH12 6ES Edinburgh | Scotland | 168210050001 | ||||||
| SEALEY, Barry Edward | Miembro de LLP | 2 The Cedars Colinton Road EH13 0PL Edinburgh Flat 5 Scotland | United Kingdom | 23790002 | ||||||
| SOUTER, Brian, Sir | Miembro de LLP | PH7 Ochtertyre By Crieff Ochtertyre House Perthshire | Scotland | 137723690001 | ||||||
| STEPHENSON, Roy Alan | Miembro de LLP | Atkinson House Brough Park DL10 7PJ Richmond | United Kingdom | 124131220001 | ||||||
| STEVENSON, David Deas | Miembro de LLP | Springhill DG13 0LP Langholm | Scotland | 22838300001 | ||||||
| SWORD, Ian Pollock, Doctor | Miembro de LLP | 13 Napier Road EH10 5AZ Edinburgh | United Kingdom | 141910600001 | ||||||
| TEMPLE, Richard | Miembro de LLP | Ebury Bridge Road SW1W 8PZ London 32 | United Kingdom | 142839670001 | ||||||
| WYETH, Robert Beals | Miembro de LLP | 20d Uxbridge Road KT1 2LL Kingston Upon Thames | United Kingdom | 142021620001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de SERAPHIM CAPITAL (GENERAL PARTNER) LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Summit Group Limited | 29 oct 2018 | 5 Cloisters House Battersea Park Road SW8 4BG London 5 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Pi Capital (Holdings) Limited | 29 oct 2018 | Piccadilly 6th Floor W1J 7NJ London 105 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Cavendish Capital Ltd | 29 oct 2018 | Claremont Road EN4 0HP Barnet 26 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Mark Thomas Boggett | 06 abr 2016 | Claremont Road EN4 0HP Enfield 26 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Paul Scott Thomas | 06 abr 2016 | Haversham Place N6 6NG London 3 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr John Arthur May | 06 abr 2016 | Lawton Street Mclean 722 Va22101 United States | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: American País de residencia: United States | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Christopher Neil Hunter Gordon | 06 abr 2016 | Colne Engaine CO6 2QL Colchester Colne Park England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Anthony Richard Clarke | 06 abr 2016 | Elm Quay Court 30 Nine Elms Lane SW8 5DF London Flat 57 England | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: British País de residencia: England | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0