THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Declaraciones de personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC001846
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción
    • Alquiler y explotación de bienes inmobiliarios de entidades de vivienda (68201) / Actividades inmobiliarias

    ¿Dónde se encuentra THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Atria One
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY PLC02 abr 188902 abr 1889

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2016

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    10 páginasLIQ13(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX el 20 jul 2018

    2 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Zahra Peermohamed como secretario el 19 jul 2018

    1 páginasTM02

    Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 páginasAD03

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 15 Atholl Crescent Edinburgh EH3 8HA

    2 páginasAD02

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 19 jun 2018

    LRESSP

    Nombramiento de Miss Zahra Peermohamed como secretario el 01 mar 2018

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Stephen Roy Slocombe como secretario el 28 feb 2018

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Stephen Roy Slocombe como director el 28 feb 2018

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2017 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016

    14 páginasAA

    Nombramiento de Mr Paul Stewart Girling como director el 11 sept 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Damien Ivo Karlov como director el 28 jul 2017

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Manager Derek Carter como director el 24 feb 2017

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Anupam Manchanda como director el 02 mar 2017

    1 páginasTM01

    Declaración de confirmación presentada el 14 dic 2016 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015

    13 páginasAA

    Cancelación total de la carga 405

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 404

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 399

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 369

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 395

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 320

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 347

    4 páginasMR04

    ¿Quiénes son los directivos de THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CARTER, Derek
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish225848070001
    GIRLING, Paul Stewart
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    Director
    144 Morrison Street
    EH3 8EX Edinburgh
    Atria One
    United KingdomBritish225432580001
    BAMBER, Janine Margaret
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    Secretario
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    British117898690001
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Secretario
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, David Allan
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    Secretario
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    British37710002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secretario
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secretario
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    PARSONS-WEISS, Beatrix
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secretario
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    German93618170002
    PEERMOHAMED, Zahra
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Secretario
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    243694040001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Secretario
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    British55097590003
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Secretario
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    ABRAMSON, Christoffer
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Director
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Swedish98463110004
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Director
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BIRCH, Paul Adrian
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    Director
    Gorselands
    PA11 3AT Bridge Of Weir
    ScotlandBritish772720001
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Director
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    BOWDEN, Matthew Neville
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish183344960001
    BURTON, Caroline Mary
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    Director
    3 Helmet Row
    EC1V 3QJ London
    EnglandBritish596070001
    CAIRNS, James Scott
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    Director
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    British33041530001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Director
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Director
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Director
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Director
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Director
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    JACK, Robert Barr, Professor
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    Director
    50 Lanton Road
    Lanton Park
    G43 2SR Glasgow
    ScotlandBritish940950004
    KANE, William James
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    Director
    11 St Peters Street
    Islington
    N1 8JD London
    British73972820001
    KARLOV, Damien Ivo
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomIrish202318870001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Director
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910001
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Director
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MACPHERSON, John Hannah Forbes
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    Director
    16 Collylinn Road
    Bearsden
    G61 4PN Glasgow
    British295710001
    MALCOLM, David
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    Director
    40 Priory Drive
    RH2 8AF Reigate
    Surrey
    British295690001
    MANCHANDA, Anupam
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomIndian196338510001
    MARFLEET, Thomas
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish139855250001

    ¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED?

    Declaraciones de personas con control significativo
    Notificado elCesado elDeclaración
    14 dic 2016La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa.

    ¿Tiene THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Cash deposit pledge
    Creado el 26 may 2004
    Entregado el 03 jun 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 jun 2004Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creado el 23 abr 2004
    Entregado el 06 may 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The company pledges and assigns the charged account and the deposit.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 may 2004Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creado el 03 feb 2004
    Entregado el 16 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The charged account and deposit. Account no. 06019951 and the sum of £1,276,957.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 feb 2004Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Cash deposit pledge
    Creado el 20 ene 2004
    Entregado el 30 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Company pledges and assigns the charged account and deposit.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 ene 2004Registro de un cargo (410)
    • 13 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 30 dic 2003
    Entregado el 13 ene 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground extending to 1.358 ha situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2004Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Assignation of rents
    Creado el 23 dic 2003
    Entregado el 31 dic 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with any finance document
    Breve descripción
    The rental income in relation to 27 milton link, newcraighall, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 31 dic 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 04 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The whole of the obligations as contained in the contract
    Breve descripción
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Meadowfield Developments Limited
    Transacciones
    • 04 sept 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 04 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The whole obligations as contained in the contract
    Breve descripción
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Meadowfield Developments Limited
    Transacciones
    • 04 sept 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 22 ago 2003
    Entregado el 04 sept 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    The whole obligations as contained in the contract
    Breve descripción
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • Meadowfield Developments Limited
    Transacciones
    • 04 sept 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 24 jun 2003
    Entregado el 08 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Payment of stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of a trust deed
    Breve descripción
    201/205 x 207 dalry road and 24 orwell terrace, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 jun 2003
    Entregado el 08 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Breve descripción
    The subjects on the east side of mavor avenue and the north side of howard avenue, east kilbride--title number LAN36104.
    Personas con derecho
    • Law Debenture Trustees Limited
    Transacciones
    • 08 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 jun 2003
    Entregado el 08 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as defined in the trust deed
    Breve descripción
    32/46 houston street, glasgow--title number GLA33572.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 23 jun 2003
    Entregado el 08 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations in terms of the trust deed
    Breve descripción
    19-25 houston street, glasgow--title number GLA102404 and 33 houston street, glasgow--title number GLA102402.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 20 jun 2003
    Entregado el 08 jul 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Payment of the stock and interest thereon and all other moneys and obligations as in the trust deed
    Breve descripción
    The subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 jul 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 16 jun 2003
    Entregado el 18 jun 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Piccadilly trading estate, manchester.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 18 jun 2003Registro de un cargo (410)
    • 23 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The road on the north or northwest leading from cadzoe street to hamilton station, hamilton.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects at jesmond drive, bridge of don, aberdeen.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    223/229 ingram street and 91 miller street, glasgow.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 28 abr 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    20/22 south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    23 south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    12/12A south gyle crescent, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Piece of ground situated to the south east of and adjacent to the asda south roundabout, milton road link/A1 musselburgh bypass in the city of edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    201/205 dalry road, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 13 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Princes mall shopping centre, edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 03 ene 2003
    Entregado el 20 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    42/50 watt street, glasgow--title number GLA93893.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 2003Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene THE SCOTTISH METROPOLITAN PROPERTY COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    10 sept 2019Fecha prevista de disolución
    19 jun 2018Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0