ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC008975
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    109 Douglas Street
    Glasgow
    G2 4HB
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARBUCKLE, SMITH & COMPANY LIMITED01 dic 198701 dic 1987
    ARBUCKLE SMITH (HOLDINGS) LIMITED09 feb 191409 feb 1914

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cese del nombramiento de Christopher Waters como director

    1 páginasTM01

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de modificación del Memorándum de Asociación

    RES01

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total para empresas pequeñas preparadas hasta el 31 dic 2009

    4 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 11 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 sept 2010

    Estado de capital el 09 sept 2010

    • Capital: GBP 450,000
    SH01

    Cambio de datos del director Exel Nominee No 2 Limited el 10 ago 2010

    2 páginasCH02

    Cambio de datos del secretario Exel Secretarial Services Limited el 10 ago 2010

    2 páginasCH04

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    5 páginasAA

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    4 páginasAA

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    5 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2005

    5 páginasAA

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2004

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    EXEL SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro817717
    32524900007
    TAYLOR, Paul
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    Director
    2a High Street
    Ringstead
    NN14 4DA Kettering
    Northamptonshire
    EnglandBritish105652320001
    EXEL NOMINEE NO 2 LIMITED
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Director corporativo
    The Ring
    RG12 1AN Bracknell
    Ocean House
    Berkshire
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro1183615
    73807850002
    ARROWSMITH, Michael Richard
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    Secretario
    Greenbanks
    154 Piccotts End Road
    HP1 3AU Hemel Hempstead
    Hertfordshire
    British64948610002
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Secretario
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    British69617780001
    BUSH, Nicholas James
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    Secretario
    50 Chester Drive
    HA2 7PU Harrow
    Middlesex
    British69612020001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Secretario
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    British719840001
    MILLS, John Michael
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    Secretario
    103 Moffats Lane
    AL9 7RP Brookmans Park
    Hertfordshire
    British193353200001
    SMITH, Nicholas Leigh
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    Secretario
    34 Castle Hill Avenue
    HP4 1HJ Berkhamsted
    Hertfordshire
    British45625440002
    STALBOW, Michael Robert
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    Secretario
    38 St Marys Avenue
    HA6 3AZ Northwood
    Middlesex
    British15165070001
    AUSTIN, Keith James
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    Director
    Little Orchard House 41 New Road
    Tylers Green
    HP10 8DN High Wycombe
    Buckinghamshire
    EnglandBritish69617780001
    BUMSTEAD, Jonathan Culver
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    Director
    Eastland Cottage
    Hall Place
    GU6 8LA Cranleigh
    Surrey
    United KingdomBritish72820970001
    ELLIS, Michael John
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    Director
    Little Trodgers
    Honor End Lane, Prestwood
    HP16 9HG Buckinghamshire
    EnglandBritish133791220001
    GILES, Bruce Sinclair
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    Director
    50a Warwick Place
    CV32 5DF Leamington Spa
    Warwickshire
    England
    British63973720001
    JOHNSTON, Geoffrey E F
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    Director
    Upper Dunard
    Station Road
    G84 8LW Rhu
    Dunbartonshire
    Scotland
    British616920001
    KIRKBY, Peter
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    Director
    Newnham View
    Newnham Green
    RG27 9AS Basingstoke
    Hampshire
    British22731280001
    MACRAE, James Norman
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    Director
    Burnside Cottage
    Gartocharn
    G83 8SD Alexandria
    Dunbartonshire
    ScotlandBritish719840001
    OWER, James
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    Director
    33 Cantley Crescent
    RG11 1NU Wokingham
    Berkshire
    British719860001
    PARKHILL, Thomas Cassidy
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    22 Ayr Road
    Giffnock
    G46 6RY Glasgow
    Lanarkshire
    British719870001
    RUSCH, Henry
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    Director
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    British63973770001
    SMITH, Jamie Robert Mark
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    Director
    Tanglewood
    33 Woodend Drive
    SL5 9BD Sunninghill
    Berkshire
    United KingdomBritish74084830002
    WATERS, Christopher Stephen
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    Director
    5 Five Acres
    WD4 9JU Kings Langley
    Hertfordshire
    EnglandBritish54969250001
    WILLIS, Nigel A R
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    Director
    Nervelstone
    PA12 4DS Lochwinnoch
    Renfrewshire
    Scotland
    British616900001
    WOODHAMS, Ernest J
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    Director
    5 Rectory Close
    BN20 8AQ Eastbourne
    East Sussex
    England
    British616890001

    ¿Tiene ARBUCKLE, SMITH INVESTMENTS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Assignation of deposit account
    Creado el 02 jul 1987
    Entregado el 14 jul 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    £300,000 deposit account held by the company with investors in industry PLC.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 14 jul 1987Registro de una carga
    • 10 nov 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 13 ago 1986
    Entregado el 21 ago 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease granted by the city of glasgow district council in favour of the company over 5 acres and 3 1/10TH parts of an acre.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 ago 1986Registro de una carga
    • 17 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 19 oct 1984
    Entregado el 30 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due, or to become due not exceeding £300,000
    Breve descripción
    89/99 mitchell st. Glasgow.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 30 oct 1984Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 19 oct 1984
    Entregado el 30 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Warehouse at ferry rd glasgow.
    Personas con derecho
    • Investors in Industry PLC
    Transacciones
    • 30 oct 1984Registro de una carga
    • 18 abr 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 12 oct 1984
    Entregado el 26 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Steading of ground containing four hundred and eighty eight square yards or thereby lying on the west side of mitchell street, glasgow, in the city parish of glasgow and county of lanark that area of ground extending to one hundred and forty five square yards or thereby lying on the west side of mitchell street aforesaid and in said county.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1984Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 10 oct 1984
    Entregado el 22 oct 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Plots of ground in glasgow first in mitchell street containing 488 sq yards and second plot 145 sq. Yards in mitchel street.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1984Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 07 jun 1983
    Entregado el 22 jun 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 22 jun 1983Registro de una carga
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 07 jun 1983
    Entregado el 20 jun 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 jun 1983Registro de una carga
    • 05 mar 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 06 mar 1980
    Entregado el 11 mar 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £201,686,77
    Breve descripción
    Area of ground extending to 4 acres and 37 1/100TH parts of an acre in paisley, renfrew.
    Personas con derecho
    • The District Council of Renfrew
    Transacciones
    • 11 mar 1980Registro de una carga
    • 13 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Assignation
    Creado el 09 dic 1975
    Entregado el 12 dic 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Endowment policy no.1378328 Dd. 19/9/75 insd. By commercial union assurance co. LTD. On life of geoffrey edward forshaw johnston for £150,000.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Co. LTD 1 Undershaft, London. EC3P 3DQ
    Transacciones
    • 12 dic 1975Registro de una carga
    • 17 feb 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 dic 1975
    Entregado el 05 dic 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Advances made or to be made in terms of agreement at 24TH july & 1ST febry 1973
    Breve descripción
    Lease of 5.3 acres in ferry rd. Glasgow.
    Personas con derecho
    • Commercial Union Assurance Company LTD
    Transacciones
    • 05 dic 1975Registro de una carga
    • 27 abr 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 19 jun 1975
    Entregado el 08 jul 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Warehouse premises lying to the north of thornliebank road, lanark.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 jul 1975Registro de una carga
    • 15 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0