PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC010074 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
- Actividades de organizaciones profesionales de miembros (94120) / Otras actividades de servicios
¿Dónde se encuentra PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Dirección de la sede social | Titanium 1 Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| PROPERTY OWNERS AND FACTORS ASSOCIATION, SCOTLAND, LIMITED (THE) | 10 feb 1986 | 10 feb 1986 |
| PROPERTY OWNERS AND FACTORS ASSOCIATION, GLASGOW, LTD. (THE) | 03 jun 1918 | 03 jun 1918 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 nov 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 ago 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 nov 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 ene 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 04 feb 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 ene 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Pennyland Property Management Consulting Limited como secretario el 31 may 2025 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Robyn Rae como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Fraser Hamilton como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Gordon Buchanan como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Callum Stewart Alasdair Seale como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Adele Elizabeth Mclaughlin como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Derek Alexander Macdonald como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Paul Mcdermott como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de David Angus Coll Doran como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de George Mcguire como director el 31 may 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2024 | 27 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Fraser Hamilton como director el 07 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Callum Stewart Alasdair Seale como director el 07 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Ms Robyn Rae como director el 07 mar 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Iain James Friel como director el 07 mar 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de David James King Reid como director el 31 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Ross William Watt como director el 01 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Nic Mayall como director el 01 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Jacqueline Borthwick como director el 01 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 nov 2023 | 26 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cambio de datos del director Mr Paul Michael Mcdermott el 06 mar 2023 | 2 páginas | CH01 | ||
Nombramiento de Mr Gordon Buchanan como director el 03 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Mr Paul Michael Mcdermott como director el 03 mar 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
¿Quiénes son los directivos de PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BISSET, Neale Alexander | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | British | 244352490001 | |||||||||
| BRUCE, Callum Alexander | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | British | 301585360001 | |||||||||
| BISHOP, Morison | Secretario | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow Lanarkshire | British | 65881680001 | ||||||||||
| MCDIARMID, Alison | Secretario | Bothwell Street G2 6NL Glasgow C/O Scott Moncrieff, 25 Scotland | 252975840001 | |||||||||||
| BISHOPS | Secretario corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 83486520001 | |||||||||||
| BISHOPS SOLICITORS LLP | Secretario corporativo | 2 Blythswood Square G2 4AD Glasgow | 101843650001 | |||||||||||
| BRODIES SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Atholl Crescent EH3 8HA Edinburgh 15 Midlothian United Kingdom |
| 79799970001 | ||||||||||
| PENNYLAND PROPERTY MANAGEMENT CONSULTING LIMITED | Secretario corporativo | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | 254533400001 | |||||||||||
| WJM SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | St. Vincent Street G2 5RZ Glasgow 302 Scotland |
| 79915470001 | ||||||||||
| ADAIR, Brian | Director | 15 Blackford Road EH9 2DT Edinburgh | Scotland | British | 292880002 | |||||||||
| ANDERSON, Gordon Stewart | Director | 24 Blair Drive Milton Of Campsie G65 8DS Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 99380001 | |||||||||
| BISSET, Robert Manners | Director | 3 Derwentwater East Kilbride G75 8JT Glasgow Lanarkshire | British | 330230001 | ||||||||||
| BORTHWICK, Jacqueline | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | British | 223815460001 | |||||||||
| BOYLE, John | Director | 42 Edgehill Road G11 7JD Glasgow Lanarkshire | Scotland | British | 332660001 | |||||||||
| BRUCE, Iain Stewart | Director | Sprawlie, Buchanan Castle Estate Drymen G63 0HX Glasgow | Scotland | British | 238890001 | |||||||||
| BUCHANAN, Gordon | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | British | 240464520001 | |||||||||
| BUCHANAN, James Stuart | Director | 14 Graham Crescent Cardross G82 5JH Dumbarton Dunbartonshire | United Kingdom | British | 8887010002 | |||||||||
| BURGESS, Charles Douglas | Director | 1 Wolfe Avenue Newton Mearns G77 6TQ Glasgow Lanarkshire | British | 269530001 | ||||||||||
| BURNETT, Richard Stephen | Director | Slade Redford Carmyllie DD11 2RE Arbroath Angus | United Kingdom | British | 35987170002 | |||||||||
| CAMPBELL, Colin Crawford | Director | 5 The Lindens Mill Road G71 8DE Bothwell | British | 41944470004 | ||||||||||
| CAMPBELL, Robert Glen | Director | 5 Dalreoch Avenue Baillieston G69 5EQ Glasgow | Scotland | British | 46210740001 | |||||||||
| CARNEGIE, Angus John | Director | Braehead House 5 Tannage Brae DD8 4ES Kirriemuir Angus | United Kingdom | British | 56731340004 | |||||||||
| CARNEGIE, Angus John | Director | 83 Magdalen Yard Road DD2 1BA Dundee Angus | British | 56731340002 | ||||||||||
| CRAIG, Andrew Robertson | Director | Kilmory Lawmarnock Road PA11 3AP Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 41847350001 | ||||||||||
| CRAIG, Andrew Robertson | Director | Kilmory Lawmarnock Road PA11 3AP Bridge Of Weir Renfrewshire | British | 41847350001 | ||||||||||
| CUMMING, Andrew Law Gordon | Director | 91 Kinghorn Drive G44 4TF Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 269570001 | |||||||||
| CUMMING, Andrew Law Gordon | Director | 91 Kinghorn Drive G44 4TF Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 269570001 | |||||||||
| CURRIE, Archibald Malcolm Thomson | Director | 74 Bay Road Wormit DD6 8LZ Newport On Tay Fife | British | 37800001 | ||||||||||
| CURRIE, Archibald Malcolm Thomson | Director | 74 Bay Road Wormit DD6 8LZ Newport On Tay Fife | British | 37800001 | ||||||||||
| DICKSON, Graeme | Director | 62 Glasserton Road G43 2LL Glasgow | Scotland | British | 792820003 | |||||||||
| DONALD, Ian | Director | 35 Russell Drive Bearsden G61 3BB Glasgow Dunbartonshire | United Kingdom | British | 32153540001 | |||||||||
| DORAN, David Angus Coll | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | Scottish | 153951240004 | |||||||||
| DORAN, David | Director | Bothwell Street G2 6NL Glasgow C/O Scott Moncrieff, 25 Scotland | Scotland | British | 153951240003 | |||||||||
| DOUGLAS, Gordon Wilson | Director | Kings Inch Place PA4 8WF Renfrew Titanium 1 Scotland | Scotland | British | 174543960002 | |||||||||
| ENGLISH, Alan Thomas | Director | 67 Lubnaig Road G43 2RX Glasgow | British | 40172140001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para PROPERTY MANAGERS ASSOCIATION SCOTLAND LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 21 ene 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0