CAPARO (TIPTON) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CAPARO (TIPTON) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC010201 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CAPARO (TIPTON) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra CAPARO (TIPTON) LIMITED?
| Dirección de la sede social | 5 Albyn Place EH2 4NJ Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CAPARO (TIPTON) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BARTON ABRASIVES LIMITED | 13 ene 1919 | 13 ene 1919 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CAPARO (TIPTON) LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2016 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2017 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CAPARO (TIPTON) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Patrick Dancaster como director el 11 nov 2016 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 4 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 29 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Claire Smith como director el 03 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 jun 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2014 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Claire Smith como director el 17 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Georgina Mason como director el 16 feb 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 jun 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 jun 2013 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Hyland como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Miss Georgina Mason como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Stilwell como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Stilwell como secretario | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 jun 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 5 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 18 jun 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de * Quartermile Two 2 Lister Square Edinburgh EH3 9GL* el 20 jun 2011 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
legacy | 25 páginas | MG01s | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CAPARO (TIPTON) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Secretario | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | British | 108203800001 | ||||||
| CHEUNG, Wing Yee | Secretario | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | 59538730002 | ||||||
| MILLS, Stephen John | Secretario | 6 Quincy Rise DY5 3LL Brierley Hill West Midlands | British | 530720001 | ||||||
| PEGLER, Ruth | Secretario | 12 Barker Road B74 2NY Sutton Coldfield West Midlands | British | 42051530002 | ||||||
| PRICE, Sharon Ann | Secretario | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | 77855650002 | ||||||
| RAWLINGS, Kevin Hedley | Secretario | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | British | 84159580002 | ||||||
| SMITH, John Godfrey | Secretario | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | British | 56051330001 | ||||||
| STILWELL, Michael James | Secretario | Albyn Place EH2 4NJ Edinburgh 5 Scotland | 150778920001 | |||||||
| ASTON, Arthur J | Director | 34 Cedar Gardens Kinver DY7 6BW Stourbridge West Midlands | British | 780720001 | ||||||
| BACHE, Mark John Thomas | Director | 47 Chesterwood Road Kings Heath B13 0QG Birmingham West Midlands | British | 42051490001 | ||||||
| BAILEY, Stephen Geoffrey | Director | Abbey Gardens ST18 0RY Great Haywood 1 Staffordshire | England | British | 108203800001 | |||||
| CHEUNG, Wing Yee | Director | 78 Park Hill Road Harborne B17 9HJ Birmingham | British | 59538730002 | ||||||
| DANCASTER, David Patrick | Director | Kenilworth Avenue SW19 7LN London 1 | England | British | 55380530001 | |||||
| HANNA, Richard Guy Crawford, Doctor | Director | The Tile House 26 Pound Lane Sonning On Thames RG4 6XE Reading Berkshire | British | 12310490001 | ||||||
| HOLMES, Alan | Director | 3 Corran Road ST17 9QG Stafford Staffordshire | British | 530750001 | ||||||
| HYLAND, Matthew William Edward | Director | Popes Lane B69 4PJ Oldbury Caparo House West Midlands | United Kingdom | British | 152453950001 | |||||
| INSCOE, Alan E | Director | 58 Leigh Road WS4 2DS Walsall West Midlands | British | 780750001 | ||||||
| MASON, Georgina | Director | Albyn Place EH2 4NJ Edinburgh 5 Scotland | England | British | 173302440001 | |||||
| MAY, Geoffrey John, Doctor | Director | Troutbeck House 126 Main Street, Swithland LE12 8TJ Loughborough Leicestershire | British | 70548680001 | ||||||
| MILLS, Stephen John | Director | 6 Quincy Rise DY5 3LL Brierley Hill West Midlands | British | 530720001 | ||||||
| MOORE, John Albert | Director | 8 Mere Close TF11 9QA Shifnal Salop | British | 530730001 | ||||||
| MUIR, Samuel T | Director | 46 Deeside Crescent AB1 7PT Aberdeen Aberdeenshire | British | 780740001 | ||||||
| PAUL, Ambar, The Honourable | Director | Ambika House 9-11 Portland Place W1B 1PR London Flat 19 United Kingdom | United Kingdom | British | 92729600003 | |||||
| PEGLER, Ruth | Director | 12 Barker Road B74 2NY Sutton Coldfield West Midlands | British | 42051530002 | ||||||
| PRICE, Sharon Ann | Director | 80 Grafton Road Oldbury B68 8BJ Warley West Midlands | British | 77855650002 | ||||||
| RAWLINGS, Kevin Hedley | Director | 75 Harrington Croft B71 3RJ West Bromwich West Midlands | United Kingdom | British | 84159580002 | |||||
| SALMOND, Robert Loudon Park | Director | 6 The Greenlands Wombourne WV5 8DP Wolverhampton West Midlands | British | 530740001 | ||||||
| SMITH, Claire | Director | Albyn Place EH2 4NJ Edinburgh 5 | England | British | 195772990001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Director | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| SMITH, John Godfrey | Director | Chequerfield House 32 Showell Lane Lower Penn WV4 4TT Wolverhampton West Midlands | United Kingdom | British | 56051330001 | |||||
| STILWELL, Michael James | Director | Albyn Place EH2 4NJ Edinburgh 5 Scotland | United Kingdom | British | 142098630001 | |||||
| SZULAKOWSKI, Roy | Director | 14 Dewberry Drive WS5 4RZ Walsall West Midlands | British | 1167310003 | ||||||
| WILLIAMS, Martin | Director | 6 Horsham Avenue Wordsley DY8 5LU Stourbridge West Midlands | British | 780730001 | ||||||
| WOOD, John Franklin | Director | 27 Oak Hill Drive Edgbaston B15 3UG Birmingham West Midlands | England | British | 1397720001 |
¿Tiene CAPARO (TIPTON) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Security agreement | Creado el 30 jul 2010 Entregado el 19 ago 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0