FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC012483 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Dirección de la sede social | 319 St. Vincent Street G2 5AS Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| OLAER INDUSTRIES LIMITED | 13 ago 2001 | 13 ago 2001 |
| EXPAMET INDUSTRIES LIMITED | 04 nov 1986 | 04 nov 1986 |
| METAL INDUSTRIES, LIMITED | 15 dic 1922 | 15 dic 1922 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 7 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG a 319 st. Vincent Street Glasgow G2 5AS el 18 ene 2022 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graham Mark Ellinor el 20 mar 2017 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Graham Mark Ellinor el 20 mar 2017 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graham Mark Ellinor el 27 may 2018 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 20 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3-5 Melville Street Edinburgh EH3 7PE a Saltire Court 20 Castle Terrace Edinburgh EH1 2EG el 10 abr 2017 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||
Estado de capital el 20 may 2016
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 18 may 2016
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2015 | 5 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 27 jul 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Mr Graham Mark Ellinor el 01 sept 2015 | 1 páginas | CH03 | ||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Graham Mark Ellinor el 01 sept 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2014 | 12 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Dominic O'reilly como secretario el 31 ago 2014 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Mr Graham Mark Ellinor como secretario el 08 sept 2014 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de John Dominic O'reilly como director el 31 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLINOR, Graham Mark | Secretario | 55 Maylands Avenue HP2 4SJ Hemel Hempstead Parker House Hertfordshire England | 190880050001 | |||||||
| ELLINOR, Graham Mark | Director | 55 Maylands Avenue HP2 4SJ Hemel Hempstead Parker House Hertfordshire England | United Kingdom | British | 102575170003 | |||||
| ELSEY, James Alan David | Director | St. Vincent Street G2 5AS Glasgow 319 | England | Scottish | 190881520001 | |||||
| BLENKINSOP, Michael | Secretario | 6 Hazelbank Kings Norton B38 8BT Birmingham | English | 34390200001 | ||||||
| HEWITT, John Donald Kerr | Secretario | 16 Coppice Gardens RG45 6EE Crowthorne Berkshire | British | 650900001 | ||||||
| KITE, Neville Francis | Secretario | Cheriton Rowton Lane Rowton CH3 6AT Chester Cheshire | British | 112502910001 | ||||||
| O'REILLY, John Dominic | Secretario | Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 United Kingdom | 170506470001 | |||||||
| TAYLOR, Martyn | Secretario | Ardenode Broom Way KT13 9TQ Weybridge Surrey | British | 49551600002 | ||||||
| BAENA, Richard | Director | 12 Rue Diderot Saint Germain En Laye 78100 Paris France | French | 46341100002 | ||||||
| BEASLEY, Jeremy Griffin | Director | Middle Sutherland Sheriffhales TF11 8RA Shifnal Shropshire | British | 35733840001 | ||||||
| BLENKINSOP, Michael | Director | 6 Hazelbank Kings Norton B38 8BT Birmingham | United Kingdom | English | 34390200001 | |||||
| HAUXWELL, Timothy Norbury | Director | The Shielings Highgrove Gardens Edwalton NG12 4DF Nottingham | British | 70993740001 | ||||||
| HEWITT, John Donald Kerr | Director | 16 Coppice Gardens RG45 6EE Crowthorne Berkshire | British | 650900001 | ||||||
| HUGHES, Thomas Michael | Director | 142 Forest Hills Newry BT34 2FJ County Down | Northern Ireland | Irish | 171963490001 | |||||
| O'REILLY, John Dominic | Director | Melville Street EH3 7PE Edinburgh 3-5 United Kingdom | United Kingdom | British | 119108080001 | |||||
| ORR, Alex | Director | 13 Harwood Drive Uxbridge UB10 0BG Hillingdon Middlesex | British | 75397180001 | ||||||
| REEDER, Philip | Director | 2 Culverwood Cottages Little London Road Cross In Hand TN21 0AX Heathfield East Sussex | British | 65969990002 | ||||||
| TAYLOR, Martyn | Director | Ardenode Broom Way KT13 9TQ Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 49551600002 | |||||
| WILSON, Richard Haigh | Director | Fairfield House Goose Hill Headley RG15 8AU Newbury Berkshire | England | British | 776180001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaer International Limited | 06 abr 2016 | 55 Maylands Avenue HP2 4SJ Hemel Hempstead Parker House Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Floating charge | Creado el 02 sept 2005 Entregado el 15 sept 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Debenture | Creado el 02 sept 2005 Entregado el 15 sept 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción By way of first fixed charge over freehold and leasehold property in england and wales and fixed and floating charges. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 09 jul 2001 Entregado el 12 jul 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 22 jul 1992 Entregado el 26 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción See page 2 of doc paper apart. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Creado el 22 jul 1992 Entregado el 26 oct 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción See page 2 of doc schedule. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene FAWCETT CHRISTIE INTERNATIONAL LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0