ROK ESTATES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaROK ESTATES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC013685
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ROK ESTATES LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra ROK ESTATES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    151 St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ROK ESTATES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    CITY ESTATES LIMITED26 may 192526 may 1925

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ROK ESTATES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ROK ESTATES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Julian Turnbull como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Sandra Al-Kordi como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    1 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 18 may 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 may 2010

    Estado de capital el 26 may 2010

    • Capital: GBP 171,666
    SH01

    Nombramiento de Mr Julian Patrick Turnbull como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Sandra Joan Al-Kordi como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Julian Turnbull como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Ross Christie como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Garvis Snook como director

    2 páginasTM01

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    1 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    21 páginas410(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante 53

    10 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante 50

    13 páginas466(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante 51

    16 páginas466(Scot)

    legacy

    14 páginas410(Scot)

    Alteraciones a la garantía flotante 52

    10 páginas466(Scot)

    legacy

    8 páginas410(Scot)

    legacy

    13 páginas410(Scot)

    Resoluciones

    Resolutions
    25 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    1 páginas288c

    ¿Quiénes son los directivos de ROK ESTATES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    AL-KORDI, Sandra Joan
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Secretario
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    150343640001
    LEICESTER, John William
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    Secretario
    35 Newton Road
    GU14 8BN Farnborough
    Hampshire
    British1011450001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Secretario
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    British5814050002
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Secretario
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    British80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    Secretario
    The Knoll
    Marsh Green
    EX5 2ES Exeter
    Devon
    English11548360002
    WHITEHEAD, John
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    Secretario
    4 Prospect Terrace
    HG5 0HR Knaresborough
    North Yorkshire
    British546830001
    BAILEY, Michael William John
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    Director
    1 Biddington Way
    EX14 2GU Honiton
    Devon
    British104839850001
    BRYAN, Richard Hugh
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    Director
    Abbey Place
    Virginia Water
    Surrey
    British1011430001
    CHRISTIE, Ross Arneil
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    Director
    Whichway House 149 Marine Drive
    Rottingdean
    BN2 7GU Brighton
    East Sussex
    EnglandBritish106468680002
    CRAIG, Brian Archibald
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    Director
    The Round House
    High Oak Road
    SG12 7PR Ware
    Hertfordshire
    United KingdomBritish71144000001
    GIDNEY, David Guy
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    Director
    Border Hill House
    Dippenhall
    GU10 5DU Farnham
    Surrey
    British63635850001
    GLOVER, Edward Douglas
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    Director
    69 Elmfield Road
    SW17 8AD London
    United KingdomBritish121380002
    HOLE, Nicholas Ian
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    Director
    Beech Trees Lane
    TQ12 5TW Ipplepen
    Windmill Brake
    Devon
    United KingdomBritish128347270001
    JORDAN, Rodney Beeching
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    Director
    Bucehayes Farm
    Cotleigh
    EX14 9JA Honiton
    Devon
    British76263960001
    KAY, Mark Russell
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    Director
    Mamhead Court
    Mamhead
    EX6 8HX Exeter
    British1472550001
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    Director
    Maritime House Hook Park Road
    Warsash
    SO31 9HA Southampton
    Hampshire
    British5814050002
    MACDONALD, Robin Alisdair Stuart
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    Director
    Crofts End
    1 Cloister Way
    CV32 6QE Leamington Spa
    Warwickshire
    British5814050001
    MACKEY, Paul Emmanuel
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Director
    59 Geffers Ride
    Burley Wood
    SL5 7JZ Ascot
    Berkshire
    Irish11264820004
    MALLINSON, David John
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    Director
    Whistlers Canada Road
    West Wellow
    SO51 6DD Romsey
    Hampshire
    British24343760001
    REARDON, David James
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    Director
    Slights Cottage Ings Lane
    East Cottingwith
    YO4 4TW York
    British50574050001
    SNOOK, Garvis David
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    Director
    Sloane Gardens
    SW1W 8EB London
    13
    EnglandBritish70647210004
    TEMPEST, Philip Anthony
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    Director
    Oaks Ridge House 53a Oaks Road
    Great Glen
    LE8 9EG Leicester
    British36898820003
    TITHERIDGE, Timothy John
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    Director
    16 Court Royal Mews
    SO15 2TU Southampton
    Hampshire
    British80101260001
    TURNBULL, Julian Patrick
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    Director
    St Vincent St
    G2 5NJ Glasgow
    151
    EnglandEnglish11548360002

    ¿Tiene ROK ESTATES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture and guarantee
    Creado el 11 mar 2009
    Entregado el 31 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Temple Trustees Limited
    Transacciones
    • 31 mar 2009Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 31 mar 2009Registro de un cargo (410)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 11 mar 2009
    Entregado el 28 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Temple Trustees Limited
    Transacciones
    • 28 mar 2009Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 28 mar 2009Registro de un cargo (410)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Debenture and guarantee
    Creado el 11 mar 2009
    Entregado el 26 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 mar 2009Registro de un cargo (410)
    • 31 mar 2009Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 11 mar 2009
    Entregado el 26 mar 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 mar 2009Registro de un cargo (410)
    • 31 mar 2009Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Third party legal charge
    Creado el 06 ene 2003
    Entregado el 22 ene 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal mortgage over plot 4400, solent business park, fareham, hampshire; fixed charge over assets.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 22 ene 2003Registro de un cargo (410)
    • 08 oct 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Charge over shares
    Creado el 20 jun 1997
    Entregado el 27 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The shares.
    Personas con derecho
    • Mckay Securities PLC
    Transacciones
    • 27 jun 1997Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Charge over shares
    Creado el 20 jun 1997
    Entregado el 27 jun 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All shares.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transacciones
    • 27 jun 1997Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of assignment
    Creado el 13 dic 1996
    Entregado el 30 dic 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Rights,title and interest to one third of the entitlement.
    Personas con derecho
    • Eastern Rivers Limited
    Transacciones
    • 30 dic 1996Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 04 dic 1995
    Entregado el 12 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5 carlton crescent, southampton, registered under title number hp 101992, together with all covenants and rights, plant, machinery etc., and goodwill in relation to that property.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 12 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 11 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 16 ago 1995
    Entregado el 31 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    First legal mortgage on plot 300, ancells business park, fleet, hampshire, registered under title number hp 321407, assignment of the benefit of all leases on that property, and first fixed charges on goodwill and any vat relating to the property.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transacciones
    • 31 ago 1995Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 21 jul 1995
    Entregado el 04 ago 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 ago 1995Registro de un cargo (410)
    • 10 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of assignment and charge
    Creado el 23 may 1995
    Entregado el 12 jun 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Plot 300, ancells business park, fleet, hampshire...... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transacciones
    • 12 jun 1995Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 21 mar 1995
    Entregado el 10 abr 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1) legal mortgage on the sun inn, town quay, southampton, registered under title number HP454183 2) assignment of security on all present and future derivative leases 3) fixed charge on goodwill 4) fixed charge on rights in any monies representing repayment by custon & excise of vat.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co Limited
    Transacciones
    • 10 abr 1995Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Charge
    Creado el 30 ene 1995
    Entregado el 16 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    See continuation sheet no.2 On c/hse microfiche.
    Personas con derecho
    • Henry Ansbacher & Co. Limited
    Transacciones
    • 16 feb 1995Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 26 ene 1995
    Entregado el 15 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    See scheldule 2 on c/hse microfiche.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Charterhouse Property Investments Limited
    Transacciones
    • 15 feb 1995Registro de un cargo (410)
    • 15 jul 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 10 feb 1994
    Entregado el 16 feb 1994
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5 carlton crescent, southampton and registered at H.M. land registry HP101992.
    Personas con derecho
    • Clerical Medical and General Life Assurance Society
    Transacciones
    • 16 feb 1994Registro de un cargo (410)
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 13 ene 1992
    Entregado el 24 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5 carlton crescent southampton,hp 101992.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 ene 1992Registro de una carga
    • 08 mar 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 09 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 22 abr 1991
    Entregado el 30 abr 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Unit 2 haywards business centre new lane havant hampshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 1991Registro de una carga
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 28 mar 1990
    Entregado el 04 abr 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Freehold property known as or being land having frontage to brunel road and telford road, salisbury, wiltshire comprising of 2.6 acres.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 04 abr 1990Registro de una carga
    Mortgage deed
    Creado el 08 sept 1989
    Entregado el 25 sept 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £300,000
    Breve descripción
    5 carlton crescent southampton hampshire.
    Personas con derecho
    • Alliance & Leicester Building Society
    Transacciones
    • 25 sept 1989Registro de una carga
    • 11 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 03 abr 1989
    Entregado el 06 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Freehold property west side of castle way southampton hampshire title no hp 293934.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 abr 1989Registro de una carga
    First legal charge
    Creado el 21 feb 1989
    Entregado el 06 mar 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Aerogan works, newmans lane, alton in hampshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 mar 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 31 ene 1989
    Entregado el 06 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    385 wimbourne rd., Winton, bournemouth.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 feb 1989Registro de una carga
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 11 ene 1989
    Entregado el 16 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5 carlton crescent, southampton, hampshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 ene 1989Registro de una carga
    Legal charge
    Creado el 30 dic 1988
    Entregado el 13 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Piece of land on north side of the hundred ramsey, hampshire plus shop at 28 the hundred ramsey.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1989Registro de una carga
    • 04 mar 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0