COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC015051 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
- Otros alojamientos (55900) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Ten George Street EH2 2DZ Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2013 |
¿Cuál es el estado de la última declaración anual para COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
| Declaración anual |
|
|---|
¿Cuáles son las últimas presentaciones para COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria | 7 páginas | 4.26(Scot) | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH | 2 páginas | AD02 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH a Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ el 25 ago 2015 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr James Owen Percival como director el 16 mar 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Oded Lifschitz como director el 16 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Robert Vincent como director el 16 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Oded Lifschitz el 24 jun 2014 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Mark Jonathan Way como director el 29 ago 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Rabin como director el 13 jun 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr. Stuart Beasley como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 may 2013 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de Oded Lifschitz como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Rogers como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 may 2012 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
Nombramiento de John Rogers como director | 3 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Philip como director | 2 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 may 2011 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLT SECRETARY LIMITED | Secretario corporativo | Maple Court Central Park, Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 125128960001 | |||||||
| BEASLEY, Stuart | Director | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 188237620001 | |||||
| PERCIVAL, James Owen | Director | Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Hertfordshire England | United Kingdom | British | 161274380001 | |||||
| HUGHES, Barbara | Secretario | Flat 3 11 Hazelmere Road NW6 6PY London | British | 45702460001 | ||||||
| LANG, Anthony | Secretario | 58 West Regent Street G2 2QZ Glasgow Lanarkshire | British | 557550001 | ||||||
| MACKAY, William Donald | Secretario | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MITCHELL, Andrew Ross | Secretario | Highwood PA13 4TA Kilmacolm Refrewshire | British | 25359180002 | ||||||
| WATSON, David John | Secretario | Clochranhill House Clochranhill Road KA7 4QE Alloway Ayrshire | British | 113082000001 | ||||||
| WILSON, Brian | Secretario | Tudor Cottage 70 High Street, Eaton Bray LU6 2DP Dunstable | British | 125151140001 | ||||||
| LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED | Secretario corporativo | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | 60530770001 | |||||||
| BRADLEY, Adrian Paul | Director | The Spinney Misbourne Avenue SL9 0PF Chalfont St Peter Buckinghamshire | United Kingdom | British | 90379240002 | |||||
| BUSBY, James George William | Director | 38 Cormorant Avenue Houston PA6 7LW Johnstone Renfrewshire | British | 584980001 | ||||||
| CHISMAN, Ronald Neil | Director | 1 Beaufort Close SW15 3TL London | United Kingdom | British | 780950001 | |||||
| FRIEDMAN, Howard | Director | Maple Court Central Park Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Hertfordshire | Usa | 106914780001 | ||||||
| GOSLING, Peter Charles | Director | 95 Worcester Road SM2 6QL Cheam Surrey | England | English | 142633640001 | |||||
| HARRIS, Anthony Richard | Director | 43 Alma Square NW8 9PY London | British | 64357620006 | ||||||
| HARVEY, Paul Victor | Director | Flat 2, The Cotton Mill 35 King Street LE1 6RN Leicester Leicestershire | British | 116809270001 | ||||||
| HEARN, Grant David | Director | Bishops Platt Norlands Lane TW20 8SS Thorpe Surrey | United Kingdom | British | 88628480001 | |||||
| HUGHES-RIXHAM, Ian | Director | 1 Grange Road HP23 5JP Tring Hertfordshire | British | 143730250001 | ||||||
| LICHMAN, Laurence | Director | 209 Merry Hill Road WD23 1AP Bushey Hertfordshire | British | 143730380001 | ||||||
| LIFSCHITZ, Oded | Director | NW8 9RF London Flat 52, The Yoo Building England England | United Kingdom | Australian / Israeli | 172992020002 | |||||
| LYLE, Gordon William | Director | Aragorn House Stylecroft Road HP8 4HZ Chalfont St. Giles Buckinghamshire | England | British | 143730330001 | |||||
| MACKAY, William Donald | Director | 79 Tweedsmuir Road G52 2RX Glasgow | British | 796730001 | ||||||
| MICHELS, David Michael Charles | Director | 15 Court Drive HA7 4QH Stanmore Middlesex | British | 4855250001 | ||||||
| NEUMANN, Wolfgang | Director | Flat 4, 34 Holland Park W11 3TA London | Austria | 87699600002 | ||||||
| PHILIP, John Crosbie | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire | England | British | 102495550001 | |||||
| RABIN, Elizabeth Jane | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire | England | British | 125139540001 | |||||
| ROGERS, John | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire England | England | British | 162807030001 | |||||
| SHILL, Rosemarie | Director | The Old School House High Street B95 5BN Henley In Arden Warwickshire | United Kingdom | British | 89948030001 | |||||
| STAKIS, Andros | Director | Glentyan House Glentyan Estate PA10 7JJ Kilbarchan Renfrewshire | British | 27237990001 | ||||||
| STAKIS, Reo, Sir | Director | 54 Aytoun Road Pollokshields G41 5HE Glasgow Lanarkshire | British | 69301420001 | ||||||
| TALJAARD, Desmond Louis Mildmay | Director | 59 Crescent West EN4 0EQ Hadley Wood Hertfordshire | United Kingdom | British | 215884620001 | |||||
| TAYLOR, Hugh Matthew | Director | 5 Amberden Avenue N3 3BJ London | United Kingdom | British | 127621330001 | |||||
| VINCENT, Simon Robert | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire | England | British | 102638930001 | |||||
| WAY, Mark Jonathan | Director | Reeds Crescent WD24 4QQ Watford Maple Court Central Park Hertfordshire | United Kingdom | British | 191239860001 |
¿Tiene COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 14 ago 1991 Entregado el 03 sept 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 14 ago 1991 Entregado el 03 sept 1991 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0