COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED

COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCOYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC015051
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    • Otros alojamientos (55900) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida

    ¿Dónde se encuentra COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Ten
    George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2013

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    7 páginas4.26(Scot)

    La dirección de inspección del registro se ha cambiado a 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH

    2 páginasAD02

    Domicilio social registrado cambiado de 4 Cadogan Square Cadogan Street Glasgow G2 7PH a Ten George Street Edinburgh EH2 2DZ el 25 ago 2015

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 13 ago 2015

    LRESSP

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital06 may 2015

    Estado de capital el 06 may 2015

    • Capital: GBP 8,810
    SH01

    Nombramiento de Mr James Owen Percival como director el 16 mar 2015

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Oded Lifschitz como director el 16 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Simon Robert Vincent como director el 16 mar 2015

    1 páginasTM01

    Cambio de datos del director Oded Lifschitz el 24 jun 2014

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Mark Jonathan Way como director el 29 ago 2014

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2013

    8 páginasAA

    Cese del nombramiento de Elizabeth Jane Rabin como director el 13 jun 2014

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr. Stuart Beasley como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital03 may 2014

    Estado de capital el 03 may 2014

    • Capital: GBP 8,810
    SH01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de Oded Lifschitz como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Rogers como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2011

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    Nombramiento de John Rogers como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Philip como director

    2 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 may 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    HLT SECRETARY LIMITED
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Maple Court
    Central Park, Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    125128960001
    BEASLEY, Stuart
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish188237620001
    PERCIVAL, James Owen
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    Director
    Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish161274380001
    HUGHES, Barbara
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    Secretario
    Flat 3
    11 Hazelmere Road
    NW6 6PY London
    British45702460001
    LANG, Anthony
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    58 West Regent Street
    G2 2QZ Glasgow
    Lanarkshire
    British557550001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Secretario
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MITCHELL, Andrew Ross
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    Secretario
    Highwood
    PA13 4TA Kilmacolm
    Refrewshire
    British25359180002
    WATSON, David John
    Clochranhill House
    Clochranhill Road
    KA7 4QE Alloway
    Ayrshire
    Secretario
    Clochranhill House
    Clochranhill Road
    KA7 4QE Alloway
    Ayrshire
    British113082000001
    WILSON, Brian
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    Secretario
    Tudor Cottage
    70 High Street, Eaton Bray
    LU6 2DP Dunstable
    British125151140001
    LADBROKE CORPORATE SECRETARIES LIMITED
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Secretario corporativo
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    60530770001
    BRADLEY, Adrian Paul
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    The Spinney
    Misbourne Avenue
    SL9 0PF Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish90379240002
    BUSBY, James George William
    38 Cormorant Avenue
    Houston
    PA6 7LW Johnstone
    Renfrewshire
    Director
    38 Cormorant Avenue
    Houston
    PA6 7LW Johnstone
    Renfrewshire
    British584980001
    CHISMAN, Ronald Neil
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    Director
    1 Beaufort Close
    SW15 3TL London
    United KingdomBritish780950001
    FRIEDMAN, Howard
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Director
    Maple Court Central Park
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Hertfordshire
    Usa106914780001
    GOSLING, Peter Charles
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    Director
    95 Worcester Road
    SM2 6QL Cheam
    Surrey
    EnglandEnglish142633640001
    HARRIS, Anthony Richard
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    Director
    43 Alma Square
    NW8 9PY London
    British64357620006
    HARVEY, Paul Victor
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    Director
    Flat 2, The Cotton Mill
    35 King Street
    LE1 6RN Leicester
    Leicestershire
    British116809270001
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Director
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritish88628480001
    HUGHES-RIXHAM, Ian
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    Director
    1 Grange Road
    HP23 5JP Tring
    Hertfordshire
    British143730250001
    LICHMAN, Laurence
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    Director
    209 Merry Hill Road
    WD23 1AP Bushey
    Hertfordshire
    British143730380001
    LIFSCHITZ, Oded
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    Director
    NW8 9RF London
    Flat 52, The Yoo Building
    England
    England
    United KingdomAustralian / Israeli172992020002
    LYLE, Gordon William
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    Director
    Aragorn House
    Stylecroft Road
    HP8 4HZ Chalfont St. Giles
    Buckinghamshire
    EnglandBritish143730330001
    MACKAY, William Donald
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    Director
    79 Tweedsmuir Road
    G52 2RX Glasgow
    British796730001
    MICHELS, David Michael Charles
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    Director
    15 Court Drive
    HA7 4QH Stanmore
    Middlesex
    British4855250001
    NEUMANN, Wolfgang
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Director
    Flat 4, 34 Holland Park
    W11 3TA London
    Austria87699600002
    PHILIP, John Crosbie
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    EnglandBritish102495550001
    RABIN, Elizabeth Jane
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    EnglandBritish125139540001
    ROGERS, John
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish162807030001
    SHILL, Rosemarie
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    Director
    The Old School House
    High Street
    B95 5BN Henley In Arden
    Warwickshire
    United KingdomBritish89948030001
    STAKIS, Andros
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    Director
    Glentyan House
    Glentyan Estate
    PA10 7JJ Kilbarchan
    Renfrewshire
    British27237990001
    STAKIS, Reo, Sir
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    54 Aytoun Road
    Pollokshields
    G41 5HE Glasgow
    Lanarkshire
    British69301420001
    TALJAARD, Desmond Louis Mildmay
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    Director
    59 Crescent West
    EN4 0EQ Hadley Wood
    Hertfordshire
    United KingdomBritish215884620001
    TAYLOR, Hugh Matthew
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    Director
    5 Amberden Avenue
    N3 3BJ London
    United KingdomBritish127621330001
    VINCENT, Simon Robert
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    EnglandBritish102638930001
    WAY, Mark Jonathan
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    Director
    Reeds Crescent
    WD24 4QQ Watford
    Maple Court Central Park
    Hertfordshire
    United KingdomBritish191239860001

    ¿Tiene COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 14 ago 1991
    Entregado el 03 sept 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Stakis Public Limited Company
    Transacciones
    • 03 sept 1991Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 14 ago 1991
    Entregado el 03 sept 1991
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 03 sept 1991Registro de un cargo (410)
    • 19 ene 1996Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (419b)

    ¿Tiene COYLUMBRIDGE HIGHLAND LODGES (MANAGEMENT) LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    13 ago 2015Inicio de la liquidación
    23 sept 2016Fecha prevista de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0