JOHNSTON PRESS PLC

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaJOHNSTON PRESS PLC
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad anónima cotizada
    Número de empresa SC015382
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de JOHNSTON PRESS PLC?

    • Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra JOHNSTON PRESS PLC?

    Dirección de la sede social
    272 Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de JOHNSTON PRESS PLC?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    F. JOHNSTON & COMPANY LIMITED31 dic 192831 dic 1928

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHNSTON PRESS PLC?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 dic 2017

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHNSTON PRESS PLC?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en una liquidación por orden judicial

    19 páginasWU15(Scot)

    Orden judicial en una liquidación (y adjunto de la orden judicial)

    6 páginasWU01(Scot)

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    2 páginasOC-DV

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cambio de administración a disolución

    34 páginasAM23(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    33 páginasAM10(Scot)

    Aviso de extensión del período de administración

    5 páginasAM19(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    35 páginasAM10(Scot)

    Cese del nombramiento de Peter Mccall como secretario el 17 may 2019

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de David John King como director el 17 may 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Kjell Aamot como director el 01 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de William James Buchan como director el 19 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Michael Guy Butterworth como director el 19 feb 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Camilla Alexandra Rhodes como director el 09 ene 2019

    1 páginasTM01

    Declaración de la propuesta considerada del administrador

    1 páginas2.16BZ(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR el 06 dic 2018

    2 páginasAD01

    Declaración de la propuesta del administrador

    119 páginas2.16B(Scot)

    Declaración de asuntos con el formulario 2.13B(Scot)

    12 páginas2.15B(Scot)

    Nombramiento de un administrador

    2 páginas2.11B(Scot)

    Cancelación total de la carga 7

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 9

    4 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 8

    4 páginasMR04

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Genera meeting of company called not less 14 clear days notice 05/06/2018
    RES13

    ¿Quiénes son los directivos de JOHNSTON PRESS PLC?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Secretario
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    British474360001
    COOPER, Philip Richard
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    Secretario
    Grange Knowe
    EH49 7HX Linlithgow
    14
    West Lothian
    United Kingdom
    British131295290001
    MCCALL, Peter
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Secretario
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    146630180001
    AAMOT, Kjell
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    NorwayNorwegian153114510002
    BELL, Iain William
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    Director
    Balhernoch
    507 Lanark Road West
    EH14 7AJ Balerno
    Midlothian
    British35563110001
    BOWDLER, Timothy John
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    Director
    2-11 St Vincent Place
    EH3 5BQ Edinburgh
    United KingdomBritish37521870002
    BUCHAN, William James
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    Director
    Bath Street
    G2 4JR Glasgow
    272
    EnglandBritish232628330001
    BUTTERWORTH, Michael Guy
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish76600500002
    CAMMIADE, Danny
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    Director
    Crathorne 4 Grange Park
    Ferring
    BN12 5LS Worthing
    West Sussex
    EnglandBritish251394160001
    CAWDRON, Peter Edward Blackburn
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    Director
    The Old Bakery
    Rectory Road
    OX44 7JG Great Haseley
    Oxfordshire
    EnglandBritish166325310001
    CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    Director
    21 Braid Farm Road
    EH10 6LE Edinburgh
    ScotlandBritish474360001
    DICKSON, Ian
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    Director designado
    Enderley 19 Baldernock Road
    Milngavie
    G62 8DU Glasgow
    ScotlandBritish900000230001
    DUNN, Hugh John Ramsay
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    Director
    Yate House
    Oxenhope
    BD22 9HL Keighley
    W Yorks
    British328340001
    FRY, John Anthony
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    Director
    Church Hill
    NR15 1TD Saxlingham Nethergate
    Old Rectory
    Norfolk
    Uk
    EnglandBritish136914890001
    HALE, Matthew Joseph Hovey
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    Director
    Stortford Little Drove
    Little Drove
    BN44 3PP Steyning
    West Sussex
    British7129870001
    HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish164400440001
    HINTON, Leslie Frank
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    Director
    1 Virginia Street
    E98 1XY London
    British104267650003
    IDDISON, Geoff
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    United Kingdom
    United KingdomBritish148074460002
    JOHNSTON, Frederick Patrick Mair
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    Director
    39 Broad Street
    SY8 1NL Ludlow
    Shropshire
    British328390002
    JOHNSTON, Henry Charles Marriott
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    Director
    Invereil House
    By Dirleton
    EH39 5DH North Berwick
    East Lothian
    British474380004
    KING, David John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish179020430001
    KING, Martina Ann
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    Director
    71 Victoria Street
    SW1H 0XA London
    British107699510001
    MARSHALL, Augustus Ralph
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    Director
    Impian Bukit Tunku
    No. 8 Jalan Tunku
    Kuala Lumpur
    Unit 17
    50480
    Malaysia
    MalaysiaMalaysian16432070011
    MERRILLS, Austin
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    Director
    The East Wing
    Tyninghame House
    EH42 1XW Dunbar
    East Lothian
    British529310002
    MURRAY, Grant
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    Director
    Holyrood Road
    EH8 8AS Edinburgh
    108
    Scotland
    United KingdomBritish159877110001
    PAIN, Mark Andrew
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    United KingdomBritish122498680001
    PARRY, Roger George
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    Director
    27 Edwardes Square
    W8 6HH London
    United KingdomBritish41614380002
    PATERSON, Stuart Randall
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    41 Fernielaw Avenue
    EH13 0EF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish64281400001
    PATTERSON, Gavin Echlin
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    Director
    Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Bt Centre 81
    British131233950001
    RHODES, Camilla Alexandra
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    British139644420001
    ROCHE, Henry John, Sir
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    Director
    242 Shakespeare Tower
    Barbican
    EC2Y 8DR London
    British53613320001
    RUDD-JONES, Nicholas
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    Director
    20 Saint Georges Square
    PE9 2BN Stamford
    Lincolnshire
    British77152150002
    RUSSELL, Ian Simon Macgregor
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    Director
    73 Braid Avenue
    EH10 6ED Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish38783050003
    THE LORD GORDON OF STRATHBLANE
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    Director
    Deil's Craig
    Old Mugdock Road,Strathblane
    G63 9ET Glasgow
    British312680002
    VAN ROOYEN, Stephen John
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    Director
    Orchard Brae House, 30 Queensferry Road
    EH4 2HS Edinburgh
    8th Floor
    Scotland
    EnglandBritish178722710001

    ¿Tiene JOHNSTON PRESS PLC alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 23 jun 2014
    Entregado el 04 jul 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 04 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 23 jun 2014
    Entregado el 04 jul 2014
    Pendiente
    Breve descripción
    The extent that title to the real property in northern ireland freehold tenure see form for further details.
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag
    Transacciones
    • 04 jul 2014Registro de una carga (MR01)
    A registered charge
    Creado el 16 jun 2014
    Entregado el 24 jun 2014
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Deutsche Bank Ag, London Branch for Itself and as Security Agent
    Transacciones
    • 24 jun 2014Registro de una carga (MR01)
    Security agreement
    Creado el 25 sept 2009
    Entregado el 06 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 2009Registro de un cargo (MG01s)
    • 10 may 2012Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 12 oct 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 28 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Supplemantal legal mortgage
    Creado el 25 sept 2009
    Entregado el 06 oct 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Kings road, bury st edmonds, suffolk P212269 SK200901; 10/11 union street, wisbech, cambridgeshire; 46 high street, grantham, lincolnshire LL85306; oundle road, woodston ind est, peterborough CB233925.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 06 oct 2009Registro de un cargo (MG01s)
    • 28 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    Security agreement
    Creado el 28 ago 2009
    Entregado el 15 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 15 sept 2009Registro de un cargo (410)
    • 10 may 2012Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 12 oct 2013Parte del bien o empresa ha sido liberada de la carga (MR05)
    • 28 ago 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Deposit agreement and cash deposit pledge
    Creado el 09 ago 2005
    Entregado el 23 ago 2005
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under or in connection with clause 5.2.2. under the credit agreement
    Breve descripción
    The company pledges and assigns the deposit account and the deposit and all the present and future rights, titles and benefit of the company in the deposit account and the deposit.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 ago 2005Registro de un cargo (410)
    • 27 jun 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 12 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (410)
    • 26 mar 2004Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 12 sept 2005Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 25 jun 1999
    Entregado el 06 jul 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 jul 1999Registro de un cargo (410)
    • 27 jun 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 01 jul 1996
    Entregado el 19 jul 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself and as Trustee for Others
    Transacciones
    • 19 jul 1996Registro de un cargo (410)
    • 08 oct 1999Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 18 oct 1978
    Entregado el 26 oct 1978
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 26 oct 1978Registro de una carga
    • 11 dic 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene JOHNSTON PRESS PLC algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    17 nov 2018Inicio de la administración
    15 jun 2020Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Catherine Williamson
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Profesional
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Peter Mark Saville
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Simon Jonathan Appell
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    2
    FechaTipo
    09 mar 2023Conclusión de la liquidación
    19 may 2021Fecha de la petición
    11 jul 2023Fecha prevista de disolución
    19 may 2021Inicio de la liquidación
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Catherine Williamson
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Profesional
    Ship Canal House 8th Floor 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Alastair Paul Beveridge
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Profesional
    6 New Street Square
    EC4A 3BF London
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0