HANOVER FOUR LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaHANOVER FOUR LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC015674
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de HANOVER FOUR LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra HANOVER FOUR LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de HANOVER FOUR LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    THOMSON BROTHERS LTD.06 jun 199406 jun 1994
    THOMSON BROTHERS (KIRKCALDY) LIMITED16 ago 192916 ago 1929

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de HANOVER FOUR LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para HANOVER FOUR LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Nombramiento de Mr Simon Terence Douglas como director el 14 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Hedley Bowcock como director el 14 nov 2011

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ago 2011

    Estado de capital el 15 ago 2011

    • Capital: GBP 21,412
    SH01

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Philip Hedley Bowcock como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jayne Fearn como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 25 feb 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Marks como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Luminar Leisure Limited como director

    2 páginasAP02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2009

    8 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 28 feb 2008

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 01 mar 2007

    7 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 02 mar 2006

    7 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de HANOVER FOUR LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158739440001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Director corporativo
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03802937
    152179970001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Secretario
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Secretario
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Director
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Director
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Director
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    COOK, John
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    Director
    55 Linefield Road
    DD7 6DT Carnoustie
    Angus
    ScotlandBritish1388150003
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Director
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    GARVIE, David Campbell
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    Director
    Craighill
    18 Murray Place
    PH1 1BP Perth
    Perthshire
    British4668490001
    GUTTERIDGE, Timothy Roy
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    Director
    38 Northumberland Street
    EH3 6JA Edinburgh
    Scotland
    British6050070003
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    JUDGE, Michael
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    Director
    12 Alexander Street
    KY4 9AA Cowdenbeath
    Fife
    British653260001
    LIVINGSTONE, Peter Wishart
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    Director
    12 Normand Road
    Dysart
    KY1 2XJ Kirkcaldy
    Fife
    British110527270001
    MACLEOD, Brian
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    Director
    18 Scobie Place
    KY12 7RX Dunfermline
    Fife
    British43111330001
    MALCOLM, Alexander Ramsay
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    Director
    2 Talla Park
    KY13 8AB Kinross
    Fife
    ScotlandBritish66254130001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Director
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MILLS, Adam Francis
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    Director
    The Walton Canonry
    69 The Close
    SP1 2EN Salisbury
    Wiltshire
    British4058810004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    PRENTICE, William
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    Director
    88 Dunnikier Road
    KY2 5AW Kirkcaldy
    Fife
    British653270001
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Director
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Director
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Director
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    ¿Tiene HANOVER FOUR LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 07 feb 1995
    Entregado el 23 feb 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 feb 1995Registro de un cargo (410)
    • 06 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of offset
    Creado el 16 ago 1982
    Entregado el 31 ago 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by t s forster & sons LTD
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ago 1982Registro de una carga
    • 06 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of offset
    Creado el 19 mar 1982
    Entregado el 06 abr 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due, or to become due by park naval engineering LTD
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 06 abr 1982Registro de una carga
    • 06 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of offset
    Creado el 09 feb 1981
    Entregado el 13 feb 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by robt. Balbirnie & company LTD and/or another
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in the name of the company.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 13 feb 1981Registro de una carga
    • 06 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Letter of offset
    Creado el 13 mar 1979
    Entregado el 22 mar 1979
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by fife forester LTD and/or others
    Breve descripción
    All sums which are now or which may at any time be at credit of any accounts held by bank of scotland in name of thomson brothers (kirkcaldy) LTD.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 mar 1979Registro de una carga
    • 06 jul 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0