THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE

THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaTHE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC016190
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenesNo
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    • Otras investigaciones y desarrollo experimental en ciencias naturales e ingeniería (72190) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Dirección de la sede social
    The Macaulay Land Use Research Institute
    Craigiebuckler
    AB15 8QH Aberdeen
    Aberdeenshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    MACAULAY INSTITUTE FOR SOIL RESEARCH (THE)05 nov 193005 nov 1930

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2015

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2015

    7 páginasAA

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2015, aucune liste de membres fournie

    4 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Julia Mary Brown como director el 21 ene 2015

    1 páginasTM01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2014

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2014, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2013

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2013, aucune liste de membres fournie

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de D.W. Company Services Limited como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2012

    30 páginasAA

    Nombramiento de D.W. Company Services Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cambio de datos del director Professor Alan Werritty el 29 ago 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mrs Julia Mary Brown el 29 ago 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Professor Brian Drummond Clark el 29 ago 2012

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Karen Shaw como secretario

    1 páginasTM02

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2012, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2011

    34 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 04 jul 2011, aucune liste de membres fournie

    6 páginasAR01

    Nombramiento de Dr Karen Shaw como secretario

    2 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Carol Bisset como secretario

    1 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Franceska Van Dijk como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de George Paterson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Robert Kay como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de THE MACAULAY LAND USE RESEARCH INSTITUTE?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    CLARK, Brian Drummond, Professor
    Craigiebuckler
    AB15 8QH Aberdeen
    The Macaulay Land Use Research Institute
    Aberdeenshire
    Scotland
    Director
    Craigiebuckler
    AB15 8QH Aberdeen
    The Macaulay Land Use Research Institute
    Aberdeenshire
    Scotland
    United KingdomBritish152018580001
    MEAGHER, Laura Reinertsen, Dr
    Edengrove House
    KY15 4RP Dairsie
    Fife
    Director
    Edengrove House
    KY15 4RP Dairsie
    Fife
    ScotlandUk/Us104736220001
    WERRITTY, Alan, Professor
    University Of Dundee
    DD1 4HN Dundee
    School Of Social And Environmental Sciences
    United Kingdom
    Director
    University Of Dundee
    DD1 4HN Dundee
    School Of Social And Environmental Sciences
    United Kingdom
    UkBritish87197750001
    BISSET, Carol Anne
    30 Barclay Park
    AB34 5JF Aboyne
    Aberdeenshire
    Secretario
    30 Barclay Park
    AB34 5JF Aboyne
    Aberdeenshire
    British115775980001
    DEVINE, Robert Buchanan
    9 Fare Park Drive
    Westhill
    AB32 6WE Skene
    Aberdeenshire
    Secretario
    9 Fare Park Drive
    Westhill
    AB32 6WE Skene
    Aberdeenshire
    British3206180001
    MURDOCH, David William
    95 Macaulay Drive
    Craigiebuckler
    AB15 8FL Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    95 Macaulay Drive
    Craigiebuckler
    AB15 8FL Aberdeen
    Aberdeenshire
    British51752580002
    PIGGOTT, Elizabeth Ann
    19 Braehead Terrace
    Milltimber
    AB1 0EB Aberdeen
    Aberdeenshire
    Secretario
    19 Braehead Terrace
    Milltimber
    AB1 0EB Aberdeen
    Aberdeenshire
    British572700001
    SHAW, Karen, Dr
    Invergowrie
    DD2 5DA Dundee
    The James Hutton Institute
    United Kingdom
    Secretario
    Invergowrie
    DD2 5DA Dundee
    The James Hutton Institute
    United Kingdom
    159606110001
    WALLS, Andrew Peter Lindsay
    6 Mcnabb Street
    FK14 7DJ Dollar
    Clacks
    Secretario
    6 Mcnabb Street
    FK14 7DJ Dollar
    Clacks
    British88805720001
    WATT, James Douglas
    43 Earlspark Drive
    Bieldside
    AB15 9AH Aberdeen
    Secretario
    43 Earlspark Drive
    Bieldside
    AB15 9AH Aberdeen
    British96844050002
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    Floor
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    4th
    Lothian
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Floor
    Saltire Court 20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    4th
    Lothian
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registroSC079179
    613080003
    ARMSTRONG, David Gilford
    44 North Road
    Ponteland
    NE20 9UR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Director
    44 North Road
    Ponteland
    NE20 9UR Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    British572710001
    BAIRD, Eric George Gunning
    Glen Tanar
    AB34 5EU Aboyne
    Avon
    Aberdeenshire
    Director
    Glen Tanar
    AB34 5EU Aboyne
    Avon
    Aberdeenshire
    United KingdomBritish137972260001
    BATEMAN, David Ian
    29 Penygraig
    SY23 2JA Aberystwyth
    Dyfed
    Director
    29 Penygraig
    SY23 2JA Aberystwyth
    Dyfed
    WalesBritish572720001
    BOYD, Douglas Turner
    5 Laurel Avenue
    Lenzie
    G66 4RX Kirkintilloch
    Glasgow
    Director
    5 Laurel Avenue
    Lenzie
    G66 4RX Kirkintilloch
    Glasgow
    ScotlandBritish58832110001
    BROWN, Julia Mary
    Errol Road
    Invergowrie
    DD2 5DA Dundee
    The James Hutton Institute
    United Kingdom
    Director
    Errol Road
    Invergowrie
    DD2 5DA Dundee
    The James Hutton Institute
    United Kingdom
    ScotlandScottish65822270002
    BURGESS, Jacqueline Anne, Professor
    Kirby Road
    Trowse
    NR14 8QH Norwich
    36 Whitlingham Hall
    Norfolk
    Director
    Kirby Road
    Trowse
    NR14 8QH Norwich
    36 Whitlingham Hall
    Norfolk
    EnglandBritish133457340001
    BUTTLE, Eileen, Doctor
    Willows Farm
    Cleverton
    SN15 5BT Chippenham
    Wiltshire
    Director
    Willows Farm
    Cleverton
    SN15 5BT Chippenham
    Wiltshire
    British41306760001
    CAMERON, John Bell
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    Director
    Balbuthie
    KY9 1EX Leven
    Fife
    ScotlandBritish203550001
    CANNELL, Melvin Gilbert Richard, Professor
    Easter Greybield
    Edderston Road
    EH45 9JB Peebles
    Tweeddale
    Director
    Easter Greybield
    Edderston Road
    EH45 9JB Peebles
    Tweeddale
    British89129650001
    CARR, John Roger
    Bradbush
    Darnaway
    IV36 0SU Forres
    Morayshire
    Director
    Bradbush
    Darnaway
    IV36 0SU Forres
    Morayshire
    British316710001
    CHAMBERS, Shireen Grace
    4 Sunbury Place
    EH4 3BY Edinburgh
    Midlothian
    Director
    4 Sunbury Place
    EH4 3BY Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish118048040001
    CRAWFORD, James Ian Mckinlay
    Wester Kinloch
    PH10 6SG Blairgowrie
    Perthshire
    Director
    Wester Kinloch
    PH10 6SG Blairgowrie
    Perthshire
    British1144960001
    CRAWLEY, Mick John, Professor
    86a Upper Village Road
    SL5 7AQ Swinninghill
    Director
    86a Upper Village Road
    SL5 7AQ Swinninghill
    EnglandBritish174957950001
    CRESSER, Malcolm Stewart, Professor
    92 Bonnymuir Place
    AB15 5NP Aberdeen
    Grampian
    Director
    92 Bonnymuir Place
    AB15 5NP Aberdeen
    Grampian
    British59841030001
    CUNNINGHAM, John Mccandlish Murdoch
    Bruaich
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Lothian
    Peebleshire
    Director
    Bruaich
    Hazlieburn
    EH46 7AS West Lothian
    Peebleshire
    British38165290001
    CURRY, Nigel, Professor
    Overton Court
    Overton Park Road
    GL50 3BW Cheltenham
    Flat 17
    Gloucestershire
    England
    Director
    Overton Court
    Overton Park Road
    GL50 3BW Cheltenham
    Flat 17
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish85900200002
    DENNIS, Marina Theresa
    Inchdryne
    Inchdryne
    PH25 3EF Nethy Bridge
    Inverness-Shire
    Director
    Inchdryne
    Inchdryne
    PH25 3EF Nethy Bridge
    Inverness-Shire
    ScotlandBritish126938120001
    DENT, John Barry
    Pinelodge 11 Tipperlinn Road
    EH10 5ET Edinburgh
    Midlothian
    Director
    Pinelodge 11 Tipperlinn Road
    EH10 5ET Edinburgh
    Midlothian
    British65638790001
    DICKINSON, Helen Jane
    North Denmore
    Auchnagatt
    AB41 8TL Ellon
    Aberdeenshire
    Director
    North Denmore
    Auchnagatt
    AB41 8TL Ellon
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish114090000001
    DON, John Alexander Campbell, Justice Of The Peace (Jp)
    Freefield Farm
    Old Rayne
    AB52 6SY Insch
    Aberdeenshire
    Director
    Freefield Farm
    Old Rayne
    AB52 6SY Insch
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish17992360001
    EDWARDS, Victoria Mary, Dr
    Charcoal Cottage Silver Street
    SO43 7DX Emery Down
    Hampshire
    Director
    Charcoal Cottage Silver Street
    SO43 7DX Emery Down
    Hampshire
    United KingdomBritish141960060001
    GIBSON, Alexander John Michael
    Edinvale
    IV36 2RW Dallas
    Morayshire
    Director
    Edinvale
    IV36 2RW Dallas
    Morayshire
    ScotlandBritish1135760001
    GIMINGHAM, Charles Henry
    Glenderry 4 Gowanbrae Road
    Bieldside
    AB1 9AQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Glenderry 4 Gowanbrae Road
    Bieldside
    AB1 9AQ Aberdeen
    Aberdeenshire
    British296200002
    GOURLAY, John Francis Stewart
    Auchencheyne
    DG3 4EP Moniaive
    Dumfriesshire
    Director
    Auchencheyne
    DG3 4EP Moniaive
    Dumfriesshire
    British159580001

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0