CHARLES CARPENTER, LIMITED

CHARLES CARPENTER, LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaCHARLES CARPENTER, LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC018125
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de CHARLES CARPENTER, LIMITED?

    • (9999) /

    ¿Dónde se encuentra CHARLES CARPENTER, LIMITED?

    Dirección de la sede social
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de CHARLES CARPENTER, LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta25 feb 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para CHARLES CARPENTER, LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    2 páginasDS01

    Nombramiento de Mr Simon Terence Douglas como director el 14 nov 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Philip Hedley Bowcock como director el 14 nov 2011

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2011 avec liste complète des actionnaires

    3 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital15 ago 2011

    Estado de capital el 15 ago 2011

    • Capital: GBP 500,000
    SH01

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Philip Hedley Bowcock como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mrs Jayne Fearn como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Timothy O'gorman como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 25 feb 2010

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 13 ago 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de Andrew Marks como director

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Luminar Leisure Limited como director

    2 páginasAP02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 26 feb 2009

    7 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 28 feb 2008

    6 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 01 mar 2007

    6 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas preparadas hasta el 02 mar 2006

    8 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de CHARLES CARPENTER, LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FEARN, Jayne
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    158737690001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Director
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Director corporativo
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro03802937
    152179100001
    ARMSTRONG, Colin North
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    Secretario
    Barton End Priors Barton
    SO23 9QF Winchester
    Hampshire
    British172030620001
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Secretario
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Secretario
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    DACRE, Ronald Robert Hugh
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    Secretario
    21 Keirsbeath Court
    Kingseat
    KY12 0UE Dunfermline
    Fife
    British813060001
    KAUFMAN, Alan
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    Secretario
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    British3111940001
    MOIR, Margaret
    Tree Tops 106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    Tree Tops 106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Lanarkshire
    British897310002
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Secretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Secretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Secretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    STRIDE, Andrew William
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    Secretario
    6 Tilbury Road
    East Haddon
    NN6 8BX Northampton
    British62422770001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    The Ca'D'Oro
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    Lanarkshire
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Director
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BROWN, Kenneth George
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    Director
    12 Prestwick Place
    KY2 6LG Kirkcaldy
    Fife
    British1035280001
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Director
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Director
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    HEPBURN, Gavin Andrew Harley
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    Director
    22 Mansionhouse Road
    EH9 2JD Edinburgh
    Midlothian
    British211700001
    KAUFMAN, Alan
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    Director
    22 Daisy Hall Drive
    Westhoughton
    BL5 2SA Bolton
    Lancashire
    British3111940001
    MACDONALD, Donald Hugh
    78 East Bankton Place
    EH54 9BZ Livingston
    West Lothian
    Scotland
    Director
    78 East Bankton Place
    EH54 9BZ Livingston
    West Lothian
    Scotland
    British3111970001
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Director
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MCINTYRE, Robert
    5 Dickburn Crescent
    FK4 1DJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    Director
    5 Dickburn Crescent
    FK4 1DJ Bonnybridge
    Stirlingshire
    British897300001
    MCKENZIE, Douglas Charles
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    Director
    3 Doonholm Road
    Alloway
    KA7 4QQ Ayr
    Ayrshire
    British48853570001
    MOIR, David
    Cairnoch
    Coach Road
    Kilsyth
    Director
    Cairnoch
    Coach Road
    Kilsyth
    British29080002
    MOIR, John
    106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    Director
    106 Stirling Road
    Kilsyth
    G65 0HY Glasgow
    British36871270001
    MONK, John
    160 Fox Lane
    Leyland
    PR5 1HE Preston
    Lancashire
    England
    Director
    160 Fox Lane
    Leyland
    PR5 1HE Preston
    Lancashire
    England
    British3111930001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Director
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Director
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    RITCHIE, Alastair James
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    Director
    Mickry Lodge
    56 Gamekeepers Road
    EH4 6LS Edinburgh
    Lothian
    British38770080002
    ROBERTSON, John
    15 Avondale Place
    East Kilbride
    G74 1NU Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    15 Avondale Place
    East Kilbride
    G74 1NU Glasgow
    Lanarkshire
    British1373520001
    THOMAS, Stephen Charles
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    Director
    Newnham Hall
    Poets Way, Newnham
    NN11 3HQ Daventry
    Northamptonshire
    British66198390004
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Director
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002
    HANOVER THREE LIMITED
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    Director corporativo
    41 King Street
    LU1 2DW Luton
    Bedfordshire
    62089160004

    ¿Tiene CHARLES CARPENTER, LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 08 feb 1995
    Entregado el 23 feb 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 feb 1995Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 19 ene 1990
    Entregado el 07 feb 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £72,120
    Breve descripción
    Factory 15-23 telford rd lenziemill cumbernauld dmb 12979.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Cumbernauld Development Corporation
    Transacciones
    • 07 feb 1990Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 16 may 1985
    Entregado el 22 may 1985
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Factory premises with yard 15/23 telford rd cumbernauld.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 22 may 1985Registro de una carga
    • 26 oct 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 03 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond of cash credit and by the company floating charge
    Creado el 03 may 1963
    Entregado el 22 may 1963
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale & North of Scotland Bank LTD
    Transacciones
    • 22 may 1963Registro de una carga
    • 12 nov 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0