CARILLION (AMBS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CARILLION (AMBS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC020258 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CARILLION (AMBS) LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Atria One 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| ALFRED MCALPINE BUSINESS SERVICES LIMITED | 10 may 2004 | 10 may 2004 |
| MCALPINE BUSINESS SERVICES LIMITED | 07 oct 2003 | 07 oct 2003 |
| STIELL FACILITIES LIMITED | 02 jun 2000 | 02 jun 2000 |
| STIELL LIMITED | 16 oct 1996 | 16 oct 1996 |
| E.J. STIELL & COMPANY (ELECTRICAL ENGINEERS) LIMITED | 15 mar 1938 | 15 mar 1938 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2017 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2018 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jun 2018 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 06 jul 2018 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 22 jun 2017 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Alison Margaret Shepley como secretario el 03 jul 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como director el 04 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Westley Maffei como secretario el 04 jun 2018 | 1 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Emma Louise Mercer como director el 01 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Modification des détails de Carillion (Ambs) Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2018 | 2 páginas | PSC05 | ||
Aviso de orden judicial de liquidación | 2 páginas | CO4.2(Scot) | ||
Notificación de la orden de liquidación | 1 páginas | 4.2(Scot) | ||
Domicilio social registrado cambiado de New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB Scotland a Atria One 144 Morrison Street Edinburgh EH3 8EX el 06 abr 2018 | 2 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de Keith Robertson Cochrane como director el 14 feb 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de un liquidador provisional | 4 páginas | 4.9(Scot) | ||
Cese del nombramiento de Richard John Howson como director el 15 ene 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Philip Ernest Shepley como director el 21 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Emma Louise Mercer como director el 12 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Keith Robertson Cochrane como director el 12 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cambio de datos del director Mr Philip Ernest Shepley el 20 nov 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del secretario Alison Margaret Shepley el 20 nov 2017 | 1 páginas | CH03 | ||
Nombramiento de Mr Westley Maffei como director el 23 oct 2017 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Zafar Iqbal Khan como director el 11 sept 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||
Nombramiento de Westley Maffei como secretario el 01 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||
Cese del nombramiento de Timothy Francis George como secretario el 30 jun 2017 | 1 páginas | TM02 | ||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de Fenick House 1 Lister Way Hamilton International Technology Park Blantyre Glasgow G72 0FT a New Alderston House Strathclyde Business Park 3 Dove Wynd Bellshill Scotland ML4 3FB el 19 jun 2017 | 1 páginas | AD01 | ||
Cese del nombramiento de John Christopher Platt como director el 08 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Zafar Iqbal Khan el 01 ene 2017 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONALD, James | Secretario | Rivendell 6 Gowanside Place ML8 5UN Carluke Lanarkshire | British | 981650002 | ||||||
| DONALD, James | Secretario | 30 Hallcraig Place ML8 5UJ Carluke | British | 981650001 | ||||||
| FORSTER, Garry James | Secretario | Pilgrim Cottage Path Hill RG8 7RE Goring Heath Oxfordshire | British | 38750850004 | ||||||
| GEORGE, Timothy Francis | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 146879670001 | |||||||
| GOODMAN, Claudia Suzanne | Secretario | Flat 4/2 336 Meadowside Quay Walk G11 6AW Glasgow | British | 109643480001 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Secretario | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | British | 44883010002 | ||||||
| HIGGINS, Caroline Patricia | Secretario | Flat 10 7 Aubert Park N5 1TL London | British | 88102970001 | ||||||
| JACKSON, Andrew Philip | Secretario | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | British | 7921750002 | ||||||
| MAFFEI, Westley | Secretario | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | 235233360001 | |||||||
| SHEPLEY, Alison Margaret | Secretario | 10-12 Russell Square Bloomsbury WC1B 5EH London Russell Square House United Kingdom | British | 84788390002 | ||||||
| SINCLAIR, John Murdoch | Secretario | 20 Lythgow Way ML11 7JA Lanark Lanarkshire | British | 655240002 | ||||||
| SINCLAIR, John Murdoch | Secretario | 118 Goremire Road ML8 4PF Carluke | British | 655240001 | ||||||
| MACLAY MURRAY & SPENS LLP | Secretario designado corporativo | St. Vincent Street G2 5NJ Glasgow 151 | 900003400001 | |||||||
| ADAM, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | United Kingdom | British | 67133560004 | |||||
| ALLAN, William Macdonald | Director | Hyndford Lea House 409 Hyndford Park ML11 8SQ Lanark Lanarkshire | British | 632640004 | ||||||
| BARRETT, James Desmond | Director | 31 Meldrum Mains Glenmavis ML6 0QQ Airdrie Lanarkshire | British | 656260001 | ||||||
| BOOTH, Karen Jane | Director | Feiashill Road WV5 7HT Trysull Cherry Cottage South Staffs | United Kingdom | British | 192636860001 | |||||
| BROWN, Greig Ronald | Director | Cherrytree Wynd The Stroud East Kilbride G75 0GA Glasgow 28 | Uk | British | 128835140001 | |||||
| CAMPBELL, Fraser John | Director | 47 Main Street KY12 8QT Cairneyhill Fife | Scotland | British | 79834340001 | |||||
| COCHRANE, Keith Robertson | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | Scotland | British | 105823620002 | |||||
| CROMPTON, George Peter | Director | 25 Roxburgh Road Little Sutton CH66 4YU South Wirral Cheshire | England | British | 167822290001 | |||||
| DODD, Ian Rees | Director | 5 Kirklands Drive Newton Mearns G77 5FF Glasgow | Scotland | British | 37550740002 | |||||
| DONALD, James | Director | Rivendell 6 Gowanside Place ML8 5UN Carluke Lanarkshire | British | 981650002 | ||||||
| GRICE, Ian Michael | Director | Heronshaw Oldbury Lane TN15 9DE Ightham Kent | United Kingdom | British | 44883010002 | |||||
| HANCOCK, Timothy John | Director | 82 Argus Lofts Robert Street BN1 4AY Brighton East Sussex | England | British | 96124860001 | |||||
| HARRIS, Ronald Hewer | Director | Home Way GU31 4EE Petersfield 16 Hampshire | British | 130770470001 | ||||||
| HAYWARD, Alan | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | United Kingdom | British | 154549030001 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 147650310001 | |||||
| JACKSON, Andrew Philip | Director | 6 Sparvells Eversley RG27 0QG Hook Hampshire | England | British | 7921750002 | |||||
| KASHER, Michael Harrison | Director | 7077 Keele Street 4th Floor Concord L4K 0B6 Ontario Carillion Canada Inc Canada | England | British | 140185150001 | |||||
| KASHER, Michael Harrison | Director | 36 Mildred Sylvester Way WF6 1TA Normanton First Floor United Kingdom | England | British | 140185150001 | |||||
| KENNY, Thomas Donald | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 85390230002 | |||||
| KENNY, Thomas Donald | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | Irish | 85390230002 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | 84 Salop Street WV3 0SR Wolverhampton Carillion House United Kingdom | England | British | 195408780001 | |||||
| KHAN, Zafar Iqbal | Director | Birch Street WV1 4HY Wolverhampton 24 United Kingdom | England | British | 195408780001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CARILLION (AMBS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carillion (Ambs) Holdings Limited | 06 abr 2016 | 144 Morrison Street EH3 8EX Edinburgh Atria One United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CARILLION (AMBS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 09 dic 2016 Entregado el 16 dic 2016 | Pendiente | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security assignment and charge | Creado el 15 dic 2004 Entregado el 05 ene 2005 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Right, title, benefit and interest in and to the security account and the charged equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Security assignment and charge | Creado el 11 jun 2003 Entregado el 02 jul 2003 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Land lease and charged equipment. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 03 mar 1987 Entregado el 16 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Lease of ground at gartsheri industrial estate coatbridge. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 03 mar 1987 Entregado el 10 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Ground on south west side of bothwell rd hamilton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 27 feb 1979 Entregado el 07 mar 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene CARILLION (AMBS) LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación forzosa |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0