THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED
Visión general
Nombre de la empresa | THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED |
---|---|
Estado de la empresa | Disuelta |
Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
Número de empresa | SC020911 |
Jurisdicción | Escocia |
Fecha de constitución | |
Fecha de cese |
Resumen
Tiene PSCs súper seguros | No |
---|---|
Tiene gravámenes | Sí |
Tiene historial de insolvencia | Sí |
La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
- Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
Dirección de la sede social | 272 Bath Street G2 2JR Glasgow |
---|---|
Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
Últimas cuentas | |
---|---|
Últimas cuentas cerradas hasta | 30 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cambio de administración a disolución | 33 páginas | AM23(Scot) | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 33 páginas | AM10(Scot) | ||||||||||
Aviso de extensión del período de administración | 5 páginas | AM19(Scot) | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 35 páginas | AM10(Scot) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Mccall como secretario el 17 may 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John King como director el 17 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de la propuesta considerada del administrador | 1 páginas | 2.16BZ(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 8th Floor Orchard Brae House, 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS a 272 Bath Street Glasgow G2 2JR el 06 dic 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de la propuesta del administrador | 111 páginas | 2.16B(Scot) | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario 2.13B(Scot) | 4 páginas | 2.15B(Scot) | ||||||||||
Nombramiento de un administrador | 2 páginas | 2.11B(Scot) | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2017 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Cancelación total de la carga 7 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ashley Gilroy Mark Highfield como director el 05 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 28 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 29 may 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Helen Clare Oldham como director el 31 mar 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 ene 2016 | 21 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Helen Clare Oldham como director el 01 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 05 ene 2015 | 18 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 28 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFFLECK, Gordon Keir | Secretario | 14 Ravelston Dykes EH4 3ED Edinburgh | British | 54593310002 | ||||||
CHIPP, Glen | Secretario | 8 Ben Sayers Park EH39 5PT North Berwick East Lothian | British | 43348820002 | ||||||
COOPER, Philip Richard | Secretario | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | Company Secretary | 131295290001 | |||||
HILL, James Douglas Moffat | Secretario | 13 Craiglockhart Dell Road EH14 1JW Edinburgh Midlothian | British | 499590001 | ||||||
MCCALL, Peter | Secretario | Bath Street G2 2JR Glasgow 272 | 147149300001 | |||||||
ADDLEY, Stephen Boyd | Director | Tall Trees Garden Reach Burtons Lane HP8 4BE Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | Personnel Director | 88262390001 | |||||
AFFLECK, Gordon Keir | Director | 14 Ravelston Dykes EH4 3ED Edinburgh | Scotland | British | Assistant Managing Director | 54593310002 | ||||
BARCLAY, Aidan Stuart | Director | 20 St James's Street SW1A 1ES London | United Kingdom | British | Company Director | 7355000002 | ||||
BRINDLE, Anthony Warwick | Director | 5 Westgate Close NE25 9HT Whitley Bay Tyne & Wear | British | Managing Director | 40027820001 | |||||
CASKIE, David Baird | Director | 88 Maggiewoods Loan FK1 5EH Falkirk | Scotland | British | Company Director | 45898950001 | ||||
COOPER, Philip Richard | Director | Grange Knowe EH49 7HX Linlithgow 14 West Lothian United Kingdom | British | Company Secretary | 131295290001 | |||||
FRY, John Anthony | Director | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | England | British | Chief Executive Officer | 136914890001 | ||||
GARNER, Stuart Montague | Director | Alexander House Stone Place IP12 1DW Woodbridge Suffolk | British | Chief Executive | 20006580001 | |||||
HARDY, Herbert Charles | Director | 64 Cadogan Square SW1X 0EA London | British | Company Newspaper Director | 35800770002 | |||||
HEEPS, William | Director | The Old Vicarage Pipers Hill Great Gaddesden HP1 3BY Hemel Hempstead Hertfordshire | British | Company Director | 17968780002 | |||||
HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 164400440001 | ||||
JOHNSTON, Michael Frederick | Director | Ann Street EH4 1PL Edinburgh 19 | Scotland | British | Company Director | 130826730001 | ||||
JONES, Michael David | Director | 31a Lexden Road CO3 3PX Colchester Essex | England | British | Managing Director | 69058220001 | ||||
KING, David John | Director | Bath Street G2 2JR Glasgow 272 | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 179020430001 | ||||
LAWRENCE, Peter John | Director | Mayfield 50 Denham Lane SL9 0ET Gerrards Cross Buckinghamshire | British | Finance Director | 57189670001 | |||||
LOGAN, Joseph Andrew | Director | 197 Colinton Road EH14 1BJ Edinburgh Midlothian | British | Company Director | 14123360001 | |||||
MCGREGOR, David Paton | Director | 60 Amberwood BH22 9JT Ferndown Dorset | British | Finance Director | 29330770001 | |||||
MOWATT, Rigel Kent | Director | 69 Mid Street RH1 4JJ South Nutfield Surrey | England | British | Chartered Accountant | 7922730001 | ||||
MURRAY, Grant | Director | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 159877110001 | ||||
OLDHAM, Helen Clare | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor | England | British | Managing Director | 105449720003 | ||||
PATERSON, Stuart Randall | Director | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | Finance Director | 64281400001 | ||||
PAUL, James Gordon | Director | 247 Haverstock Hill Hampstead NW3 4PR London | British | Chief Executive | 26696380001 | |||||
PETERS, Philip Leslie | Director | 20 St. James's Street SW1A 1ES London | United Kingdom | British | Banking Director/Company Direc | 125281170001 | ||||
RICHARDSON, Andrew John | Director | c/o C/O Johnston Press Plc Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 United Kingdom | Scotland | British | Managing Director | 149470940001 | ||||
RIDLEY-THOMAS, Roger | Director | Copse Hill House Flaunden Lane HP3 0PA Bovingdon Hertfordshire | British | Company Director | 34045870001 | |||||
SEAL, Michael | Director | 20 St James's Street SW1A 1ES London | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 4991060003 | ||||
WALKER, Steven John | Director | 9 Lennel Avenue EH12 6DW Edinburgh | Scotland | British | Advertising Director | 61064440002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED?
Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnston Press Plc | 06 abr 2016 | 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh Orchard Brae House Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
|
¿Tiene THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED alguna carga?
Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Creado el 23 jun 2014 Entregado el 04 jul 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción All material real property owned by the chargor on the date of security agreement see form for further details. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
A registered charge | Creado el 16 jun 2014 Entregado el 24 jun 2014 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Standard security | Creado el 25 jun 2010 Entregado el 01 jul 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects at 9 newhaven road edinburgh (formerly 7/9 newhaven road edinburgh). | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Deed of accession | Creado el 25 sept 2009 Entregado el 06 oct 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
Assignation | Creado el 02 feb 2001 Entregado el 14 feb 2001 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada Sums due in terms of the facilities agreement (as defined in the charge) | |
Breve descripción The whole right, title, interest and benefit in the contract between the company and goss graphic systems dated 4TH & 7TH december 2000 & the prepayment guarantee. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 12 dic 1995 Entregado el 22 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 9 newhaven road, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Standard security | Creado el 12 dic 1995 Entregado el 22 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The scotsman buildings, 20, 22 and 24 north bridge, edinburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Floating charge | Creado el 08 dic 1995 Entregado el 22 dic 1995 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
|
¿Tiene THE SCOTSMAN PUBLICATIONS LIMITED algún caso de insolvencia?
Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0