MATTHEW GLOAG & SON LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MATTHEW GLOAG & SON LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC020954 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (11010) / Industrias manufactureras
- Comercio al por mayor de vino, cerveza, bebidas espirituosas y otras bebidas alcohólicas (46342) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Dirección de la sede social | Strathclyde Business Park Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Lanarkshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| HIGHLAND DISTILLERS BRANDS UK LIMITED | 23 mar 2000 | 23 mar 2000 |
| MAXXIUM UK LIMITED | 01 feb 2000 | 01 feb 2000 |
| HIGHLAND DISTILLERS BRANDS U.K. LIMITED | 16 feb 1999 | 16 feb 1999 |
| MATTHEW GLOAG & SON, LIMITED | 14 abr 1939 | 14 abr 1939 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 30 nov 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 dic 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 30 nov 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la dirección del domicilio social registrado Strathclyde Business Park Phoenix Crescent Bellshill Lanarkshire ML4 3AN | 1 páginas | AD04 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Kirsten Anna Wallace Meikle como director el 04 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Graeme Mckinlay Jenkins como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Kenneth Strachan Mckinlay como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Ewan John Henderson como director el 01 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicholas John Mcmanus como secretario el 01 jul 2025 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Aristotelis Baroutsis como director el 01 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Joakim Andreasson Leijon como director el 01 jul 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 100 Queen Street Glasgow G1 3DN Scotland a Strathclyde Business Park Phoenix Crescent Bellshill Lanarkshire ML4 3AN el 01 jul 2025 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Notification de The Famous Grouse Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jun 2025 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Highland Distillers Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jun 2025 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Estado de capital el 27 may 2025
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 2 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2024 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 nov 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Huw Charlton Pennell como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Suzy Smith como director el 03 feb 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Aristotelis Baroutsis como director el 03 feb 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENDERSON, Ewan John | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 83866580002 | |||||
| JENKINS, Graeme Mckinlay | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | England | British | 222813990001 | |||||
| MCKINLAY, Kenneth Strachan | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | Scotland | British | 259715100001 | |||||
| MEIKLE, Kirsten Anna Wallace | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | England | British | 109761200003 | |||||
| BELL, Graeme D | Secretario | 37 Stormont Road Scone PH2 6PJ Perth Perthshire | British | 85700001 | ||||||
| COOKE, Martin Alexander | Secretario | Queen Street G1 3DN Glasgow 100 Scotland | 227528210001 | |||||||
| MCMANUS, Nicholas John | Secretario | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | 275313890001 | |||||||
| MORRISON, Fraser Stuart | Secretario | 19 Haston Crescent PH2 7XD Perth Perthshire | British | 1320140001 | ||||||
| BAROUTSIS, Aristotelis | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | Scotland | Swedish | 292253950001 | |||||
| BRANNAN, Robert | Director | 13 Ashburnham Gardens EH30 9LB South Queensferry West Lothian | British | 64147580001 | ||||||
| BYERS, John Scott | Director | 46 Castleton Drive Newton Mearns G77 5LE Glasgow Lanarkshire | British | 107800001 | ||||||
| COOKE, Martin Alexander | Director | Queen Street G1 3DN Glasgow 100 Scotland | Scotland | British | 136961730001 | |||||
| DARBYSHIRE, Peter | Director | Balhomie House Cargill PH2 6DS Perth Perthshire | British | 60123450001 | ||||||
| EASTON, Ronald Story | Director | 1 Yew Gardens Luncarty PH1 3UD Perth | Scotland | British | 174715380001 | |||||
| FARRAR, Richard William | Director | West Grange House By Culross KY12 8EL Culross | Scotland | British | 14413860001 | |||||
| FARRAR, Richard William | Director | West Grange House By Culross KY12 8EL Culross | Scotland | British | 14413860001 | |||||
| GILLIES, Robert Skirving Scott | Director | West Lodge St Martins PH2 6AL Perth Perthshire | British | 107770001 | ||||||
| GLEN, Trina Catherine | Director | Holmcraig Montrose Terrace PA11 3DD Bridge Of Weir Renfrewshire | United Kingdom | British | 67317220001 | |||||
| GLOAG, Matthew Irving | Director | Hillockhead Airlie DD8 5NN Kirriemuir Angus | British | 1424510002 | ||||||
| GOOD, John James Griffen, Sir | Director | Old Greenock Road PA7 5BB Bishopton Woodlands 120 Renfrewshire | Scotland | British | 65806120005 | |||||
| GOODWIN, John Macleod | Director | 3 Old Edinburgh Gardens Boarhills KY16 8PZ St. Andrews Fife | British | 95188710001 | ||||||
| GRAHAM, Edward Thomas | Director | Carolina Place Wolfhill Perth Tayside | British | 30855990001 | ||||||
| GRIMWOOD, Paul | Director | Weydown House Farnham Lane GU27 1EU Haslemere Surrey | British | 86255060001 | ||||||
| HUGHES, John | Director | Ben Lui PH7 3EQ Crieff | British | 88490001 | ||||||
| IVORY, Brian Gammell, Sir | Director | 12 Ann Street EH4 1PJ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 107780003 | |||||
| JACKSON, Barrie Mason | Director | 26 Coltbridge Terrace EH12 6AE Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 59010012 | |||||
| JACKSON, Barrie Mason | Director | "Capelaw" 486 Lanark Road West EH14 7AN Balerno Midlothian | British | 59010003 | ||||||
| KAY, Gerard | Director | 8 Dean Terrace EH4 1ND Edinburgh Midlothian | British | 44473410001 | ||||||
| KETTLES, Andrew | Director | Redcroft PH13 9AU Coupar Angus | British | 88530001 | ||||||
| LEIJON, Joakim Andreasson | Director | Phoenix Crescent ML4 3AN Bellshill Strathclyde Business Park Lanarkshire Scotland | Scotland | Swedish | 292253810001 | |||||
| MAXWELL SCOTT, David Darragh | Director | 56 Hazlewell Road SW15 6LR London | United Kingdom | British | 93189170001 | |||||
| MORRISON, Fraser Stuart | Director | Haston Crescent PH2 7XD Perth 19 Perthshire United Kingdom | Scotland | British | 147121870001 | |||||
| PENNELL, Huw Charlton | Director | Queen Street G1 3DN Glasgow 100 Scotland | Scotland | British | 109961500001 | |||||
| SANDERS, Simon Patrick | Director | Woodfield Balmullo KY16 0AN St Andrews Fife | Scotland | British | 473140002 | |||||
| SHERRIFF, John Alexander | Director | Pitnacree House Ballinluig PH9 0LW Pitlochry Perthshire | British | 88520001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MATTHEW GLOAG & SON LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Famous Grouse Limited | 01 jun 2025 | Fleet Place EC4M 7WS London One England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Highland Distillers Group Limited | 06 abr 2016 | West Kinfauns PH2 7XZ Perth West Kinfauns Perthshire Scotland | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0