THE TWEEDDALE PRESS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE TWEEDDALE PRESS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC020984 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
- Edición de periódicos (58130) / Información y comunicación
¿Dónde se encuentra THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Dirección de la sede social | 272 Bath Street G2 4JR Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 dic 2017 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cambio de administración a disolución | 33 páginas | AM23(Scot) | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 33 páginas | AM10(Scot) | ||||||||||
Aviso de extensión del período de administración | 5 páginas | AM19(Scot) | ||||||||||
Informe de progreso del administrador | 35 páginas | AM10(Scot) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Guy Butterworth como director el 17 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Peter Michael Mccall como secretario el 17 may 2019 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David John King como director el 17 may 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de la propuesta considerada del administrador | 1 páginas | 2.16BZ(Scot) | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 8th Floor Orchard Brae House, 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS a 272 Bath Street Glasgow G2 4JR el 06 dic 2018 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de asuntos con el formulario 2.13B(Scot) | 4 páginas | 2.15B(Scot) | ||||||||||
Declaración de la propuesta del administrador | 111 páginas | 2.16B(Scot) | ||||||||||
Nombramiento de un administrador | 2 páginas | 2.11B(Scot) | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 dic 2017 | 23 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Guy Butterworth como director el 24 sept 2018 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ashley Gilroy Mark Highfield como director el 05 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 abr 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
La dirección de inspección del registro se ha cambiado de 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS Scotland a 8th Floor Orchard Brae House 30 Queensferry Road Edinburgh EH4 2HS | 1 páginas | AD02 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 11 abr 2017 con actualizaciones | 6 páginas | CS01 | ||||||||||
Los registros se han trasladado a la ubicación de inspección registrada 108 Holyrood Road Edinburgh EH8 8AS | 1 páginas | AD03 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 02 ene 2016 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 11 abr 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Stephen Plews como director el 31 dic 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alan Stephen Plews como director el 01 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUDGEON, Edward | Secretario | 25 Cottage Road NE71 6AD Wooler Northumberland | British | 19728160001 | ||||||
| MCCALL, Peter Michael | Secretario | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | 161445620001 | |||||||
| SIMMONS, John Edward | Secretario | 4 Valley View Tweedmouth TD15 2ED Berwick Upon Tweed | British | 37365190002 | ||||||
| SMAIL, John Daniel Richardson | Secretario | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk Borders | British | 41960002 | ||||||
| SPEIGHT, Arthur John Peter | Secretario | 37 High Street NE71 6BU Wooler Northumberland | British | 41920001 | ||||||
| ANDREW, James Houston | Director | Fogo Mains Fogo TD11 3RA Duns Berwickshire | United Kingdom | British | 62235680001 | |||||
| ARMSTRONG, Anthony Bowes | Director | Riverview Cottage Lilliesleaf TD6 9JB Melrose Roxburghshire | British | 35246880001 | ||||||
| BIRKETT, Stuart James | Director | 10 Eildon View TD15 2FQ Berwick Upon Tweed Northumberland | United Kingdom | British | 174124340001 | |||||
| BOWDLER, Timothy John | Director | 2-11 St Vincent Place EH3 5BQ Edinburgh | United Kingdom | British | 37521870002 | |||||
| BROTHERSTON, Richard | Director | 8 Strathearn Road EH9 2AE Edinburgh Midlothian | British | 39940001 | ||||||
| BUTTERWORTH, Michael Guy | Director | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | England | British | 76600500002 | |||||
| CASKIE, David Baird | Director | 88 Maggiewoods Loan FK1 5EH Falkirk | Scotland | British | 45898950001 | |||||
| CHIAPPELLI, Marco Luigi Autimio | Director | 21 Braid Farm Road EH10 6LE Edinburgh | Scotland | British | 474360001 | |||||
| DOWNIE, George Waddell | Director | The Gables,Close Farm Hatch Beauchamp TA3 6AE Taunton Somerset | British | 26306280002 | ||||||
| DUDGEON, Edward | Director | 25 Cottage Road NE71 6AD Wooler Northumberland | British | 19728160001 | ||||||
| FRY, John Anthony | Director | Church Hill NR15 1TD Saxlingham Nethergate Old Rectory Norfolk Uk | England | British | 136914890001 | |||||
| HIGHFIELD, Ashley Gilroy Mark | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor Scotland | United Kingdom | British | 164400440001 | |||||
| KING, David John | Director | Bath Street G2 4JR Glasgow 272 | United Kingdom | British | 179020430001 | |||||
| MCINTYRE, Keith William | Director | 49 Meldrum Mains Glenmavis ML6 0QQ Airdrie Lanarkshire | Scotland | British | 112687860001 | |||||
| MCPHERSON, Stuart | Director | 8 Heriot Road Lenzie G66 5AY Glasgow | Scotland | British | 986760004 | |||||
| MURRAY, Grant | Director | Holyrood Road EH8 8AS Edinburgh 108 Scotland | United Kingdom | British | 159877110001 | |||||
| PATERSON, Stuart Randall | Director | 41 Fernielaw Avenue EH13 0EF Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 64281400001 | |||||
| PLEWS, Alan Stephen | Director | Orchard Brae House, 30 Queensferry Road EH4 2HS Edinburgh 8th Floor | England | British | 27819010002 | |||||
| RICHARDSON, John Daniel | Director | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk | British | 47707970001 | ||||||
| SMAIL, Derek James Richardson | Director | Waimate East Ord TD15 2NS Berwick Upon Tweed Northumberland | England | British | 41950001 | |||||
| SMAIL, Dorothy Margaret | Director | Kiwi Cottage Scremerston TD15 2RB Berwick Upon Tweed Northumberland | British | 41940001 | ||||||
| SMAIL, James Ingram Miles | Director | Kiwi Cottage Scremerston TD15 2RB Berwick Upon Tweed Northumberland | British | 41930001 | ||||||
| SMAIL, John Daniel Richardson | Director | Lindean Farmhouse Lindean TD7 4QW Selkirk Borders | British | 41960002 | ||||||
| WALLACE, David Forster | Director | The Whins Unthbank Square TD15 2NG Berwick-Upon-Tweed Northumberland | British | 65583180002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE TWEEDDALE PRESS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnston Publishing Limited | 06 abr 2016 | Bourges Boulevard PE1 1NG Peterborough Unex House - Suite B Cambridgeshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THE TWEEDDALE PRESS LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 23 jun 2014 Entregado el 04 jul 2014 | Pendiente | ||
Breve descripción All material real property owned by the chargor on the date of the security agreement see form for further details. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| A registered charge | Creado el 16 jun 2014 Entregado el 24 jun 2014 | Pendiente | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Deed of accession | Creado el 25 sept 2009 Entregado el 06 oct 2009 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 04 mar 1991 Entregado el 11 mar 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The hermitage selkirk. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Mortgage | Creado el 12 sept 1986 Entregado el 24 sept 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £27375 and all further sums due or to become due | |
Breve descripción 13 thomson gate tweedmonte. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 28 ago 1979 Entregado el 30 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop and dwellinghouse forming numbers 1 & 3 easter street, dums in the town and parish of dums in the county of berwick. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 15 ago 1979 Entregado el 21 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Subjects in boarding school yard, berwick upon tweed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 15 ago 1979 Entregado el 21 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 94/94A marygate, berwick upon tweed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 15 ago 1979 Entregado el 21 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Kuri cottages, scremerston, berwick upon tweed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 may 1979 Entregado el 25 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 51 high street selkirk. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 may 1979 Entregado el 25 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 53 high street, selkirk. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 may 1979 Entregado el 25 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 19 bridge street, kelso, roxburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 16 may 1979 Entregado el 25 may 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Northmost shop at 33 high street, jedburgh. County of roxburgh. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 29 ene 1979 Entregado el 02 feb 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal charge | Creado el 03 dic 1976 Entregado el 07 dic 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Freehold property "weimate", east old berwick upon tweed. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| G r s roxburgh standard security | Creado el 05 mar 1976 Entregado el 08 mar 1976 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Land & store at 8 buccleuch st., Hawick. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene THE TWEEDDALE PRESS LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| En administración |
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0