THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.
Visión general
| Nombre de la empresa | THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD. |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC024440 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
- Otras actividades deportivas (93199) / Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
¿Dónde se encuentra THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Dirección de la sede social | 16-18 Weir Street FK1 1RA Falkirk Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 23 abr 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 may 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 23 abr 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramiento de Mr John Alexander Kinmond como director el 16 oct 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2024 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2023 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Henry George Williams como director el 18 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Notification de Nicolas Jason Boyes en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 oct 2023 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||
Nombramiento de Rebecca Jane Smith como director el 06 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Richard David Edward Stanley Burrell como director el 06 oct 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 19 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de John Alexander Kinmond como director el 02 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Mcnab como director el 02 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Kevin James Nigel Pick como director el 02 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Alan James Barron como director el 02 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Glenn Martyn Alcock como director el 02 may 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 23 abr 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 dic 2022 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael How como director el 23 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Hugh Mcphail Mccaig en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 feb 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cessation de Bernard Buss en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 mar 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Bernard Buss como director el 03 mar 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cessation de Victor John Scott Covey en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 feb 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Victor John Scott Covey como director el 28 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hugh Mcphail Mccaig como director el 28 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYES, Nicolas Jason | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 295215790001 | |||||
| BRUNTON, Graham | Director | Knockhill Racing Circuit Saline KY12 9TF Dunfermline Unit 22 Fife United Kingdom | Scotland | British | 159453880001 | |||||
| BURNS, Steven John | Director | School Road Kilcreggan G84 0HT Helensburgh Dungrianach Scotland | United Kingdom | British | 183610140001 | |||||
| KINMOND, John Alexander | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 72770230003 | |||||
| SMITH, Rebecca Jane | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 314382580001 | |||||
| BRUNTON, Heather Anne | Secretario | Knockhill Racing Circuit Saline KY12 9TF Dunfermline Unit 22 Fife United Kingdom | British | 169538810001 | ||||||
| BUSS, Margaret Anne | Secretario | Yew Tree Cottage Wellfield TD11 3EH Duns Berwickshire | British | 41873900001 | ||||||
| EDWARDS, Gillian | Secretario | Birch House PH2 9PD Duncrievie | British | 82236850002 | ||||||
| FORTUNE, Linda, Mes | Secretario | 10 Burnhead Road ML9 2EH Larkhall Lanarkshire | British | 988230002 | ||||||
| ALCOCK, Glenn Martyn | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 258905620001 | |||||
| BARRON, Alan James | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 295194320001 | |||||
| BOYES, Nicolas Jason | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 | United Kingdom | British | 78518020004 | |||||
| BROWN, Thomas | Director | 40 Clydeford Rd Cambuslang G72 7JF Glasgow Strathclyde | British | 35200780001 | ||||||
| BURRELL, Richard David Edward Stanley | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 276624350001 | |||||
| BUSS, Bernard | Director | Yew Tree Cottage TD11 3EH Duns Berwickshire | Scotland | British | 1078980001 | |||||
| BUTCHER, Derek | Director | 66 Donibristle Gardens Dalgety Bay KY11 9NQ Dunfermline Fife | United Kingdom | British | 94683850001 | |||||
| CHALMERS, Hugh | Director | 442 Lanark Road West Edinburgh | British | 1098090001 | ||||||
| CLARK, John Hunter Somerville | Director | Ramornie Craigs Road AB41 9BG Ellon Aberdeenshire | Scotland | British | 39539350001 | |||||
| CLARKE, Nicholas David | Director | 19 Laverockdale Park EH13 0QE Edinburgh | United Kingdom | British | 42383910001 | |||||
| COVEY, Victor John Scott | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 267189880001 | |||||
| COVEY, Victor George Christopher | Director | 9 Dovecot Way EH34 5HA Pencaitland East Lothian | United Kingdom | British | 239600006 | |||||
| DAVIES, Gareth | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 170391970001 | |||||
| DENHAM, Robert Alexander | Director | 103 Ferryfield EH5 2PS Edinburgh | Scotland | British | 50855290001 | |||||
| DRYDEN, Mark George Noble | Director | Bruntsfield Crescent EH42 1QZ Dunbar 42 East Lothian | Scotland | British | 101177580001 | |||||
| DUNCAN, John James | Director | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Scotland | British | 276623340001 | |||||
| EDWARDS, Christopher Heath | Director | Birch House, PH2 9PD Duncrievie Perthshire | British | 38644000002 | ||||||
| FENWICK, Alan Andrew Hugh | Director | Greenbank Road PH2 9NW Glenfarg 20 Perthshire | Scotland | British | 47567940002 | |||||
| FORSYTH, James | Director | 5 Kirkstyle Cottages ML5 5AJ Coatbridge Lanarkshire | United Kingdom | British | 165580001 | |||||
| FURSMAN, John | Director | 27 Bellevue Place EH7 4BS Edinburgh Midlothian | British | 48692120002 | ||||||
| FYDA, John | Director | 15 Ure Street DD1 5JD Dundee Angus | British | 1067630001 | ||||||
| GASCOIGNE, Michael Neil Clifton | Director | Glenalmond Whitefield Road KY12 0SY Dunfermline Fife | Scotland | British | 65521550001 | |||||
| GAULD, Graham | Director | Victoria House 38 Lower Granton Road EH5 3RS Edinburgh Midlothian | British | 1098130001 | ||||||
| GRAY, Stuart Ferguson | Director | 24 Ashburnham Gardens EH30 9LB South Queensferry Edinburgh | Scotland | British | 88983780001 | |||||
| GRAY, Stuart Ferguson | Director | 64 Stoneyflatts Crescent EH30 9XY South Queensferry West Lothian | British | 1371790001 | ||||||
| HAMILTON, Adrian William | Director | West Ingliston Cottage Glasgow Road EH28 8LY Edinburgh Lothian | United Kingdom | British | 95519130001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE SCOTTISH MOTOR RACING CLUB LTD.?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Nicolas Jason Boyes | 06 oct 2023 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Victor John Scott Covey | 31 dic 2020 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Robert Alexander Denham | 16 nov 2017 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Michael How | 16 nov 2017 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Steven John Burns | 16 nov 2017 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | No |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Bernard Buss | 06 abr 2016 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Hugh Mcphail Mccaig | 06 abr 2016 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Graham Brunton | 06 abr 2016 | Weir Street FK1 1RA Falkirk 16-18 Scotland | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: Scotland | |||
Naturaleza del control
| |||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0