EDINBURGH IC LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EDINBURGH IC LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC024663 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EDINBURGH IC LIMITED?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra EDINBURGH IC LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EDINBURGH IC LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| EDINBURGH GEORGE HOTEL LIMITED | 03 nov 1989 | 03 nov 1989 |
| INTER-CONTINENTAL HOTELS (SCOTLAND) LIMITED | 01 sept 1989 | 01 sept 1989 |
| GRAND METROPOLITAN HOTELS (SCOTLAND) LIMITED | 21 oct 1946 | 21 oct 1946 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EDINBURGH IC LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2019 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EDINBURGH IC LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 17 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Modification des détails de Six Continents Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 ene 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2021 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Caledonian Exchange 19a Canning Street Edinburgh EH3 8HE a C/O Bdo Llp 4 Atlantic Quay 70 York Street Glasgow G2 8JX el 22 dic 2020 | 2 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Six Continents Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 oct 2020 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Ihc Edinburgh (Holdings) en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 oct 2020 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 19 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 22 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Melinda Marie Renshaw como director el 24 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nicolette Henfrey como director el 24 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Heather Carol Wood como director el 31 jul 2019 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Todd Glover como director el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2019 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 17 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Nigel Peter Stocks como director el 31 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 30 jun 2017 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 16 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ralph Wheeler como director el 27 feb 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael Todd Glover como director el 20 jul 2016 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mrs Fiona Cuttell como secretario el 20 jul 2016 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Hanisha Hands-Patel como secretario el 22 jul 2016 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de EDINBURGH IC LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUTTELL, Fiona | Secretario | 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow C/O Bdo Llp | 211328620001 | |||||||
| COCKCROFT, Michael Jon | Director | Broadwater Park, North Orbital Road Denham UB9 5HR Uxbridge Intercontinental Hotels Group Middlesex England | United Kingdom | British | 193297040001 | |||||
| RENSHAW, Melinda Marie | Director | 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow C/O Bdo Llp | United Kingdom | American | 267794820001 | |||||
| WOOD, Heather Carol | Director | 4 Atlantic Quay 70 York Street G2 8JX Glasgow C/O Bdo Llp | England | British | 261257930001 | |||||
| BARR, Caroline Rowena | Secretario | 14 Rayleigh Road IG8 7HG Woodford Green Essex | British | 860950002 | ||||||
| BARR, Caroline Rowena | Secretario | 48 Queens Road Leytonstone E11 1BB London | British | 860950001 | ||||||
| BARRY, Chloe | Secretario | 35 Victor Road SL4 3JS Windsor Berkshire | British | 92460210002 | ||||||
| BRIDGE, Michael John Noel | Secretario | 17 Airedale Avenue Chiswick W4 2NW London | British | 36370370001 | ||||||
| ENGMANN, Catherine | Secretario | 18 Rays Avenue SL4 5HG Windsor Berkshire | British | 92722710002 | ||||||
| GLANVILLE, Charles Dixon | Secretario | Flat 1 521 Caledonian Road N7 9RH London | British,American | 6015200002 | ||||||
| HANDS-PATEL, Hanisha | Secretario | Broadwater Park, North Orbital Road Denham UB9 5HR Uxbridge Ihg Middlesex England | 200384330001 | |||||||
| HIRANI, Daksha | Secretario | 178 Princes Avenue Kingsbury NW9 9JE London | British | 73720490001 | ||||||
| JACKSON, Ivan | Secretario | 36 Pyotts Copse Old Basing RG24 8WE Basingstoke Hampshire | British | 1029020001 | ||||||
| KAMERE, Sophia Muthoni | Secretario | 26 Lloyd Park Avenue CR0 5SB Croydon Surrey | British | 107635740001 | ||||||
| LITTLEBURY-CUTTELL, Fiona | Secretario | Broadwater Park UB9 5HR Denham Intercontinental Hotels Group Plc Buckinghamshire United Kingdom | 211331460001 | |||||||
| MEYER, Barbara Jean | Secretario | 657 Linwood Avenue CHANNEL Ridgewood New Jersey | British | 2805930001 | ||||||
| PATEL, Pritti | Secretario | Broadwater Park, North Orbital Road Denham UB9 5HR Uxbridge Intercontinental Hotels Group Middlesex England | 152578380001 | |||||||
| PATEL, Pritti | Secretario | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | 152578370001 | |||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretario | 27 Valley Road CM11 2BS Billericay Essex | British | 78744290002 | ||||||
| WILLIAMS, Alison | Secretario | 12a Oaklands Rise AL6 0RN Welwyn Hertfordshire | British | 78744290001 | ||||||
| ARASI, Thomas | Director | 557 Gramercy Drive Marietta 30068 FOREIGN Georgia Usa | American | 57855970001 | ||||||
| BARTLE, Warren William | Director | 29 The Quadrangle Chelsea Harbour London | Australian | 860960001 | ||||||
| BARTLE, Warren William | Director | 29 The Quadrangle Chelsea Harbour London | Australian | 860960001 | ||||||
| CAIRNS, Michael Anthony | Director | Birchlands Old Avenue KT13 0PY Weybridge Surrey | United Kingdom | British | 36488470001 | |||||
| COWIE, Graham Michael | Director | Fir Tree Cottage Rays Lane Tylers Green HP10 8LH Penn Buckinghamshire | England | British | 63239220001 | |||||
| CROSTON, Francis John | Director | 5 The Laurels Queenborough Lane CM77 7QD Braintree Essex | United Kingdom | British | 65219360003 | |||||
| EDGECLIFFE-JOHNSON, Paul Russell | Director | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | United Kingdom | British | 160885780001 | |||||
| GALLAGHER, Neil | Director | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange Scotland | England | British | 185313000001 | |||||
| GLANVILLE, Charles Dixon | Director | Flat 1 521 Caledonian Road N7 9RH London | England | British,American | 6015200002 | |||||
| GLOVER, Michael Todd | Director | 19a Canning Street EH3 8HE Edinburgh Caledonian Exchange | England | American | 210795090001 | |||||
| HAARMANN, Hans | Director | 4 Garthside Church Road Ham TW10 5JA Richmond Surrey | British | 56072750001 | ||||||
| HENFREY, Nicolette | Director | Broadwater Park, North Orbital Road Denham UB9 5HR Uxbridge Intercontinental Hotels Group Middlesex England | England | British | 163139310001 | |||||
| HOSONO, Takaaki | Director | 22 Greenway Totteridge N20 8ED London | Japanese | 56072690002 | ||||||
| LEWIS, Robert Phillip | Director | Hornbeams Orchard Dell West Chiltington RH20 2LB Pulborough West Sussex | British | 21503600001 | ||||||
| MANDER, Christopher | Director | Hotel Inter Continental London 1 Hamilton Place Hyde Park Corner W1V 0QY London | British | 19298860001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de EDINBURGH IC LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Six Continents Limited | 20 oct 2020 | Windsor Dials Arthur Road SL4 1RS Windsor 1 Berkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Ihc Edinburgh (Holdings) | 06 abr 2016 | North Orbital Road Denham UB9 5HR Uxbridge Broadwater Park Middlesex England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene EDINBURGH IC LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0