ABERLOUR HOUSE LIMITED

ABERLOUR HOUSE LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaABERLOUR HOUSE LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social
    Número de empresa SC025720
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    • Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales

    ¿Dónde se encuentra ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Gordonstoun School
    Elgin
    IV30 5RF Morayshire
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 ago 2012

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Bryan Peter Williams como director el 03 oct 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Professor Bryan Peter Williams como director el 03 oct 2020

    2 páginasAP01

    Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria

    1 páginasDISS16(SOAS)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Cese del nombramiento de Hugh Spence Brown como secretario el 16 may 2018

    2 páginasTM02

    Cese del nombramiento de Bryan Peter Williams como director el 01 jun 2018

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de John Yeoman como director el 01 jun 2018

    1 páginasTM01

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    1 páginasOC-DV

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2012

    7 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2013, aucune liste de membres fournie

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2011

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2012, aucune liste de membres fournie

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2010

    10 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2011, aucune liste de membres fournie

    4 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2009

    8 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 19 feb 2010, aucune liste de membres fournie

    3 páginasAR01

    Cambio de datos del director Mr Bryan Peter Williams el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del director Mr John Yeoman el 01 mar 2010

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2008

    10 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de ABERLOUR HOUSE LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BARR, George Jefferson
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    Secretario
    Gordonstoun School
    IV30 2RF Elgin
    Moray
    British38294790001
    BROWN, Hugh Spence
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    Secretario
    13 Beech Brae
    IV30 4NS Elgin
    Moray
    British40872570003
    BROWN, James Ogg, Commander
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    Secretario
    The White House
    Duffus
    IV30 2QN Elgin
    Morayshire
    British37334700001
    SPENCER, John Robert, Squadron Leader
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    Secretario
    Kilcluan House
    IV30 8LA Elgin
    Morayshire
    British50650460002
    WHITTLE, Colin Douglas Richardson
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    Secretario
    121 High Street
    IV36 1AB Forres
    British536270001
    BUCHANAN, Ewan Craig Barr
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    Director
    Mayne House
    IV30 3RS Elgin
    Morayshire
    United KingdomBritish404330003
    CAUNT, Christine Janet
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    Director
    43 Park Town
    OX2 6SL Oxford
    Oxfordshire
    British5133580001
    DICKINSON, John Joicey
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    Director
    Dipple House
    IV32 7QA Fochabers
    Moray
    British1278160001
    DONALD, Charles
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    Director
    Plow Green
    Hartley Wespall
    RG27 0AL Hook
    Hampshire
    EnglandBritish69189660001
    DRUMMOND, Norman
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    Director
    24 Huntingdon Place
    EH7 4AX Edinburgh
    Midlothian
    British68147030002
    FARQUHARSON, Clodagh
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    Director
    Dallas Lodge
    IV36 0RY Forres
    Moray
    British7047470001
    FERGUSON, James Gordon Dickson
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    Director
    25 Heriot Row
    EH3 6EN Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish23960001
    FOGDEN, Andrew Mark
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    Director
    Wardsley Farmhouse
    Leagram Chipping
    PR3 2QT Preston
    Lancashire
    British74942750002
    GORDON DUFF, Priscilla Margaret
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    Director
    Kirkton House
    Drummuir
    AB55 3JE Keith
    Banffshire
    KeithBritish47184790001
    GRUNEBAUM, George Peter
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    Director
    352 Mclain Street
    Bedford Hills
    New York 10507
    Usa
    United StatesAmerican96073500001
    HILL, Caroline Elizabeth
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    Director
    Taylors Wynd
    Clocksbriggs
    DD8 2TA Forfar
    Angus
    British1054220001
    HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    Director
    Gatcombe Park
    Hampton Fields, Minchinhampton
    GL6 9AT Stroud
    Gloucestershire
    United KingdomBritish69284900001
    HUNT, Flora Christine Campbell
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    Director
    39 Stratherrick Road
    IV2 4LF Inverness
    Inverness Shire
    British1323300001
    INGLEBY, Moira Frances
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    Director
    Invermarkie
    Glass
    AB54 4XY Huntly
    Aberdeenshire
    British45709310001
    ISMAY CHEAPE, Emma Margaret
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    Director
    Middleton Fossoway
    KY13 6PB Kinross
    British38383690001
    JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    Director
    Spynie Kirk House
    Spynie
    IV30 8XJ Elgin
    Moray
    ScotlandBritish1390490001
    LOCKE, Alasdair James Dougall
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    Director
    Glenrinnes Lodge
    Dufftown
    AB55 4BS Keith
    Banffshire
    Scotland
    United KingdomBritish115457770001
    LUMLEY, Tessa Jocelyn
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    Director
    Flat 4
    10 Westbourne Gardens
    W2 5PU London
    British85182640001
    MACDONALD, Angus Stewart
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    Director
    Torgorm
    Conon Bridge
    IV7 8DN Dingwall
    Ross & Cromarty
    British1220020001
    MARTIN, Hector John Bruce
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    Director
    Windmill Cottage
    38 High Street
    AB38 9QD Aberlour
    Banffshire
    British54403370002
    MATHEWSON, George
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    Director
    Netherfield
    Skye Of Kurr
    PH26 3PA Dulnain Bridge
    Grantown On Spey
    Moray
    British1054210001
    MITCALFE, Alan Hugh
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    Director
    Milton Brodie
    IV36 0UA Forres
    Morayshire
    British8870980001
    MORGAN, Angus
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    Director
    Mount Devon House
    FK14 7PT Dollar
    British1142050001
    NASH, Mark Andrew
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    Director
    54 Harbour Street
    IV30 5RU Hopeman
    Moray
    ScotlandBritish114921310001
    NICHOLSON, John Richard
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    Director
    Romach House
    Dunphail
    IV36 2QR Forres
    Morayshire
    United KingdomBritish1054200007
    NICHOLSON, John Richard
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    Director
    Mayne Lodge
    Mayne
    IV30 3SX Elgin
    Moray
    British1054200001
    OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    Director
    Netherdale House
    AB53 7LE Turriff
    Aberdeenshire
    British45709230001
    ORD, Peter John
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    Director
    Baile Na Coille
    Balmoral
    AB35 5TB Ballater
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish948580002
    RUANE, Richard James
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    Director
    Willow Vale Tradespark Road
    IV12 5NF Nairn
    Nairnshire
    British1293210002
    SABBAN-CLARKE, James Paley
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    Director
    Sandy Hill Farm
    Corfe Castle
    BH20 5JF Wareham
    Dorset
    British89104030001

    ¿Tiene ABERLOUR HOUSE LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Bond & floating charge
    Creado el 11 abr 2002
    Entregado el 30 abr 2002
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 30 abr 2002Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 05 nov 1990
    Entregado el 19 nov 1990
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 19 nov 1990Registro de una carga
    • 10 nov 1993Declaración de que parte o la totalidad de la propiedad de una carga flotante ha sido liberada (419b)
    Floating charge
    Creado el 01 ago 1983
    Entregado el 03 ago 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £75,000 & all further sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transacciones
    • 03 ago 1983Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 25 jul 1983
    Entregado el 29 jul 1983
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £75,000,00
    Breve descripción
    All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others.
    Personas con derecho
    • Gordounstoun Schools LTD
    Transacciones
    • 29 jul 1983Registro de una carga
    Disposition
    Creado el 29 sept 1969
    Entregado el 02 mar 1970
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    £4,000
    Breve descripción
    New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire.
    Personas con derecho
    • Abbey National Building Society
    Transacciones
    • 02 mar 1970Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0