ABERLOUR HOUSE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ABERLOUR HOUSE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC025720 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ABERLOUR HOUSE LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Dirección de la sede social | Gordonstoun School Elgin IV30 5RF Morayshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2012 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ2 | ||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cese del nombramiento de Bryan Peter Williams como director el 03 oct 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Professor Bryan Peter Williams como director el 03 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Se ha suspendido la acción de cancelación obligatoria | 1 páginas | DISS16(SOAS) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria | 1 páginas | GAZ1 | ||
Cese del nombramiento de Hugh Spence Brown como secretario el 16 may 2018 | 2 páginas | TM02 | ||
Cese del nombramiento de Bryan Peter Williams como director el 01 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de John Yeoman como director el 01 jun 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Orden judicial Order of court - dissolution void | 1 páginas | OC-DV | ||
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2012 | 7 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2013, aucune liste de membres fournie | 4 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2011 | 10 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2012, aucune liste de membres fournie | 4 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2010 | 10 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2011, aucune liste de membres fournie | 4 páginas | AR01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2009 | 8 páginas | AA | ||
Déclaration annuelle établie au 19 feb 2010, aucune liste de membres fournie | 3 páginas | AR01 | ||
Cambio de datos del director Mr Bryan Peter Williams el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Mr John Yeoman el 01 mar 2010 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 ago 2008 | 10 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de ABERLOUR HOUSE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARR, George Jefferson | Secretario | Gordonstoun School IV30 2RF Elgin Moray | British | 38294790001 | ||||||
| BROWN, Hugh Spence | Secretario | 13 Beech Brae IV30 4NS Elgin Moray | British | 40872570003 | ||||||
| BROWN, James Ogg, Commander | Secretario | The White House Duffus IV30 2QN Elgin Morayshire | British | 37334700001 | ||||||
| SPENCER, John Robert, Squadron Leader | Secretario | Kilcluan House IV30 8LA Elgin Morayshire | British | 50650460002 | ||||||
| WHITTLE, Colin Douglas Richardson | Secretario | 121 High Street IV36 1AB Forres | British | 536270001 | ||||||
| BUCHANAN, Ewan Craig Barr | Director | Mayne House IV30 3RS Elgin Morayshire | United Kingdom | British | 404330003 | |||||
| CAUNT, Christine Janet | Director | 43 Park Town OX2 6SL Oxford Oxfordshire | British | 5133580001 | ||||||
| DICKINSON, John Joicey | Director | Dipple House IV32 7QA Fochabers Moray | British | 1278160001 | ||||||
| DONALD, Charles | Director | Plow Green Hartley Wespall RG27 0AL Hook Hampshire | England | British | 69189660001 | |||||
| DRUMMOND, Norman | Director | 24 Huntingdon Place EH7 4AX Edinburgh Midlothian | British | 68147030002 | ||||||
| FARQUHARSON, Clodagh | Director | Dallas Lodge IV36 0RY Forres Moray | British | 7047470001 | ||||||
| FERGUSON, James Gordon Dickson | Director | 25 Heriot Row EH3 6EN Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 23960001 | |||||
| FOGDEN, Andrew Mark | Director | Wardsley Farmhouse Leagram Chipping PR3 2QT Preston Lancashire | British | 74942750002 | ||||||
| GORDON DUFF, Priscilla Margaret | Director | Kirkton House Drummuir AB55 3JE Keith Banffshire | Keith | British | 47184790001 | |||||
| GRUNEBAUM, George Peter | Director | 352 Mclain Street Bedford Hills New York 10507 Usa | United States | American | 96073500001 | |||||
| HILL, Caroline Elizabeth | Director | Taylors Wynd Clocksbriggs DD8 2TA Forfar Angus | British | 1054220001 | ||||||
| HRH THE PRINCESS ROYAL, Anne | Director | Gatcombe Park Hampton Fields, Minchinhampton GL6 9AT Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | 69284900001 | |||||
| HUNT, Flora Christine Campbell | Director | 39 Stratherrick Road IV2 4LF Inverness Inverness Shire | British | 1323300001 | ||||||
| INGLEBY, Moira Frances | Director | Invermarkie Glass AB54 4XY Huntly Aberdeenshire | British | 45709310001 | ||||||
| ISMAY CHEAPE, Emma Margaret | Director | Middleton Fossoway KY13 6PB Kinross | British | 38383690001 | ||||||
| JOHNSTON, Grenville Shaw, Lt Colonel | Director | Spynie Kirk House Spynie IV30 8XJ Elgin Moray | Scotland | British | 1390490001 | |||||
| LOCKE, Alasdair James Dougall | Director | Glenrinnes Lodge Dufftown AB55 4BS Keith Banffshire Scotland | United Kingdom | British | 115457770001 | |||||
| LUMLEY, Tessa Jocelyn | Director | Flat 4 10 Westbourne Gardens W2 5PU London | British | 85182640001 | ||||||
| MACDONALD, Angus Stewart | Director | Torgorm Conon Bridge IV7 8DN Dingwall Ross & Cromarty | British | 1220020001 | ||||||
| MARTIN, Hector John Bruce | Director | Windmill Cottage 38 High Street AB38 9QD Aberlour Banffshire | British | 54403370002 | ||||||
| MATHEWSON, George | Director | Netherfield Skye Of Kurr PH26 3PA Dulnain Bridge Grantown On Spey Moray | British | 1054210001 | ||||||
| MITCALFE, Alan Hugh | Director | Milton Brodie IV36 0UA Forres Morayshire | British | 8870980001 | ||||||
| MORGAN, Angus | Director | Mount Devon House FK14 7PT Dollar | British | 1142050001 | ||||||
| NASH, Mark Andrew | Director | 54 Harbour Street IV30 5RU Hopeman Moray | Scotland | British | 114921310001 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Director | Romach House Dunphail IV36 2QR Forres Morayshire | United Kingdom | British | 1054200007 | |||||
| NICHOLSON, John Richard | Director | Mayne Lodge Mayne IV30 3SX Elgin Moray | British | 1054200001 | ||||||
| OLIPHANT, Colin Pilkington Lyle | Director | Netherdale House AB53 7LE Turriff Aberdeenshire | British | 45709230001 | ||||||
| ORD, Peter John | Director | Baile Na Coille Balmoral AB35 5TB Ballater Aberdeenshire | Scotland | British | 948580002 | |||||
| RUANE, Richard James | Director | Willow Vale Tradespark Road IV12 5NF Nairn Nairnshire | British | 1293210002 | ||||||
| SABBAN-CLARKE, James Paley | Director | Sandy Hill Farm Corfe Castle BH20 5JF Wareham Dorset | British | 89104030001 |
¿Tiene ABERLOUR HOUSE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 11 abr 2002 Entregado el 30 abr 2002 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 05 nov 1990 Entregado el 19 nov 1990 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 01 ago 1983 Entregado el 03 ago 1983 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada £75,000 & all further sums due or to become due | |
Breve descripción The whole of the property which is or may from time to time be comprised in the company's property and undertaking. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 25 jul 1983 Entregado el 29 jul 1983 | Pendiente | Cantidad garantizada £75,000,00 | |
Breve descripción All and whole (first) mansion house of aberlour in the county of banff with the offices thereof and ground attached described in disposition by north british hotels limited in favour of aberlour house limited recorded G.R.S. (banff) 1ST april, 1948 excepting therefrom the part thereof being the solum of the railway line and eighteen inches outside the fences bounding same and under exception of (one) all and whole that traingular piece of ground at fisherton, aberlour in the said county described in disposition by aberlour house limited with consent in favour of captain jocelyn slingsby bethell recorded said G.R.S. 27TH march, 1951 (two) all and whole the subjects in the said county described (first) and (second) in disposition by aberlour house limited in favour of the town council of the burgh of charlestown of aberlour recorded said G.R.S. 10TH january, 1962 (three) all and whole the subjects disponed in disposition by aberlour house limited with consent in favour of abbey national building society recorded said G.R.S. 29TH september, 1969 and (four) all and whole the subjects in the said county described (first) (second) (third) and (fourth) in disposition by aberlour house limited with consent in favour of alexander mackay recorded said G.R.S. 4TH march, 1970; together with by way of inclusion rather than exception the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, all trees, shrubs, plants and standing and fallen timber, the teinds and the parts, privileges and pertinents and all and whole (second) that piece of ground lying in the said county described in disposition by aberlour gardens limited in favour of aberlour house limited recorded said G.R.S. 30TH may, 1952; together with the whole buildings and other erections, the fittings and fixtures, the teinds, all trees, shrubs, plants and amenity timber thereon and the parts, privileges and partinents including all rights, servitudes and others. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Disposition | Creado el 29 sept 1969 Entregado el 02 mar 1970 | Pendiente | Cantidad garantizada £4,000 | |
Breve descripción New bungalow in the grounds of aberlour house, aberlour, banffshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0