SC026103 LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSC026103 LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC026103
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SC026103 LIMITED?

    • (3420) /

    ¿Dónde se encuentra SC026103 LIMITED?

    Dirección de la sede social
    4th Floor
    Saltire Court
    EH1 2EN 20 Castle Terrace
    Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SC026103 LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WALTER ALEXANDER & COMPANY (COACHBUILDERS) LIMITED16 feb 194816 feb 1948

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SC026103 LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2002

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SC026103 LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    3 páginasOC-DV

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed walter alexander (falkirk)\certificate issued on 13/05/21
    páginasCERTNM

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    1 páginasOC-DV

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2002

    26 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    Renuncia del auditor

    1 páginasAUD

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de SC026103 LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MAYFLOWER MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    Secretario corporativo
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    97789670001
    MAYFLOWER MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    Director corporativo
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 4TR London
    97789670001
    THE MAYFLOWER CORPORATION PLC
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Director corporativo
    Deloitte & Touche Llp
    Hill House 1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    102132700001
    CHALMERS, Nicholas Oman
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    British1158020002
    GRANT, John Rattray
    38 Laurelhill Place
    FK8 2JJ Stirling
    Stirlingshire
    Secretario
    38 Laurelhill Place
    FK8 2JJ Stirling
    Stirlingshire
    British628900001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Secretario corporativo
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    613080003
    ALEXANDER, Cyril James Turnbull
    Woodside
    FK14 7JX Dollar
    Clackmannanshire
    Director
    Woodside
    FK14 7JX Dollar
    Clackmannanshire
    British181360001
    ALEXANDER, Walter Ronald
    Moonzie Mill
    Balmullo
    KY16 0AH St Andrews
    Fife
    Director
    Moonzie Mill
    Balmullo
    KY16 0AH St Andrews
    Fife
    British177410002
    BARR, Maurice James
    118 Currieside Avenue
    ML7 4AX Shotts
    Lanarkshire
    Director
    118 Currieside Avenue
    ML7 4AX Shotts
    Lanarkshire
    British38165900001
    CAMERON, William
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    Director
    Broompark
    101 Liberton Drive
    EH16 6TH Edinburgh
    British15243740003
    CARDOW, Robert Stuart
    Westhills
    Bowfield Road
    PA9 1BS Howwood
    Renfrewshire
    Director
    Westhills
    Bowfield Road
    PA9 1BS Howwood
    Renfrewshire
    British40276190001
    CHALMERS, Nicholas Oman
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Kenmill House 13 Hamilton Drive
    Bothwell
    G71 8RR Glasgow
    Lanarkshire
    British1158020002
    CHAPMAN, Michael
    93 Broadway
    Duffield
    DE56 4BW Belper
    Derbyshire
    Director
    93 Broadway
    Duffield
    DE56 4BW Belper
    Derbyshire
    British58307070001
    COLE, Alan Jack
    30 Broughton Place
    EH1 3RT Edinburgh
    Director
    30 Broughton Place
    EH1 3RT Edinburgh
    British9811630002
    CRAMB, Raymond Peter
    31 The Bridges
    KY11 9XZ Dalgety Bay
    Fife
    Director
    31 The Bridges
    KY11 9XZ Dalgety Bay
    Fife
    British81978110001
    DONNELLY, David Thomas
    Sherbourne
    Glendene Avenue
    KT24 5AY East Horsley
    Surrey
    Director
    Sherbourne
    Glendene Avenue
    KT24 5AY East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish34478650003
    DUFFIN, Ian Andrew
    Crosswinds
    2 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxon
    Director
    Crosswinds
    2 Orchard Rise
    OX18 4SZ Burford
    Oxon
    British63643820001
    FLEMING, John
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    Director
    Aldern Bridge House
    RG20 4HQ Aldern Bridge
    Berkshire
    British107749800001
    FULTON, Charles Mcmillan
    10 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NY Glasgow
    Director
    10 Stobs Drive
    Barrhead
    G78 1NY Glasgow
    British42783750001
    GALLACHER, John James
    92a Maxwellton Avenue
    East Kilbride
    G74 3DY Glasgow
    Director
    92a Maxwellton Avenue
    East Kilbride
    G74 3DY Glasgow
    British51332140001
    GALLOWAY, Ian William
    Dundarroch
    Lochard Roa
    FK8 3TQ Aberfoyle
    Stirling
    Director
    Dundarroch
    Lochard Roa
    FK8 3TQ Aberfoyle
    Stirling
    British1051370004
    HASTIE, James
    64a Colquhoun Street
    G84 9JP Helensburgh
    Director
    64a Colquhoun Street
    G84 9JP Helensburgh
    ScotlandBritish36987530002
    HODGSON, Clive John Peter
    Locka Oldhall
    Locka Lane Arkholme
    LA6 1BD Carnforth
    Lancashire
    Director
    Locka Oldhall
    Locka Lane Arkholme
    LA6 1BD Carnforth
    Lancashire
    British32698020001
    HUNT, Colin Maxwell
    Twynham
    1 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    Director
    Twynham
    1 Bellenden Grove
    FK15 0FD Dunblane
    Perthshire
    British63787560001
    KERR, Ian William
    42 Redding Road
    Laurieston
    FK2 9JU Falkirk
    Director
    42 Redding Road
    Laurieston
    FK2 9JU Falkirk
    British38447970001
    KEYS, William Wesley
    The Pines
    FK14 7AE Dollar
    Director
    The Pines
    FK14 7AE Dollar
    British628910001
    LAWRENCE, John Malcolm
    The Paddock Second Drift
    Wothorpe
    PE9 3JH Stamford
    Lincolnshire
    Director
    The Paddock Second Drift
    Wothorpe
    PE9 3JH Stamford
    Lincolnshire
    British1271680001
    MARTIN, David Stuart
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    Director
    2 Spylaw Avenue
    EH13 0LR Edinburgh
    Midlothian
    British70256380001
    MATHIESON, Malcolm
    16 Bonnyview Gardens
    FK4 1PW Bonnybridge
    Stirlingshire
    Director
    16 Bonnyview Gardens
    FK4 1PW Bonnybridge
    Stirlingshire
    ScotlandBritish59765780001
    MCGAUGHEY, Goodlet William Nigel
    Dripend Farm
    FK9 4UJ Stirling
    Stirlingshire
    Director
    Dripend Farm
    FK9 4UJ Stirling
    Stirlingshire
    British67292900001
    MCLEAN, Ross
    51 Ewenfield Avenue
    KA7 2QL Ayr
    Ayrshire
    Director
    51 Ewenfield Avenue
    KA7 2QL Ayr
    Ayrshire
    British74820480001
    PITKIN, Frank John
    10b Fort End
    HP17 8EJ Haddenham
    Buckinghamshire
    Director
    10b Fort End
    HP17 8EJ Haddenham
    Buckinghamshire
    EnglandBritish87977780001
    RHODES, Glenn Martin
    26 Forth Crescent
    FK8 1LG Stirling
    Director
    26 Forth Crescent
    FK8 1LG Stirling
    British38165730002
    SIMPSON, John William Peter
    Portnall Hill
    Portnall Drive Wentworth
    GU25 4NW Virginia Water
    Surrey
    Director
    Portnall Hill
    Portnall Drive Wentworth
    GU25 4NW Virginia Water
    Surrey
    British36520000001
    STEWART, James Roy
    2 Balmore Court
    PA13 4LX Kilmacolm
    Renfrewshire
    Director
    2 Balmore Court
    PA13 4LX Kilmacolm
    Renfrewshire
    ScotlandBritish68035790001

    ¿Tiene SC026103 LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 11 jun 1993
    Entregado el 29 jun 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    91 glasgow road falkirk.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 29 jun 1993Registro de un cargo (410)
    • 09 dic 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 01 abr 1992
    Entregado el 10 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    91 glasgow road, camelon, falkirk.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 10 abr 1992Registro de un cargo (410)
    • 16 abr 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 27 mar 1992
    Entregado el 02 abr 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 02 abr 1992Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 20 dic 1991
    Entregado el 03 ene 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 ene 1992Registro de una carga
    • 16 abr 1992Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 19 jun 1990
    Entregado el 29 jun 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Those areas of ground extending to: (1) 0.130 acre (2) 4 acres 2 roods 16 poles 26 sq. Yards (but excepting 0.068 acre and 85.12 sq. Yards therefrom) (3) (I) 7 acres (but excepting 0.162 acre therefrom) (ii) 28 poles (but excepting 0.175 acre therefrom) (4) 2 acres 25 poles (5) 1.1 acre and (6) 0.43 acre, in falkirk, stirling.
    Personas con derecho
    • Security Pacific National Bank
    Transacciones
    • 29 jun 1990Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 13 jun 1990
    Entregado el 03 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Security Pacific National Bank
    Transacciones
    • 03 jul 1990Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0