THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC026752 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
- Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (11010) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 6 St Andrew Square Level 4 EH2 2BD Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLENMORANGIE PUBLIC LIMITED COMPANY | 29 abr 1996 | 29 abr 1996 |
| MACDONALD MARTIN DISTILLERIES PUBLIC LIMITED COMPANY | 30 dic 1948 | 30 dic 1948 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 25 jul 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 11 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Jonas Tahlin como director el 30 dic 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Eleanor Anne Mary Stanley como director el 01 ago 2025 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 25 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Peter Jonathon Nelson como director el 01 abr 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Cube 45 Leith Street Edinburgh EH1 3AT a 6 st Andrew Square Level 4 Edinburgh EH2 2BD el 14 abr 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 25 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Caspar Alexander Macrae como director el 03 jul 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Thomas Jean Moradpour como director el 03 jul 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Jonas Tahlin como director el 01 oct 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Nauman Saleem Hasan como director el 01 oct 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021 | 24 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Marie Bernadou como director el 01 jul 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Jean-Marc Rene Boulan como director el 01 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020 | 23 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Richard Spencer Yeomans como director el 01 ene 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019 | 21 páginas | AA | ||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 21 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 11 jul 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BERNADOU, Marie | Director | St Andrew Square Level 4 EH2 2BD Edinburgh 6 Scotland | France | French | 298226580001 | |||||
| MACRAE, Caspar Alexander | Director | St Andrew Square Level 4 EH2 2BD Edinburgh 6 Scotland | Scotland | British | 311243700001 | |||||
| STANLEY, Eleanor Anne Mary | Director | St Andrew Square Level 4 EH2 2BD Edinburgh 6 Scotland | Scotland | British | 339130190001 | |||||
| CULLEN, Peter Beszant | Secretario | 41 Cammo Grove EH4 8HD Edinburgh Midlothian | British | 572670001 | ||||||
| FLEMING, Martha Jayne | Secretario | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | British | 105635740001 | ||||||
| MACDONALD, Alison Erica | Secretario | 7 Scotland Street Lane West EH3 6PT Edinburgh | British | 40293500003 | ||||||
| BOULAN, Jean-Marc Rene | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube | Scotland | French | 230554870001 | |||||
| BUCHANAN, Eric David | Director | 1 Succoth Place EH12 6BJ Edinburgh | British | 142100002 | ||||||
| BURNET, Anthony John | Director | Broomfield House Garvald EH41 4LN Haddington East Lothian | British | 574760001 | ||||||
| BURNETT-STUART, Joseph | Director | Ardmeallie House AB54 5RS Huntly Aberdeenshire | British | 1410250001 | ||||||
| CAMPBELL, Colin Archibald Alexander Forbes | Director | C/O Moet Hennessy 22 Avenue Montaigne FOREIGN 75008 Paris France | British | 28565360001 | ||||||
| CHEEK, Michael Verdon | Director | 1022 Barcamil Way 34110 Naples Florida Usa | American | 70633180002 | ||||||
| CULLEN, Peter Beszant | Director | Larchfield 32 Barnton Avenue West EH4 6DE Edinburgh | British | 572670002 | ||||||
| DARBYSHIRE, Peter Michael Arvor | Director | Meadowwells Farm House Ladybank KY15 7UY Cupar Fife | British | 60123450003 | ||||||
| EDELMAN, Keith Graeme | Director | "Laurimar" 7 Linksway HA6 2XA Northwood Middlesex | England | British | 34519430003 | |||||
| ERLANGER, Simon David | Director | 87 Colinton Road EH10 5DF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 38816480002 | |||||
| FLEMING, Martha Jayne | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | United Kingdom | British | 140771110002 | |||||
| FYFE, James Hood | Director | 58 Broomfield Avenue Newton Mearns G77 5JP Glasgow Lanarkshire | British | 566170001 | ||||||
| GALLOT, Jean-Marc Francois Nicolas | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | France | French | 187346650001 | |||||
| HAMILTON, Iain Lindsay | Director | Ayr Road Lower Whitecraigs G46 6RX Glasgow 10 | Scotland | British | 50906940006 | |||||
| HASAN, Nauman Saleem | Director | c/o Moet Hennessy Services Uk Grosvenor Gardens SW1W 0DH London 12 - 18 England | England | British | 221250820001 | |||||
| HENNESSY, Gilles Marie Kilian | Director | 7 Bis Rue Lalo Paris FOREIGN France 75116 | France | France | 67426350001 | |||||
| HOELLINGER, Marc | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | Scotland | French | 184935750002 | |||||
| HOUEL, Patrick Gaston | Director | 10 Avenue Frederic Le Play FOREIGN Paris 75007 France | France | French | 102678950001 | |||||
| JENSEN, Peter Sinclair | Director | 60 Kew Green Kew TW9 3AP Richmond Upon Thames Surrey | England | British | 53890090002 | |||||
| KNOX, Lesley Mary Samuel | Director | Maidenhead Road SL4 5GD Windsor Millstream Berkshire | United Kingdom | British | 165715660002 | |||||
| MACDONALD, David William Alexander | Director | 66 Barnton Park View EH4 6HJ Edinburgh Midlothian | British | 374930001 | ||||||
| MADDRELL, Geoffrey Keggen | Director | 28 Sussex Street SW1V 4RL London | United Kingdom | British | 17150180001 | |||||
| MCKERROW, Neil Alexander Herdman | Director | Guldrey Lodge Malim Lodge Station Road LA10 5RY Sedbergh Cumbria | British | 55583810002 | ||||||
| MORADPOUR, Thomas Jean | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube | Scotland | French | 250713690001 | |||||
| NAVARRE, Christophe Vincent | Director | 5 Boulevard Richard Wallace 92000 Neuilly Sur Seine France | France | Belgium | 104156790001 | |||||
| NEEP, Paul Anthony | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | Scotland | British | 51414620004 | |||||
| NELSON, Peter Jonathon, Dr | Director | St Andrew Square Level 4 EH2 2BD Edinburgh 6 Scotland | Scotland | British | 74012890002 | |||||
| PENOT, Guillaume Marie Maurice | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube Scotland | France | French | 112499580001 | |||||
| PIETRINI, Hugues Michel | Director | 45 Leith Street EH1 3AT Edinburgh The Cube | England | French | 185593460003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE GLENMORANGIE COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diageo Plc | 06 abr 2016 | Park Royal NW10 7HQ London Lakeside Drive England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se | 06 abr 2016 | Avenue Montaigne 75008 Paris 22 France | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0