ALLIED DISTILLERS LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | ALLIED DISTILLERS LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC026753 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de ALLIED DISTILLERS LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Dirección de la sede social | Kilmalid Stirling Road G82 2SS Dumbarton Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| TEACHER (DISTILLERS) LIMITED | 30 dic 1948 | 30 dic 1948 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Edward Fells como director el 28 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2024 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 30 sept 2024 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2023 | 1 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2022 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 19 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Stuart Macnab como director el 31 mar 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2021 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 01 sept 2021 | 2 páginas | CH01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 jun 2020 | 1 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Edward Fells el 07 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Scott Livingstone como director el 08 dic 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Edward Fells como director el 01 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Vincent Turpin como director el 30 sept 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 31 ago 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 06 abr 2016 | 2 páginas | PSC05 | ||
Modification des détails de Allied Domecq Spirits & Wine Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 jul 2020 | 2 páginas | PSC05 | ||
Domicilio social registrado cambiado de , 111-113 Renfrew Road, Paisley, PA3 4DY a Kilmalid Stirling Road Dumbarton G82 2SS el 01 jul 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Cambio de datos del director Mr Stuart Macnab el 13 may 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cambio de datos del director Catherine Louise Thompson el 10 ene 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
¿Quiénes son los directivos de ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMILEY, Alexander Hugh | Secretario | Stirling Road G82 2SS Dumbarton Kilmalid Scotland | 258908670001 | |||||||
| MCKECHNIE, Stuart Andrew Ferrie | Director | Stirling Road G82 2SS Dumbarton Kilmalid Scotland | Scotland | British | 264144930001 | |||||
| THOMPSON, Catherine Louise | Director | Stirling Road G82 2SS Dumbarton Kilmalid Scotland | France | Australian | 258897310003 | |||||
| ARTIS, Iain Norris James | Secretario | Urchinwood Manor Cottage Wrington Road, Congresbury BS19 5AR Bristol Avon | British | 46141510003 | ||||||
| BROWN, Charles Bennett | Secretario | The Old Library High Street BS40 5QA Wrington Bristol Avon | British | 107840600001 | ||||||
| EGAN, Jane | Secretario | 11 Mccrorie Place PA10 2BF Kilbarchan Renfrewshire | British | 112277750001 | ||||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Secretario | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | 116030190001 | ||||||
| HOWARD, Martin John | Secretario | Friary Cottage Witham Friary BA11 5HD Frome Somerset | British | 467110001 | ||||||
| MACNAB, Stuart | Secretario | 6 Station Rise PA12 4NA Lochwinnoch Renfrewshire | British | 77024740001 | ||||||
| MAINS, Thomas Gordon | Secretario | The Meadows Duck Lane BA5 1EZ Westbury-Sub-Mendip Somerset | British | 46135720001 | ||||||
| MAPPLEBECK, Ailsa Mary Robertson | Secretario | Renfrew Road PA3 4DY Paisley 111-113 | British | 158572350001 | ||||||
| MONTGOMERY, John Sibbald | Secretario | Gordon Avenue Netherlee G44 3TR Glasgow 2 | British | 29914850001 | ||||||
| TOMLINSON, John Michael | Secretario | 11 Selwood Crescent BA11 2HX Frome Somerset | British | 1356620001 | ||||||
| WOOTERS, Joseph Michael | Secretario | Denny House Knowle Hill Farm Knowle Hill Chew Magna BS18 8TE Bristol Avon | American | 40378020001 | ||||||
| BABEAU, Emmanuel Andre Marie | Director | 7 Rue Paul Chatrousse, 92200 Neuilly Sur Seine France | French | 107414890001 | ||||||
| BEATTY, David | Director | Swangles Cold Christmas Thundridge SG12 7SP Ware Herts | British | 709400001 | ||||||
| BECKERLEG, John Clifton | Director | 27 Bushy Park Gardens TW11 0LQ Teddington Middlesex | British | 13642030002 | ||||||
| BROWN, Ian Alexander | Director | 10 Calderwood Road KA13 7DR Kilwinning Ayrshire | British | 657450001 | ||||||
| BUTTERWORTH, Mark | Director | 50 Kelvin Court G12 0AE Glasgow | British | 10066840002 | ||||||
| CORRIGAN, John | Director | 11a Upper Glenburn Road Bearsden G61 4BW Glasgow | British | 54748240001 | ||||||
| COWMAN, John Michael | Director | Sheldrake Bellwood Park PH2 7AJ Perth Perthshire Scotland | British | 473110002 | ||||||
| COWMAN, John Michael | Director | Sheldrake Bellwood Park PH2 7AJ Perth Perthshire Scotland | British | 473110002 | ||||||
| CUNNINGHAM, Alistair Archibald | Director | 4 Kennedy Drive G84 9LT Helensburgh Dunbartonshire | British | 42899840001 | ||||||
| DEGG, Christopher Thomas Hardcastle | Director | 10 Cattermills Croftamie G63 0BB Drymen Glasgow | United Kingdom | British | 80606580002 | |||||
| DEWAR-DURIE, Andrew Maule | Director | Finnich Malise G63 0HA Croftamie Stirlingshire | Scotland | British | 73128130001 | |||||
| EVANS, David John | Director | Pennyfield Hacketts Lane Pyrford GU22 8PJ Woking Surrey | British | 43103010001 | ||||||
| FELLS, Edward | Director | Stirling Road G82 2SS Dumbarton Kilmalid Scotland | United Kingdom | British | 274854930003 | |||||
| FETTER, Herve Denis Michel | Director | Spear Mews SW5 9NA London 6 | England | French | 133848930001 | |||||
| FILLINGHAM, Derrick John | Director | Holmlea Station Road PH2 7SN Errol Perthshire | British | 374940002 | ||||||
| FITZSIMONS, Ian Terence | Director | 5 Rue Gounod, 75017 Paris | British | 116030190001 | ||||||
| GAYNOR, Donard Patrick Thomas | Director | 7 Swans Mill Lane Scotch Plains FOREIGN New Jersey 07076 Usa | Usa | United States | 107540910001 | |||||
| GILLON, Patrick L'Estrange | Director | 12 Chapelacre Grove Helensburgh Dunbartonshire | British | 469830002 | ||||||
| GOURLAY, Ian | Director | Westfield 101 The Lynch BS25 1AR Winscombe Avon | British | 104963710001 | ||||||
| GOURLAY, Ian | Director | 2 Castle Gardens Buchanan Castle Estate Drymen G63 0HX Glasgow | British | 45583640002 | ||||||
| GREALEY, Martyn | Director | Rowington House Pound Close Off Poolhead Lane B94 5ET Earlswood Warwickshire | United Kingdom | British | 125401590001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de ALLIED DISTILLERS LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allied Domecq Spirits & Wine Limited | 06 abr 2016 | Montford Place Kennington SE11 5DE London 20 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0