BIKECLOUD LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Declaración anual
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBIKECLOUD LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC027672
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BIKECLOUD LIMITED?

    • Fabricación de instrumentos y suministros médicos y dentales (32500) / Industrias manufactureras

    ¿Dónde se encuentra BIKECLOUD LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Lomond House
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BIKECLOUD LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WALLACE, CAMERON & COMPANY LIMITED25 abr 195025 abr 1950

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BIKECLOUD LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuál es el estado de la última declaración anual para BIKECLOUD LIMITED?

    Declaración anual
    Última declaración anual

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BIKECLOUD LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Aviso de reunión final de acreedores

    16 páginas4.17(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de * 26 Netherhall Road Netherton Industrial Est Wishaw Lanarkshire ML2 0JG* el 01 ago 2013

    2 páginasAD01

    Aviso de orden judicial de liquidación

    1 páginasCO4.2(Scot)

    Notificación de la orden de liquidación

    1 páginas4.2(Scot)

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed wallace, cameron & company LIMITED\certificate issued on 29/05/13
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    29 may 2013

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 24 may 2013

    RES15

    Memorándum y Estatutos

    30 páginasMEM/ARTS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución del Memorándum de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Mr Giovanni Benedetti como secretario

    1 páginasAP03

    Cese del nombramiento de Andrew Palmer como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Andrew Palmer como secretario

    1 páginasTM02

    legacy

    3 páginasMG03s

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    23 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital12 jun 2012

    Estado de capital el 12 jun 2012

    • Capital: GBP 1,856,766
    SH01

    legacy

    3 páginasMG03s

    Cese del nombramiento de Paul Anderson como director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Mallard como director

    2 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Ian Mallard como secretario

    2 páginasTM02

    Nombramiento de Andrew Palmer como secretario

    3 páginasAP03

    Nombramiento de Andrew Palmer como director

    3 páginasAP01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Graeme Carruthers como director

    2 páginasTM01

    legacy

    5 páginasMG01s

    Déclaration annuelle établie au 07 jun 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de BIKECLOUD LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BENEDETTI, Giovanni
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    Secretario
    9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Lomond House
    175991450001
    BENEDETTI, Giovanni
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    Director
    21 Overton Drive
    KA23 9LQ West Kilbride
    Strathclyde
    United KingdomItalian90520001
    LENNOX, Alexander Craig
    2 Dunmore Drive
    Milngavie
    G62 6NZ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    Secretario
    2 Dunmore Drive
    Milngavie
    G62 6NZ Glasgow
    Strathclyde
    Scotland
    British47685000001
    MALLARD, Ian
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    Secretario
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    British146386340001
    PALMER, Andrew
    Borland Road
    G61 2ND Bearsden
    37
    Secretario
    Borland Road
    G61 2ND Bearsden
    37
    British163906450001
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Secretario
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    British53458580003
    ANDERSON, Paul
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Scotland United Kingdom
    Director
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Scotland United Kingdom
    ScotlandBritish160040730001
    CARRUTHERS, Graeme Frank Hamilton
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    Wallace Ameron & Co Ltd
    Director
    26 Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    Wallace Ameron & Co Ltd
    ScotlandBritish147817050001
    CLARK, Michael David
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    Director
    31 Cheviot Crescent
    G75 9GG East Kilbride
    Lanarkshire
    British111876120001
    CRANSTON, Charles Johnstone
    Heathland 85 Woolsbridge Road
    Ashley Heath
    BH24 2LY Ringwood
    Hampshire
    Director
    Heathland 85 Woolsbridge Road
    Ashley Heath
    BH24 2LY Ringwood
    Hampshire
    British1322560003
    DENHURST, Mark
    Millhill Crescent
    FK15 0LH Greenloaning
    8
    Perthshire
    Director
    Millhill Crescent
    FK15 0LH Greenloaning
    8
    Perthshire
    British130744440001
    FRYER, Alan Richmond
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    Director
    Hampton Barn
    Snitterfield Road
    CV35 8AU Hampton Lucy
    Warwickshire
    British9290001
    HOLBROOK, Paul
    Oak Cottage
    School Lane, Burwardsley
    CH3 9NX Chester
    Cheshire
    Director
    Oak Cottage
    School Lane, Burwardsley
    CH3 9NX Chester
    Cheshire
    United KingdomBritish151168180001
    HUGHES, Adrian John David
    29 Wakehurst Drive
    NN4 0TN Northampton
    Northamptonshire
    Director
    29 Wakehurst Drive
    NN4 0TN Northampton
    Northamptonshire
    United KingdomBritish67694050001
    JACK, Sheena Buchanan
    Nursery Drive
    Dalgarven Meadows
    KA13 6EL Kilwinning
    28
    Director
    Nursery Drive
    Dalgarven Meadows
    KA13 6EL Kilwinning
    28
    ScotlandBritish161099050001
    KEMP, Kenneth Reginald
    29 Batchelors Way
    HP7 9AH Amersham
    Buckinghamshire
    Director
    29 Batchelors Way
    HP7 9AH Amersham
    Buckinghamshire
    British28260001
    LAURI, Toomas Rein
    32 Avenue De Miremont
    1206
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    Director
    32 Avenue De Miremont
    1206
    FOREIGN Geneva
    Switzerland
    Swedish1128790001
    MACKAY, Ian Duncan
    Glenairthrey
    12 Upper Glen Road
    FK9 4PX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    Director
    Glenairthrey
    12 Upper Glen Road
    FK9 4PX Bridge Of Allan
    Stirlingshire
    British74583500001
    MALLARD, Ian
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    Director
    Skaterigg Drive
    G13 1SR Glasgow
    25
    UkBritish146386250001
    MCCORMICK, John Robert
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    Director
    17 Wellknowe Place
    Thorntonhall
    G74 5QA Glasgow
    ScotlandBritish82210090001
    NEILSON, Iain Macarthur Blackadder
    30 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    30 Woodvale Avenue
    Giffnock
    G46 6RQ Glasgow
    Lanarkshire
    British9280001
    OWENS, Anthony
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    Director
    41 Beltonfoot Way
    ML2 0GA Wishaw
    North Lanarkshire
    ScotlandBritish86285020002
    PALMER, Andrew Grant Dougal
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    Director
    Netherhall Road
    Netherton Industrial Estate
    ML2 0JG Wishaw
    26
    ScotlandBritish176138150001
    PITTMAN, Philip John
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    2 Craigievar Place
    West Acres, Newton Mearns
    G77 6YE Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish115658830001
    REILLY, Brennan Michael
    17 Glenpark Avenue
    Thornliebank
    G46 7JE Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    17 Glenpark Avenue
    Thornliebank
    G46 7JE Glasgow
    Lanarkshire
    British52482110002
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Director
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    United KingdomBritish53458580003
    WILSON, Kenneth
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    Director
    343 Glasgow Road
    Waterfoot
    G76 0ER Glasgow
    United KingdomBritish53458580003

    ¿Tiene BIKECLOUD LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 13 jun 2011
    Entregado el 17 jun 2011
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 17 jun 2011Registro de un cargo (MG01s)
    Floating charge
    Creado el 28 jul 2010
    Entregado el 03 ago 2010
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank PLC
    Transacciones
    • 03 ago 2010Registro de un cargo (MG01s)
    Bond & floating charge
    Creado el 31 ene 2008
    Entregado el 06 feb 2008
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Scotland PLC
    Transacciones
    • 06 feb 2008Registro de un cargo (410)
    • 04 may 2012Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 21 dic 2007
    Entregado el 22 dic 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transacciones
    • 22 dic 2007Registro de un cargo (410)
    • 11 ene 2013Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Bond & floating charge
    Creado el 06 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I Group PLC
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (410)
    • 22 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 15 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 14 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 12 feb 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 06 oct 1999
    Entregado el 19 oct 1999
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Giovanni Benedetti
    Transacciones
    • 19 oct 1999Registro de un cargo (410)
    • 19 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 15 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 06 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 15 ene 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 21 oct 1993
    Entregado el 26 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The property known as all and whole the tenants' interest under the lease of the property known as ultra house, drakemire drive, castlemilk, glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 oct 1993Registro de un cargo (410)
    • 12 oct 2000Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • 19 dic 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 19 oct 1993
    Entregado el 27 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 oct 1993Registro de un cargo (410)
    • 25 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 20 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 19 oct 1993
    Entregado el 26 oct 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 26 oct 1993Registro de un cargo (410)
    • 25 oct 1999Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 20 dic 2000Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 oct 2003Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 13 nov 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    ¿Tiene BIKECLOUD LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    01 abr 2015Conclusión de la liquidación
    19 jul 2013Fecha de la petición
    19 jul 2013Inicio de la liquidación
    02 jul 2015Fecha de disolución
    Liquidación forzosa
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Christopher Nigel Mckay
    Lomond House, 9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    Profesional
    Lomond House, 9 George Square
    G2 1QQ Glasgow
    John Charles Reid
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Profesional
    Deloitte Llp
    Lomond House, 9
    G2 1QQ George Square
    Glasgow
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0