EAST EDINBURGH LIMITED

EAST EDINBURGH LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaEAST EDINBURGH LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC028093
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de EAST EDINBURGH LIMITED?

    • Desarrollo de proyectos de construcción (41100) / Construcción

    ¿Dónde se encuentra EAST EDINBURGH LIMITED?

    Dirección de la sede social
    15 Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de EAST EDINBURGH LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    WALTONS HERITABLE ASSETS LIMITED03 ene 195103 ene 1951

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de EAST EDINBURGH LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para EAST EDINBURGH LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cancelación total de la carga 6

    6 páginasMR04

    Estado de capital el 02 jul 2013

    • Capital: GBP 101.00
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    legacy

    1 páginasSH20

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 24 abr 2013

    • Capital: GBP 101.00
    4 páginasSH01

    Déclaration annuelle établie au 08 dic 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Resoluciones

    Resolutions
    31 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2011

    11 páginasAA

    Cese del nombramiento de Thomas Marfleet como director el 02 jul 2012

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr Graham Frederick Boyd Palmer como director el 02 jul 2012

    2 páginasAP01

    Cambio de datos del director Mr Thomas Marfleet el 18 may 2012

    2 páginasCH01

    Cambio de datos del secretario Stephen Roy Slocombe el 15 may 2012

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director Mr Stephen Roy Slocombe el 15 may 2012

    2 páginasCH01

    Déclaration annuelle établie au 08 dic 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Nombramiento de Mr Stephen Roy Slocombe como director el 03 oct 2011

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ilaria Jane Del Beato como director el 03 oct 2011

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Manuel Uria Fernandez como director

    1 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2010

    11 páginasAA

    Nombramiento de Ms Ilaria Jane Del Beato como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Ian Gatiss como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 08 dic 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    ¿Quiénes son los directivos de EAST EDINBURGH LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Secretario
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    British55097590003
    PALMER, Graham Frederick Boyd
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish170304850001
    SLOCOMBE, Stephen Roy
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomEnglish151593900001
    BAMBER, Janine Margaret
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    Secretario
    Flat 16 St Pauls View
    15 Amwell Street
    EC1R 1UP London
    British117898690001
    BEWSEY, Martin Roy
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    Secretario
    16 Hawthorne Road
    BR1 2HH Bromley
    Kent
    British88472130001
    BROWN, David Allan
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    Secretario
    Royal Exchange House 100 Queen Street
    G1 3DL Glasgow
    British37710002
    BROWN, Grace
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    Secretario
    35 Corringham Road
    Wembley Park
    HA9 9PX Wembley
    Middlesex
    British102074060001
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Secretario
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    PARSONS-WEISS, Beatrix
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    Secretario
    Meadow Cottage
    Hawksfold Lane
    GU27 3JW Fernhurst
    Surrey
    German93618170002
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Secretario
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    ABRAMSON, Christoffer
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Director
    59 Queen Anne Street
    W1G 9JS London
    Swedish98463110004
    BARTRAM, Christopher John
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    Director
    15 Trumpington Road
    CB2 2AJ Cambridge
    EnglandBritish38758710002
    BOTHA, Stephanie
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    Director
    5 Highbridge Wharf
    Highbridge
    SE10 9PS London
    American116663740001
    CAIRNS, James Scott
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    Director
    2 Springfield Grange
    Blackness Road
    EH49 7HA Linlithgow
    West Lothian
    British33041530001
    CASEY, Shay Andrew
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    Director
    Flat 3 St Mary Hall
    106 Felsham Road
    SW15 1DQ London
    United KingdomIrish90824990003
    DEBNEY, Richard Johnathon
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    Director
    81 Manor Way
    Blackheath
    SE3 9XG London
    EnglandBritish59232720003
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomBritish93124450002
    DEL BEATO, Ilaria Jane
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    Director
    33 Gorst Road
    Battersea
    SW11 6JB London
    United KingdomBritish93124450002
    FELCE, Gary John
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    Director
    25 Ickwell Road
    Northill
    SG18 9AB Biggleswade
    Bedfordshire
    EnglandBritish107819460001
    GATISS, Ian William
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritish95094220003
    HARRIS, Neil Jason
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    Director
    Pattison Lane
    Woolstone
    MK15 0AU Milton Keynes
    11
    Buckinghamshire
    EnglandBritish94095660004
    KEARLEY, Andrew Paul
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    Director
    12 Fiddicroft Avenue
    SM7 3AD Banstead
    Surrey
    British26039210001
    LEE, David Robert
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    Director
    139 Ascot Crescent
    SG1 5SX Stevenage
    Hertfordshire
    British76032910001
    LEWIS, Martyn Phillips
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    Director
    Wyncroft
    Ringmore
    TQ7 4HL Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritish96177720001
    MARFLEET, Thomas
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    Director
    Atholl Crescent
    EH3 8HA Edinburgh
    15
    United KingdomBritish139855250001
    MILNE, Gordon Stewart
    5 Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DQ Edinburgh
    Director
    5 Woodhall Road
    Colinton
    EH13 0DQ Edinburgh
    British39048480001
    PEARSON, William James
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    Director
    Graham Road
    Wimbledon
    SW19 3SL London
    171
    United KingdomBritish133539850001
    THOMSON, Alan Herbert
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    Director
    South Hill Of Dripps Cottage
    Thorntonhall
    G74 5AW Glasgow
    British293000001
    URIA FERNANDEZ, Manuel
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Director
    201 Talgarth Road
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    United KingdomSpanish123133150001
    WALTON, David
    4 Methven Road
    Whitecraigs
    G46 6TG Glasgow
    Strathclyde
    Director
    4 Methven Road
    Whitecraigs
    G46 6TG Glasgow
    Strathclyde
    ScotlandBritish37720001

    ¿Tiene EAST EDINBURGH LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 17 mar 1998
    Entregado el 23 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    2 pieces of ground known as the railway field, edinburgh, midlothian.
    Personas con derecho
    • James Andrew Wauchope and Another
    Transacciones
    • 23 mar 1998Registro de un cargo (410)
    • 27 sept 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Standard security
    Creado el 17 mar 1998
    Entregado el 20 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The railway field,newcraighall,edinburgh.
    Personas con derecho
    • The Scottish Metropolitan Property PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1998Registro de un cargo (410)
    • 10 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 12 mar 1998
    Entregado el 20 mar 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Scottish Metropolitan Property PLC
    Transacciones
    • 20 mar 1998Registro de un cargo (410)
    • 20 mar 1998Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 10 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Bond & floating charge
    Creado el 04 oct 1991
    Entregado el 22 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Scottish Metropolitan Property PLC
    Transacciones
    • 22 oct 1991Registro de una carga
    • 12 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 04 oct 1991
    Entregado el 18 oct 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • As Trustee
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 18 oct 1991Registro de una carga
    • 12 ene 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 17 ago 1984
    Entregado el 23 ago 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £1 1/4 6.3/8% first mortgage debenture stock 1988/93 of the scottish metropolitan property PLC and all further sums due or to become due
    Breve descripción
    102/106 quarry street, hamilton, lanarkshire.
    Personas con derecho
    • Guardian Assurance PLC as Trustees
    Transacciones
    • 23 ago 1984Registro de una carga
    • 10 oct 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0