JOHN WOOD GROUP PLC
Visión general
| Nombre de la empresa | JOHN WOOD GROUP PLC |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad anónima cotizada |
| Número de empresa | SC036219 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JOHN WOOD GROUP PLC?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JOHN WOOD GROUP PLC?
| Dirección de la sede social | Sir Ian Wood House Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHN WOOD GROUP PLC?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para JOHN WOOD GROUP PLC?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 31 jul 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 14 ago 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 31 jul 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHN WOOD GROUP PLC?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 270 páginas | AA | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 5 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190014, creada el 03 dic 2025 | 29 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190012, creada el 03 dic 2025 | 46 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190013, creada el 03 dic 2025 | 30 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190011, creada el 03 dic 2025 | 54 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga SC0362190009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga SC0362190008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Cancelación total de la carga SC0362190010 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 61 páginas | MA | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Adrian Marsh como director el 18 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Brenda Reichelderfer como director el 18 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Kenneth Gilmartin como director el 18 nov 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Kenneth Gilmartin el 18 abr 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190009, creada el 05 sept 2025 | 29 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190010, creada el 05 sept 2025 | 28 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190008, creada el 05 sept 2025 | 52 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Registro de la carga SC0362190007, creada el 13 ago 2025 | 10 páginas | MR01 | ||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 jul 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||
Nombramiento de Paul Philip O’Donnell como director el 28 jul 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 4 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Catherine Elisa Michel como director el 18 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Susan Steele como director el 18 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de David Charles Lockwood como director el 18 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JOHN WOOD GROUP PLC?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HABGOOD, John Alan | Secretario | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | 329975180001 | |||||||
| BRINCH MADSEN, Birgitte | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Denmark | Danish | 267778430001 | |||||
| FRANKLIN, Roy Alexander | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 238790650001 | |||||
| MILLS, Nigel Gordon | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 28385060001 | |||||
| O’DONNELL, Paul Philip | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Ireland | Irish | 338946490001 | |||||
| TORRENS, Iain William | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 120015110002 | |||||
| BROWN, Charles Nicholas | Secretario | Stoneyards Farm Menie By Balmedie AB41 0YJ Aberdeen Grampian | British | 36752260001 | ||||||
| BROWN, Robert Muirhead Birnie | Secretario | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | 153923500001 | |||||||
| GOOD, Graham | Secretario | 22 Gladstone Place AB10 6XA Aberdeen | British | 57781370001 | ||||||
| JOHNSON, Ian | Secretario | John Wood House Greenwell Road AB12 3AX East Tullos Aberdeen | British | 102664100004 | ||||||
| MCINTYRE, Martin James | Secretario | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | 241416090001 | |||||||
| RASMUSON, Michael | Secretario | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | 324697330001 | |||||||
| SETTER, William George | Secretario | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | British | 147116630002 | ||||||
| WATSON, Christopher Edward Milne | Secretario | 77 Fountainhall Road AB15 4EA Aberdeen | British | 60315030001 | ||||||
| ADAMANY, Linda Louise | Director | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | United States | American | 238789200001 | |||||
| BALAN, Arvind Philip | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 321877490001 | |||||
| BOTTS, Thomas | Director | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | United States | American | 174825760002 | |||||
| BRILL-EDWARDS, Harry | Director | 1100 Arcadian Way Fortlee New Jersey 07024 Usa | American | 73217080001 | ||||||
| BROOKS, Wendell | Director | 23203 Meadow Cross Lane Katy 77494 Texas | American | 62342650002 | ||||||
| BROWN, Ewan | Director | Brucenocke 9 Belmont Drive EH12 6JW Edinburgh | United Kingdom | British | 63394750003 | |||||
| BROWN, Janice Margaret | Director | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | 117048670002 | |||||
| CARR, William Hadden | Director | Collieston Hall AB41 8RS Collieston Aberdeenshire | British | 100270001 | ||||||
| CONTIE, Michel Jean Marcel, Mr. | Director | John Wood House Greenwell Road AB12 3AX East Tullos Aberdeen | France | French | 70625610003 | |||||
| COOPER, James | Director | 7 Kirkstyle Avenue ML8 5AQ Carluke Lanarkshire | Scotland | British | 929150002 | |||||
| DOBLER, Mark Stephen | Director | John Wood House Greenwell Road AB12 3AX East Tullos Aberdeen | United States | American | 158697600001 | |||||
| DUNCAN, Hugh Drummond | Director | Rivendell Netherley AB3 2QN Stonehaven | British | 11880730001 | ||||||
| EDGAR, William | Director | 3 Cairnie View Westhill AB32 6NB Aberdeen Aberdeenshire | Scotland | British | 109447840001 | |||||
| FERGUSON, Jacqueline | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | England | British | 245789210001 | |||||
| GARRETT, Edwin Charles | Director | The Beeches Banchory Devenick AB12 5YD Aberdeen Aberdeenshire | British | 38811750002 | ||||||
| GILMARTIN, Kenneth | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | United States | Irish | 297665100002 | |||||
| HOWSON, Richard John | Director | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | England | British | 147650310001 | |||||
| JONES, John Derek Prichard | Director | 9018 Fm 1383 78945 La Grange Texas Usa | Us Citizen Naturalis | 27236600001 | ||||||
| KEILLER, Robert | Director | Justice Mill Lane AB11 6EQ Aberdeen 15 Scotland | Scotland | British | 121316480001 | |||||
| KEMP, David Miller | Director | Hareness Road Altens Industrial Estate AB12 3LE Aberdeen Sir Ian Wood House Scotland | Scotland | British | 197523510001 | |||||
| LANGLANDS, Allister Gordon | Director | John Wood House Greenwell Road AB12 3AX East Tullos Aberdeen | Scotland | British | 34145910003 |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0