RUBY DCO TWO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RUBY DCO TWO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC037571 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RUBY DCO TWO LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RUBY DCO TWO LIMITED?
| Dirección de la sede social | Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street G2 1BP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBY DCO TWO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| AAH TWENTY FOUR LIMITED | 02 ago 2002 | 02 ago 2002 |
| A. G. BANNERMAN LIMITED | 30 abr 1962 | 30 abr 1962 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBY DCO TWO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBY DCO TWO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 dic 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland a Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP el 18 sept 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Thorsten Sprank el 18 sept 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Notification de Dunamis Mind Accelerator Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||||||
Cessation de Admenta Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 ago 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Wiseman como director el 31 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Thorsten Sprank como director el 31 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed aah twenty four LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Estado de capital el 15 ago 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 06 dic 2022 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Wendy Margaret Hall como director el 09 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nichola Louise Legg como secretario el 09 sept 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 33 páginas | MA | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nombramiento de Graham Wiseman como director el 07 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christian Keen como director el 18 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RUBY DCO TWO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Director | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | 203900280002 | |||||
| BANNERMAN, Stewart Nelson | Secretario | 13 Quadrant Road Newlands G43 2QP Glasgow | British | 242550002 | ||||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Secretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Secretario | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | 163214890001 | |||||||
| BANNERMAN, Alexander Grant | Director | Arns Brae 12 Ledcameroch Road Bearsden G61 4AB Glasgow | British | 242580001 | ||||||
| BANNERMAN, James Pirie | Director | Collingwood 5 Boclair Road Bearsden G61 2AE Glasgow | British | 242560001 | ||||||
| BANNERMAN, Stewart Nelson | Director | 13 Quadrant Road Newlands G43 2QP Glasgow | Scotland | British | 242550002 | |||||
| BEER, Thorsten | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| CLARK, Sheena Buchan | Director | 5 Lochview Road Bearsden G61 1PP Glasgow | British | 242570002 | ||||||
| DYKES, Gordon John | Director | 7h Hughenden Gardens Hyndland G12 9XW Glasgow | British | 37415970001 | ||||||
| HALL, Wendy Margaret | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Germany | German | 238936580003 | |||||
| HOOD, John | Director | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| KEEN, Christian | Director | Hampden Park Industrial Estate G42 0PH Glasgow 204 Polmadie Road Scotland | England | British | 54544790004 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| MURDOCK, Andrew Mark | Director | The Barn Caldecott Road LE16 8TB Great Easton Leicestershire | England | British | 49930640003 | |||||
| SHEPHERD, William | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| WILLETTS, Andrew John | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 120451550002 | |||||
| WISEMAN, Graham | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 299860960001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBY DCO TWO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunamis Mind Accelerator Limited | 31 ago 2023 | Cray Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Admenta Holdings Limited | 06 abr 2016 | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RUBY DCO TWO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 09 oct 1987 Entregado el 15 oct 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0