MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED

MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaMATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC039321
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    • Comercio al por mayor de vino, cerveza, bebidas espirituosas y otras bebidas alcohólicas (46342) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Wellpark Brewery
    161 Duke Street
    G4 0UL Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    FORTH WINES LIMITED01 oct 196301 oct 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta28 feb 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2021

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cambio de datos del secretario C&C Management Services Limited el 24 mar 2021

    1 páginasCH04

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 feb 2020

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2019 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 feb 2019

    6 páginasAA

    Cese del nombramiento de Jonathan Solesbury como director el 14 oct 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Riona Heffernan como director el 14 oct 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Andrea Pozzi como director el 14 oct 2019

    1 páginasTM01

    Exercice comptable précédent raccourci du 27 abr 2019 au 28 feb 2019

    1 páginasAA01

    Cese del nombramiento de David George Johnston como director el 29 ene 2019

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 30 abr 2018

    6 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 01 dic 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de C&C Management Services Limited como secretario el 26 sept 2018

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de C&C Management Services (Uk) Limited como secretario el 26 sept 2018

    1 páginasTM02

    Modification des détails de Matthew Clark (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 may 2018

    2 páginasPSC05

    Nombramiento de Mr David Johnston como director el 17 abr 2018

    2 páginasAP01

    Domicilio social registrado cambiado de The Ca'd'oro 45 Gordon Street Glasgow Scotland G1 3PE a Wellpark Brewery 161 Duke Street Glasgow G4 0UL el 19 abr 2018

    1 páginasAD01

    Nombramiento de Mr Jonathan Solesbury como director el 17 abr 2018

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Stephen Frederick Jebson como director el 17 abr 2018

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    C&C MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Keeper Road
    Crumlin
    Bulmers House
    Dublin 12, D12 K702
    Ireland
    Secretario corporativo
    Keeper Road
    Crumlin
    Bulmers House
    Dublin 12, D12 K702
    Ireland
    Forma jurídicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES - LTD
    Tipo de identificaciónOtra entidad corporativa o firma
    Autoridad legalIRISH COMPANIES ACT 2014
    Número de registroSC039321
    172928540001
    HEFFERNAN, Riona
    161 Duke Street
    G4 0UL Glasgow
    Wellpark Brewery
    Scotland
    Director
    161 Duke Street
    G4 0UL Glasgow
    Wellpark Brewery
    Scotland
    IrelandIrishAccountant203083000001
    ROBERTSON, Ewan James
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    ScotlandBritishCommercial & Operations Finance Director208215190001
    BIRRELL, David Robertson
    3 High Street
    KY13 7AW Kinross
    Fife
    Secretario
    3 High Street
    KY13 7AW Kinross
    Fife
    British185430001
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Secretario
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    British28396500005
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    BritishSolicitor69554640002
    PHILLIPS, David John
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    Secretario
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    158113200001
    YOUNGER, Michael James
    5 Malta Terrace
    EH4 1HR Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    5 Malta Terrace
    EH4 1HR Edinburgh
    Midlothian
    British1051770002
    C&C MANAGEMENT SERVICES (UK) LIMITED
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3LH Exeter
    Ashford House
    England
    Secretario corporativo
    Grenadier Road
    Exeter Business Park
    EX1 3LH Exeter
    Ashford House
    England
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro06743858
    245149380001
    AIKENS, Peter
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    Director
    Princes Lodge
    BA4 5HN Shepton Mallet
    Somerset
    BritishBrewer2228040002
    AYLWIN, Mark Terence
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Director
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    EnglandBritishManaging Director200866300001
    BELL, Peter T
    Manderlea 33 Links Road
    Lundin Links
    KY8 6AT Leven
    Fife
    Director
    Manderlea 33 Links Road
    Lundin Links
    KY8 6AT Leven
    Fife
    BritishCompany Director337980001
    CAMERON, David John
    Druminlochan
    Feshiebridge
    PH21 1NQ Kincraig
    Inverness-Shire
    Director
    Druminlochan
    Feshiebridge
    PH21 1NQ Kincraig
    Inverness-Shire
    ScotlandBritishCompany Director125212090001
    CAMPBELL, Donald Mackinnon
    5 Maryville Lane
    Uddingston
    G71 6EX Glasgow
    Director
    5 Maryville Lane
    Uddingston
    G71 6EX Glasgow
    ScotlandBritishSales Manager55208670001
    CARSON, Christopher
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    Director
    White Gates
    11 Oxshott Way
    KT11 2RU Cobham
    Surrey
    BritishCompany Director26602290003
    CHRISTENSEN, Troy
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    AustraliaAmericanCompany Director130789730003
    COLQUHOUN, Anne Therese
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    Director
    Apartment B Kings Ride House
    Prince Albert Drive
    SL5 8AQ Ascot
    United KingdomBritishCompany Secretary28396500005
    CRAN, John Mclellan
    Dupplin Bank
    PH2 7DF Perth
    Director
    Dupplin Bank
    PH2 7DF Perth
    BritishCompany Director Chartered Accountant352730001
    CREIGHTON, Thomas Hugh
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    Director
    Apple Acre
    High Road
    CR5 3QR Chipstead
    Surrey
    EnglandBritishAccountant157727790001
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Director
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director152083750001
    ETHERIDGE, Hugh Charles
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    Director
    5 Springfield Place
    BA1 5RA Bath
    Avon
    United KingdomBritishChartered Accountant1491130002
    GLENNIE, Helen Margaret
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director137615160001
    GOW, John
    26 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    26 Norwood Drive
    Giffnock
    G46 7LS Glasgow
    Lanarkshire
    BritishCompany Director352750001
    HARVEY-MILLER, Nicholas Thomas
    Craigton House
    G63 0XQ Fintry
    Stirlingshire
    Scotland
    Director
    Craigton House
    G63 0XQ Fintry
    Stirlingshire
    Scotland
    United KingdomBritishCompany Director83120001
    HODGES, Nigel Ian
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    Director
    Sonning House
    2 Canns Lane
    TA6 6QF North Petherton
    Somerset
    BritishBusiness Development Director75692570001
    HOGG, James Lauder Ettrick
    61 Cumberland Street
    EH3 6RA Edinburgh
    Midlothian
    Director
    61 Cumberland Street
    EH3 6RA Edinburgh
    Midlothian
    BritishWine & Spirit Merchant58108280001
    HUMPHREYS, Andrew
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Director
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    EnglandBritishDirector200489460001
    HUNTER, Diana
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    Director
    45 Gordon Street
    G1 3PE Glasgow
    The Ca'D'Oro
    Scotland
    EnglandBritishCeo170154190002
    HUNTER, Diana
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    England
    Director
    Weston Road
    CW1 6BP Crewe
    Unit 1
    England
    EnglandBritishCeo170154190002
    JEBSON, Stephen Frederick
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    EnglandBritishBuying & Insight Director171865850001
    JOHNSTON, David George
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    Director
    Duke Street
    G31 1JD Glasgow
    161
    Scotland
    IrelandIrishSolicitor198738340001
    KLEIN, David
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    Director
    45 Princes Road
    The Alberts
    TW10 6DQ Richmond
    Surrey
    AmericanCompany Director119928070001
    LOUSADA, James David
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway
    Old Portsmouth Road
    GU3 1LR Guildford
    Accolade House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director152222000001
    MALHOTRA, Deepak Kumar
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    The Guildway, Old Portsmouth Road
    Artington
    GU3 1LR Guildford
    Constellation House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor69554640002
    MARNOCH, William Berry
    Cairnwood
    Hartree
    ML12 6JJ Biggar
    Lanarkshire
    Director
    Cairnwood
    Hartree
    ML12 6JJ Biggar
    Lanarkshire
    BritishCompany Director779840001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Whitchurch
    BS14 0JZ Bristol
    Whitchurch Lane
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro6133835
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene MATTHEW CLARK (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    A registered charge
    Creado el 08 jul 2016
    Entregado el 22 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 22 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 12 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 08 jul 2016
    Entregado el 21 jul 2016
    Satisfecho en su totalidad
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Contiene una garantía fija:
    Personas con derecho
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 21 jul 2016Registro de una carga (MR01)
    • 12 abr 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    A registered charge
    Creado el 07 oct 2015
    Entregado el 16 oct 2015
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 16 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 28 oct 2015Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 03 feb 2017Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    A registered charge
    Creado el 07 oct 2015
    Entregado el 16 oct 2015
    Pendiente
    La garantía flotante cubre todo:
    Contiene una promesa negativa:
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transacciones
    • 16 oct 2015Registro de una carga (MR01)
    • 28 oct 2015Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 03 feb 2017Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 25 abr 2007
    Entregado el 01 may 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    That area or piece of ground lying in the parish of orwell and county of kinross extending to 4.5 acres or thereby.
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 01 may 2007Registro de un cargo (410)
    • 13 ago 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 17 abr 2007
    Entregado el 27 abr 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 27 abr 2007Registro de un cargo (410)
    • 08 mar 2016Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 05 nov 1998
    Entregado el 20 nov 1998
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Royal Bank Invoice Finance Limited
    Transacciones
    • 20 nov 1998Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 24 ene 1996
    Entregado el 30 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Warehouse premises and others at crawford place, milnathort, kinross.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 30 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • John Gow
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (410)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Northern Venture Partnership Fund
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (410)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (410)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nicholas Thomas Harvey-Miller
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (410)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 10 sept 1993
    Entregado el 28 sept 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Upland Developments Limited
    Transacciones
    • 28 sept 1993Registro de un cargo (410)
    • 17 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • James Lauder Ettrick Hogg
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • 3I PLC
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • John Buchan Richardson
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Northern Venture Partnership Fund
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • John Gow
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Nicholas Thomas Harvey-Miller
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 23 dic 1992
    Entregado el 13 ene 1993
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Upland Developments Limited
    Transacciones
    • 13 ene 1993Registro de un cargo (410)
    • 05 may 1993Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 15 dic 1989
    Entregado el 22 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects at crawford place milnathort, kinross.
    Personas con derecho
    • Noble Crossart LTD as Agent for Itself and the Banks
    Transacciones
    • 22 dic 1989Registro de una carga
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 dic 1989
    Entregado el 21 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Noble Grossart LTD as Agents and Trustee
    Transacciones
    • 21 dic 1989Registro de una carga
    • Tiene modificaciones en la orden:
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones
    Mandate
    Creado el 06 dic 1989
    Entregado el 21 dic 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Sale proceeds of the netty bridge hotel netty bridge inverness-shire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1989Registro de una carga
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 23 nov 1989
    Entregado el 23 nov 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Warehouse premises and others at crawford place milinathart kinross.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 23 nov 1989Registro de una carga
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 01 dic 1977
    Entregado el 21 dic 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 21 dic 1977Registro de una carga
    • 02 mar 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0