ARGENT OILS (UK) LIMITED

ARGENT OILS (UK) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaARGENT OILS (UK) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC039715
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    • Recolección de residuos no peligrosos (38110) / Captación, depuración y distribución de agua; gestión de residuos; actividades de descontaminación y recuperación

    ¿Dónde se encuentra ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    236-240 Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    ARGENT ENERGY COLLECTIONS LIMITED30 ene 200730 ene 2007
    W.C. HODGKINSON (CLELAND) LIMITED31 dic 196331 dic 1963

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Nombramiento de Dr Louise Jacqueline Calviou como director el 31 dic 2023

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Erik Peter Rietkerk como director el 31 dic 2023

    1 páginasTM01

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Estado de capital el 03 ago 2023

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    7 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2023 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2021

    17 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2022 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2020

    18 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2021 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2019

    22 páginasAA

    Cese del nombramiento de Andrew William Dane como director el 09 jul 2020

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mrs Nicola Dean como director el 09 jul 2020

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018

    22 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 17 may 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Nombramiento de Mr Andrew William Dane como director el 12 mar 2019

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de John Bruce Rae-Smith como director el 12 mar 2019

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de James Arthur Richard Boyd como director el 12 mar 2019

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MORRIS, David Charles
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Secretario
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    251441300001
    CALVIOU, Louise Jacqueline, Dr
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Director
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish215932720001
    DEAN, Nicola
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Director
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish219781490001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Secretario
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    British79031400002
    BOND, Christopher David
    Ashgrove
    4/5 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    Secretario
    Ashgrove
    4/5 Wester Coates Road
    EH12 5LU Edinburgh
    Other95433830001
    BOYD, James Arthur Richard
    Renwick Lane
    Cardrona
    EH45 9LU Peebles
    14
    Borders
    Scotland
    Secretario
    Renwick Lane
    Cardrona
    EH45 9LU Peebles
    14
    Borders
    Scotland
    British130003610001
    CARTWRIGHT, David Frederick
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    Secretario
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    British1161680001
    DIBBEN, Ann Marie
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    Secretario
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    213029000001
    HYND, Russell John
    22/4 East Suffolk Park
    Newington
    EH16 5PN Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    22/4 East Suffolk Park
    Newington
    EH16 5PN Edinburgh
    Midlothian
    British84638940002
    JANNETTA, Lucio Enrico Peter
    18 Beauly Crescent
    G77 5UQ Newwton Mearns
    Renfrewshire
    Secretario
    18 Beauly Crescent
    G77 5UQ Newwton Mearns
    Renfrewshire
    British115543480001
    MACEACHRAN, Ronald Bannatyne
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    Secretario
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    British108202220001
    MCLINDEN, John Farrell
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    British183160001
    MORRIS, David Charles
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    Secretario
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    England
    203885110001
    BARNES, Andrew John
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    Director
    19 Queens Avenue
    IG8 0JE Woodford Green
    Essex
    EnglandBritish79031400002
    BOYD, James Arthur Richard
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Director
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    United KingdomBritish130003610003
    BUSWELL, Michel Norman
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    Director
    The Dower House
    1 The Green
    NN12 8PD Blakesley
    Northants
    British15685720001
    CARTWRIGHT, David Frederick
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    Director
    38 Argyle Way
    FK15 9DY Dunblane
    Perthshire
    British1161680001
    DANE, Andrew William
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Director
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    ScotlandBritish184371050002
    DELL, Julian David
    37 The Moor
    Melbourn
    SG8 6ED Royston
    Hertfordshire
    Director
    37 The Moor
    Melbourn
    SG8 6ED Royston
    Hertfordshire
    British37454890002
    GORDON, George Hay Robertson
    18 Lynecroft
    Bishopbriggs
    G64 3LN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    18 Lynecroft
    Bishopbriggs
    G64 3LN Glasgow
    Lanarkshire
    British183180001
    GRAY, David John
    20 Warwick Avenue
    W9 2PT London
    Director
    20 Warwick Avenue
    W9 2PT London
    EnglandBritish105745700001
    HUNTER, Andrew Pennington Havard
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Director
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    EnglandBritish54239750005
    MACEACHRAN, Ronald Bannatyne
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    Director
    59 Finnart Street
    Greenock
    PA16 8HH Renfrewshire
    British108202220001
    MCLINDEN, John Farrell
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    21 Castleton Avenue
    Newton Mearns
    G77 5NF Glasgow
    Lanarkshire
    British183160001
    MENZIES, John
    35 Dundonald Road
    KA1 1RY Kilmarnock
    Ayrshire
    Director
    35 Dundonald Road
    KA1 1RY Kilmarnock
    Ayrshire
    British183170002
    RAE-SMITH, John Bruce
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    Director
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    Scotland
    United KingdomBritish135359240003
    RIETKERK, Erik Peter
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Director
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    United KingdomDutch249633820001
    WALKER, James Lamont
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    Director
    59 Buckingham Gate
    SW1E 6AJ London
    Swire House
    United Kingdom
    ScotlandBritish127869700010
    WARD, Douglas John
    6 Halmyre Loan
    Romanno Bridge
    EH46 7DN West Linton
    Valhalla
    Director
    6 Halmyre Loan
    Romanno Bridge
    EH46 7DN West Linton
    Valhalla
    United KingdomBritish35803420005

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de ARGENT OILS (UK) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    06 abr 2016
    Biggar Road
    Newarthill
    ML1 5FA Motherwell
    236-240
    North Lanarkshire
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalUnited Kingdom (Scotland)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc359384
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene ARGENT OILS (UK) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 09 sept 2011
    Entregado el 17 sept 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 17 sept 2011Registro de un cargo (MG01s)
    • 21 sept 2011Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 29 nov 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Floating charge
    Creado el 09 sept 2011
    Entregado el 17 sept 2011
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 17 sept 2011Registro de un cargo (MG01s)
    • 21 sept 2011Alteración de un cargo flotante (466 Scot)
    • 27 nov 2018Satisfacción de una carga (MR04)
    • Tiene modificaciones en la orden:
    Standard security
    Creado el 02 sept 2009
    Entregado el 09 sept 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Auchterderran road lochgelly FFE47732.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 09 sept 2009Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 18 ago 2009
    Entregado el 26 ago 2009
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transacciones
    • 26 ago 2009Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 25 jul 2007
    Entregado el 06 ago 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    Subjects at auchterderran road, lochgelly FFE47732.
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 06 ago 2007Registro de un cargo (410)
    • 03 nov 2011Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Bond & floating charge
    Creado el 17 jul 2007
    Entregado el 31 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 jul 2007Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Floating charge
    Creado el 16 jul 2007
    Entregado el 31 jul 2007
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the finance documents
    Breve descripción
    Legal mortgage over any property; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 31 jul 2007Registro de un cargo (410)
    • 17 sept 2011Declaración de satisfacción de una carga flotante (MG03s)
    Standard security
    Creado el 12 mar 2003
    Entregado el 20 mar 2003
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects on the east side of biggarford road, cleland--title number LAN23031.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 mar 2003Registro de un cargo (410)
    • 11 may 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 30 oct 2002
    Entregado el 12 nov 2002
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due under the bos documents
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 nov 2002Registro de un cargo (410)
    • 02 dic 2008Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 03 oct 1997
    Entregado el 10 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects at east side of biggarford road, cleland.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 10 oct 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 oct 1997
    Entregado el 16 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    East side of biggarford road, cleland : ground at parish of bothwell.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Agent and Trustee
    Transacciones
    • 16 oct 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Floating charge
    Creado el 30 sept 1997
    Entregado el 06 oct 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transacciones
    • 06 oct 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 nov 2002Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0