KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC042425 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
- Agentes involucrados en la venta de madera y materiales de construcción (46130) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Dirección de la sede social | 50 Mauchline Street G5 8HQ Glasgow United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KEYLINE BUILDERS MERCHANTS LIMITED | 30 ene 1991 | 30 ene 1991 |
| J. & W. HENDERSON LIMITED | 28 nov 1988 | 28 nov 1988 |
| CRH MERCHANTS LIMITED | 04 jun 1987 | 04 jun 1987 |
| CEMENT-ROADSTONE MERCHANTS LIMITED | 19 sept 1986 | 19 sept 1986 |
| WIMPEY MERCHANTS LIMITED | 21 jul 1965 | 21 jul 1965 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 dic 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 sept 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 15 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 01 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Catherine Edwards como director el 31 ene 2026 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del secretario Tpg Management Services Limited el 18 jun 2025 | 1 páginas | CH04 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Tp Directors Ltd el 18 jun 2025 | 1 páginas | CH02 | ||||||||||||||
Modification des détails de Travis Perkins Merchant Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 nov 2025 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Huw Russell Jenkins como director el 01 sept 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mrs Catherine Edwards el 23 jul 2025 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2024 | 33 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Harris como director el 30 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2025 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
legacy | 4 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Robin Paul Miller como director el 28 ene 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Catherine Edwards como director el 28 ene 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 02 dic 2024
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2023 | 32 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2024 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Dean Pinner como director el 31 mar 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Nombramiento de Mr Robin Paul Miller como director el 23 ene 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Alan Richard Williams como director el 23 ene 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Estado de capital el 05 sept 2023
| 6 páginas | SH02 | ||||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Alan Richard Williams el 16 jun 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2022 | 38 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom |
| 186000060001 | ||||||||||
| ALCOCK, Thomas William | Director | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | United Kingdom | British | 156454570001 | |||||||||
| JENKINS, Huw Russell | Director | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | United Kingdom | British | 258399470001 | |||||||||
| TP DIRECTORS LTD | Director corporativo | Ryehill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom |
| 191205550001 | ||||||||||
| DAVIDSON, Arthur Joseph | Secretario | 63 Moorfoot Way Bearsden G61 4RL Glasgow | British | 604400002 | ||||||||||
| DOOHAN, John | Secretario | Trefoil Avenue G41 3PE Shawlands 48 Glasgow | British | 129812950001 | ||||||||||
| HOWLETT, Michael Robert | Secretario | 45 Kendal Close NN3 6WJ Northampton Northamptonshire | British | 12957700001 | ||||||||||
| PIKE, Andrew Stephen | Secretario | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Travis Perkins Plc Northamptonshire | British | 65678800002 | ||||||||||
| SUTHERLAND, Andrew Campbell | Secretario | Fairways, 28 Gadloch Avenue Lenzie G66 5NP Glasgow | British | 86050600001 | ||||||||||
| ADAMS, Edward Cyril | Director | Granville House Holly Farm Road Otham ME15 8RY Maidstone Kent | British | 14500800001 | ||||||||||
| AITKEN, John David | Director | 26 Salisbury Road SP10 2JL Andover Hampshire | British | 717920001 | ||||||||||
| AITKEN, John David | Director | 26 Salisbury Road SP10 2JL Andover Hampshire | British | 717920001 | ||||||||||
| BARRY, Anthony Dermot | Director | Annamore 30 Sydney Avenue IRISH Blackrock Co Dublin | Irish | 717900001 | ||||||||||
| BELL, Norman | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 106766000001 | |||||||||
| BUFFIN, Anthony David | Director | 8 Strathkelvin Place G66 1XT Kirkintilloch Suite S3 Scotland Scotland | England | British | 178011680002 | |||||||||
| CAHILL, Jack | Director | 36 Netherblane Blanefield G63 9JW Glasgow | British | 37460910002 | ||||||||||
| CARTER, John Peter | Director | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 46226920007 | |||||||||
| CARTON, Maeve Catherine | Director | 56 Mountain View Road Ranelagh IRISH Dublin 6 Ireland | Irish | 48332960001 | ||||||||||
| COOPER, Geoffrey Ian | Director | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 104472550001 | |||||||||
| DAVIDSON, Arthur Joseph | Director | Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 604400004 | |||||||||
| DICKS, Christopher | Director | 8 Strathkelvin Place G66 1XT Kirkintilloch Suite S3 Scotland Scotland | United Kingdom | British | 203748470001 | |||||||||
| EDWARDS, Catherine | Director | Rye Hill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House United Kingdom | England | British | 331745010001 | |||||||||
| ELKINS, Francis Mark | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | England | British | 164172230002 | |||||||||
| GANDY, David | Director | Malton Farm Malton Lane Meldreth SG8 6PE Royston Hertfordshire | British | 19322520001 | ||||||||||
| GODSON, Don | Director | Island View Nerano Road IRISH Dalkey Co Durham Ireland | Irishsh | 42404310003 | ||||||||||
| GOLDSMITH, Ian Robert, Dr | Director | Lodge Way House, Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | British | 70864590002 | ||||||||||
| GOUKA, Jacobus | Director | Bosrand-38 3121 XA Schiedam Zuid Holland | Dutch | 48332710001 | ||||||||||
| GRIFFIN, Kieran | Director | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | United Kingdom | British | 131159630001 | |||||||||
| GRIFFIN, William Gerard | Director | Moonacre Killincarrig IRISH Delgany Co Wicklow Republic Of Ireland | Irish | 717160011 | ||||||||||
| HAMPDEN SMITH, Paul Nigel | Director | Travis Perkins Plc, Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton Northamptonshire | United Kingdom | British | 72135950007 | |||||||||
| HARRIS, Stephen | Director | Mauchline Street G5 8HQ Glasgow 50 United Kingdom | England | British | 178050390001 | |||||||||
| HARRISON, Andrew Peter | Director | Lodge Way House Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 246549720001 | |||||||||
| HILL, Brian Gerard | Director | Ringdijk 14 3054 Kw FOREIGN Rotterdam The Netherlands | Irish | 63529150001 | ||||||||||
| HUGHES, Liam Patrick | Director | 55 Southlea Road Datchet SL3 9BZ Slough Berkshire | Irish | 64295190001 | ||||||||||
| KAVANAGH, Carol | Director | Lodge Way House Lodge Way, Harlestone Road NN5 7UG Northampton | United Kingdom | British | 127248260001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de KEYLINE CIVILS SPECIALIST LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Perkins Merchant Holdings Limited | 21 dic 2018 | Ryehill Close Lodge Farm Industrial Estate NN5 7UA Northampton Ryehill House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Travis Perkins Plc | 06 abr 2016 | Lodge Way Harlestone Road NN5 7UG Northampton Lodge Way House United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0