MB ENGINEERING SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | MB ENGINEERING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC043732 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
- Otras actividades especializadas de construcción n.c.p. (43999) / Construcción
¿Dónde se encuentra MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Unit B Hermiston House Newhouse Industrial Estate Newhouse ML1 5FL Motherwell Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MOTHERWELL BRIDGE CONSTRUCTION LIMITED | 17 nov 1986 | 17 nov 1986 |
| MOTHERWELL BRIDGE CONSTRUCTORS LIMITED | 18 jul 1966 | 18 jul 1966 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 ago 2025 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 may 2026 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 ago 2024 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jun 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 23 jun 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 09 jun 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2024 | 12 páginas | AA | ||
Notification de Altrad Services Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2023 | 2 páginas | PSC02 | ||
Cessation de Motherwell Bridge Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 dic 2023 | 1 páginas | PSC07 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2023 | 12 páginas | AA | ||
Nombramiento de Mr Jonathan Paul Gilmore como director el 13 jun 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Padraig Somers como director el 13 jun 2023 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2022 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2021 | 12 páginas | AA | ||
Domicilio social registrado cambiado de The Bridge Works P.O. Box 4 Logans Road Motherwell Scotland ML1 3NP Scotland a Unit B Hermiston House Newhouse Industrial Estate Newhouse Motherwell ML1 5FL el 08 oct 2021 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2020 | 12 páginas | AA | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2019 | 12 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Padraig Somers como director el 27 jun 2019 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Simon Angus Hicks como director el 27 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 09 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cese del nombramiento de Jane Victoria Atkinson como director el 13 jun 2019 | 1 páginas | TM01 | ||
Cambio de datos del director Mr Simon Angus Hicks el 04 feb 2019 | 2 páginas | CH01 | ||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 ago 2018 | 12 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Mark Jason Scott como director el 10 nov 2018 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2017 | 16 páginas | AA | ||
¿Quiénes son los directivos de MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILMORE, Jonathan Paul | Director | Newhouse Industrial Estate Newhouse ML1 5FL Motherwell Unit B Hermiston House Scotland | England | British | 263362040001 | |||||
| WALSH, John Anthony Meade | Director | Newhouse Industrial Estate Newhouse ML1 5FL Motherwell Unit B Hermiston House Scotland | United Kingdom | British | 238138720001 | |||||
| ALLAN, Richard | Secretario | P.O. Box 4 Logans Road ML1 3NP Motherwell The Bridge Works Scotland Scotland | British | 186195370001 | ||||||
| HAMILTON, Robert Herd | Secretario | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | British | 647140001 | ||||||
| HAMILTON, Robert Herd | Secretario | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | British | 647140001 | ||||||
| POLLAND, Owen | Secretario | 7 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | British | 90289570001 | ||||||
| ALLAN, Richard Friend | Director | P.O. Box 4 Logans Road ML1 3NP Motherwell The Bridge Works Scotland Scotland | United Kingdom | British | 183409640001 | |||||
| ATKINSON, Jane Victoria | Director | P.O. Box 4 Logans Road ML1 3NP Motherwell The Bridge Works Scotland Scotland | England | British | 242910000001 | |||||
| BROWN, Alan Charles | Director | 26 Lever Road G84 9DP Helensburgh Dunbartonshire | British | 628180001 | ||||||
| CORBISHLEY, Michael | Director | Overidge Farm Beckside Cartmel LA11 7SP Grange-Over-Sands Cumbria | England | British | 101553180002 | |||||
| CRAWFORD, Cameron James Kenneth | Director | 3 Baberton Mains Drive EH14 3DF Edinburgh Midlothian | British | 87125750001 | ||||||
| EASTON, Archibald Arbuckle | Director | The Steading, 16 Crofthead Place Newton Mearns G77 5QQ Glasgow | British | 29624020002 | ||||||
| FORD, Ian Joicey | Director | Little Appleton, 3 Lumley Terrace Newton-Le-Willows DL8 1SS Bedale North Yorkshire | British | 97586400001 | ||||||
| FUDGE, Sydney Robert | Director | Pitlethie House Pitlethie Road KY16 0DP Leuchars Fife | Scotland | British | 10630480001 | |||||
| GEORGE, Victoria Anne | Director | Motherwell Bridge Works Motherwell | United Kingdom | British | 134024500001 | |||||
| GRAHAM, Robert Smith | Director | 14 Hamilton Avenue Pollokshields G41 4JF Glasgow Lanarkshire | British | 647170001 | ||||||
| GROVER, John | Director | South Town Road Medstead GU34 5ES Hants Rowan House United Kingdom | United Kingdom | British | 213497560001 | |||||
| HAMILTON, Robert Herd | Director | Drayton Hall Church Road UB7 7PS West Drayton, Middlesex Cape Intermediate Holdings Limited England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | 647140001 | |||||
| HAMILTON, Robert Herd | Director | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | United Kingdom | British | 647140001 | |||||
| HAMILTON, Robert Herd | Director | 82 Manse Road ML1 2PT Motherwell | United Kingdom | British | 647140001 | |||||
| HART, Craig | Director | 21 Weaver Place G75 8SH East Kilbride Lanarkshire | British | 100056190001 | ||||||
| HAYES, Michael Hugh | Director | Wenlock Mounthooly TD8 6TJ Jedburgh Roxburghshire | Scotland | British | 50729030001 | |||||
| HICKS, Simon Angus | Director | P.O. Box 4 Logans Road ML1 3NP Motherwell The Bridge Works Scotland Scotland | England | British | 189093640001 | |||||
| LINDSAY, Ian | Director | 56 Braidwood Road ML8 5NY Braidwood Lanarkshire | British | 72204680001 | ||||||
| LUMSDEN, John | Director | 4 Friarsfield Road ML11 9EN Lanark Lanarkshire | Scotland | British | 647150001 | |||||
| MACDONALD, Alexander Alister | Director | 4 Millburn Drive PA13 4JF Kilmacolm | Scotland | British | 35579400001 | |||||
| MCSHANE, Joseph | Director | 18 Woodlands Drive ML1 4XU Motherwell Lanarkshire | British | 62244850001 | ||||||
| MURPHY, John Alan | Director | 64 Whittinghame Drive G12 Glasgow | Scotland | British | 628170001 | |||||
| PATE, Robert | Director | 26 Torr Road G64 1XJ Glasgow | British | 87125790001 | ||||||
| PATERSON, Stewart Mcgregor | Director | 17 Edzell Drive Newton Mearns G77 5QX Glasgow Lanarkshire | British | 628160001 | ||||||
| POLLAND, Owen | Director | 7 Carlingnose Point KY11 1ER North Queensferry | British | 90289570001 | ||||||
| PROSSER, William Lindsay | Director | 5 Kilbreck Gardens Bearsden G61 4SL Glasgow Lanarkshire | British | 649450001 | ||||||
| REID, William Mungall | Director | 25 Royal Drive ML3 7DJ Hamilton Lanarkshire | British | 35277110003 | ||||||
| SCOTT, Mark Jason | Director | Brindley Way Wakefield 41 Industrial Park WF2 0XQ Wakefield Unit 2b West Yorkshire United Kingdom | England | British | 205880020001 | |||||
| SOMERS, Padraig | Director | Island Ganniv Greenville Listowel 3 Co. Kerry Ireland | Ireland | Irish | 259818620001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de MB ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altrad Services Limited | 01 dic 2023 | Barleycastle Lane Appleton WA4 4ST Warrington 6-7 Lyncastle Way England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Motherwell Bridge Limited | 06 abr 2016 | Church Road West Drayton UB7 7PS Middlesex Drayton Hall England England | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0