T K EBBUTT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | T K EBBUTT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC044771 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de T K EBBUTT LIMITED?
- producción de metales preciosos (24410) / Industrias manufactureras
- Fabricación de joyería y artículos relacionados (32120) / Industrias manufactureras
¿Dónde se encuentra T K EBBUTT LIMITED?
| Dirección de la sede social | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de T K EBBUTT LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2020 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para T K EBBUTT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan David Payne como director el 15 jun 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de microempresa preparadas hasta el 31 mar 2020 | 3 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Stephen Richard Paterson como director el 31 jul 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ross Haston como director el 07 abr 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Ross Haston como secretario el 07 abr 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Victoria Houghton como director el 06 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan David Payne como director el 06 abr 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 mar 2019 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Neal Hunt como director el 31 ene 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 mar 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 01 abr 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 10 may 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 02 abr 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 may 2016 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 28 mar 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 may 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 10 may 2014 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 29 mar 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de T K EBBUTT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOUGHTON, Victoria | Director | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF | England | English | 245853410001 | |||||
| CARR, Deirdre Mabel Hamilton | Secretario | 50 Murrayfield Avenue EH12 6AY Edinburgh Midlothian | British | 566990001 | ||||||
| HASTON, Ross | Secretario | George Street EH2 3EY Edinburgh 87 Midlothian Scotland | British | 155763790001 | ||||||
| PAGE, Elizabeth | Secretario | Flat 3 5 St Leonards Road, Ealing W13 8PN London | British | 34006010001 | ||||||
| PATRICK, David Malcolm | Secretario | George Street EH2 3EY Edinburgh 87 Midlothian | British | 150814540001 | ||||||
| REID, Michael John | Secretario | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| REID, Michael John | Secretario | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | Irish | 950490001 | ||||||
| SKINNER, Denzil Gough Onslow | Secretario | Rosebank House 190 Newhaven Road EH6 4QB Edinburgh | British | 37319990002 | ||||||
| ADAMS, David Alexander Robertson | Director | Applegarth Three Elm Lane Hadlow TN11 0AB Tonbridge Kent | England | British | 55757700003 | |||||
| ASPREY, John Rolls | Director | 166 New Bond Street W1Y 0AR London | United Kingdom | British | 68034280002 | |||||
| ATTALLAH, Naim Ibrahim | Director | Flat 15 51 South Street W1Y 5PA London | United Kingdom | British | 25646240001 | |||||
| CARR, Deirdre Mabel Hamilton | Director | 50 Murrayfield Avenue EH12 6AY Edinburgh Midlothian | British | 566990001 | ||||||
| CARR, Malcolm Stuart | Director | 50 Murrayfield Avenue EH12 6AY Edinburgh Midlothian | British | 567020001 | ||||||
| DAHL, Ian Xavier | Director | 2 Heathfield Lodge Carron Lane GU29 9LD Midhurst West Sussex | British | 66486140001 | ||||||
| FRASER, Alexander James | Director | Milngavie G62 8LB Glasgow Craigmaddie | Scotland | British | 85468160004 | |||||
| HASTON, Ross | Director | George Street EH2 3EY Edinburgh 87 Midlothian Scotland | Scotland | British | 98032220001 | |||||
| HUNT, Jonathan Neal | Director | George Street EH2 8EY Edinburgh 87 Midlothian | Scotland | British | 150913530001 | |||||
| INCHES, Deirdre Rosaleen | Director | 5 Belford Place EH4 3DH Edinburgh Midlothian | British | 567010001 | ||||||
| INCHES, Ian Hamilton | Director | 5 Belford Place EH4 3DH Edinburgh Midlothian | British | 567000001 | ||||||
| LOWDEN, David Soutar | Director | The Squirrels Riversdale SL8 5EB Bourne End Buckinghamshire | England | British | 54836190001 | |||||
| OGILVY, Julia Caroline | Director | Coates House Upper Largo KY8 6JF Leven Fife Scotland | Scotland | British | 19413900001 | |||||
| PATERSON, Stephen Richard | Director | George Street EH2 8EY Edinburgh 87 Midlothian | United Kingdom | British | 1079360002 | |||||
| PAYNE, Jonathan David | Director | 16 Charlotte Square Edinburgh EH2 4DF | Scotland | British | 187118830001 | |||||
| REID, Michael John | Director | 49 Waldemar Avenue W13 9PZ London | England | Irish | 950490001 | |||||
| RITCHIE, John | Director | 93 Weaversnowe Cres Currie EH14 5PP Edinburgh Midlothian | British | 858050002 | ||||||
| SKINNER, Denzil Gough Onslow | Director | Rosebank House 190 Newhaven Road EH6 4QB Edinburgh | United Kingdom | British | 37319990002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de T K EBBUTT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton & Inches Limited | 06 abr 2016 | Charlotte Square EH2 4DF Edinburgh 16 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene T K EBBUTT LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Letter of offset | Creado el 22 ene 1988 Entregado el 08 feb 1988 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due by hamilton & inches LTD | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the bank in name of the company. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 24 feb 1978 Entregado el 03 mar 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0