SD DECISIONS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSD DECISIONS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC045704
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SD DECISIONS LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra SD DECISIONS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    24 Great King Street
    Edinburgh
    EH3 6QN
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SD DECISIONS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BIS STRATEGIC DECISIONS LIMITED 28 ene 199128 ene 1991
    BIS MACKINTOSH LIMITED22 mar 198822 mar 1988
    BIS MACKINTOSH INTERNATIONAL LIMITED11 jul 198611 jul 1986
    BIS-MACKINTOSH LIMITED28 may 196828 may 1968

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SD DECISIONS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 may 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SD DECISIONS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta)

    13 páginasLIQ13(Scot)

    legacy

    1 páginasAC93

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    23 páginas4.26(Scot)

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación

    LRESSP

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2010

    5 páginasAA

    Nombramiento de Thomas Edward Timothy Homer como director

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Cheesewright como director

    1 páginasTM01

    Déclaration annuelle établie au 01 jul 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital26 jul 2010

    Estado de capital el 26 jul 2010

    • Capital: GBP 10,500
    SH01

    Nombramiento de Nicholas Brian Farrimond como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de un director

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Elizabeth Gray como secretario

    1 páginasTM02

    Nombramiento de Misys Corporate Secretary Limited como secretario

    2 páginasAP04

    Cese del nombramiento de Gurbinder Bains como secretario

    1 páginasTM02

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2009

    5 páginasAA

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2008

    5 páginasAA

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 may 2007

    5 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    ¿Quiénes son los directivos de SD DECISIONS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MISYS CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Secretario corporativo
    Paddington
    W2 6BL London
    One Kingdom Street
    United Kingdom
    Tipo de identificaciónEEE
    Número de registro07036299
    150502590001
    FARRIMOND, Nicholas Brian
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    Director
    The Avenue
    WD17 4NU Watford
    51
    Hertfordshire
    EnglandBritish75357260001
    HOMER, Thomas Edward Timothy
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    Director
    Maidenhead Road
    Cookham
    SL6 9DF Berkshire
    Rosedale
    United Kingdom
    EnglandBritish146605570001
    MISYS CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Burleigh House
    Chapel Oak
    WR11 8SP Salford Priors
    Evesham
    Director corporativo
    Burleigh House
    Chapel Oak
    WR11 8SP Salford Priors
    Evesham
    82836510001
    ARMITAGE, Matthew
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    Secretario
    63 Windsor Road
    WR11 4QF Evesham
    British98110790002
    BAINS, Gurbinder
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Secretario
    Kingston Road
    UB2 4AP Southall
    36
    Middlesex
    United Kingdom
    Other138753780001
    BICHEMO, Tracey Lynne
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    Secretario
    Flat E 9 Longridge Road
    SW5 9SB London
    British16560470002
    DURRANT, Zoe Vivienne
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    Secretario
    Beehive Cottage
    Radford Road, Rous Lench
    WR11 4UL Evesham
    Worcestershire
    British68141090001
    GRAY, Elizabeth Andrea
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    Secretario
    16 Broad Street
    CV34 4LT Warwick
    Warwickshire
    British98035800001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Secretario
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    British136433670001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    WALDEN, Alan Derek
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    Secretario
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    British536150001
    WATERS, Paul Christopher
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    Secretario
    The Old Vicarage
    High Street
    B50 4BQ Bidford On Avon
    Warwickshire
    British67435560001
    BEAR, John Peter
    1 Longwater Circle
    FOREIGN Norwell
    Usa
    Director
    1 Longwater Circle
    FOREIGN Norwell
    Usa
    American26180110001
    BIRD, John Francis
    8a Dell Close
    AL5 4HP Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    8a Dell Close
    AL5 4HP Harpenden
    Hertfordshire
    British35039540001
    CHEESEWRIGHT, James
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    Director
    Horton Meadow
    Heyshott
    GU29 0DL Midhurst
    West Sussex
    United KingdomBritish80646020001
    COOPER, Graham Barrie
    School House
    Cockernhoe
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    Director
    School House
    Cockernhoe
    LU2 8PY Luton
    Bedfordshire
    British603160001
    COPELAND, Philip Robert
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    Director
    Crofton Sheldon Road
    Ickford
    HP18 9HY Aylesbury
    Buckinghamshire
    EnglandBritish44954570001
    EVANS, Robert Owen
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    Field House
    Ashow
    CV8 2LE Kenilworth
    Warwickshire
    British57011000002
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GORDON, George Michael Winston
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    Director
    5 Englehurst
    AL5 5SQ Harpenden
    Hertfordshire
    British37797170001
    GRAHAM, George Malcolm Roger
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    Director
    Gaston House
    Gaston Green Little Hallingbury
    CM22 7QS Bishops Stortford
    Hertfordshire
    United KingdomBritish36314420001
    GRAHAM, Ross King
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Director
    Stourton Farm House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    United KingdomBritish61733920001
    GUINCHARD, Philippe Albert
    37 Rue Des Longs Pres
    92100 Boulogne
    France
    Director
    37 Rue Des Longs Pres
    92100 Boulogne
    France
    French35039550001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    HAM, Richard Laurence
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    Director
    High Street
    Welford-On-Avon
    CV37 8EA Stratford-Upon-Avon
    Avon House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish136433670001
    JARVIS, John Edwin
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    Director
    Hurstbury Combe Lane
    Wormley
    GU8 5JX Godalming
    Surrey
    British62045640001
    OLDERSHAW, Peter Alan
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    Director
    Wellesbourne 80 Newfield Road
    West Hagley
    DY9 0HY Stourbridge
    West Midlands
    British2546430001
    PESKO, Charles Anton
    366 Moraine Street
    FOREIGN Marshfield
    Ma
    Usa
    Director
    366 Moraine Street
    FOREIGN Marshfield
    Ma
    Usa
    American603180001
    PYNE, Anthony Edwin
    1 Brook End
    Eversholt
    MK17 9DT Milton Keynes
    Director
    1 Brook End
    Eversholt
    MK17 9DT Milton Keynes
    British603190001
    TAYLOR, David
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    Director
    Honeywood Atch Lench Road
    Church Lench
    WR11 4UG Evesham
    Worcestershire
    British1439590001
    WALDEN, Alan Derek
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    Director
    17 Braggs Lane
    Wrestlingworth
    SG19 2ER Sandy
    Bedfordshire
    British536150001
    WEAVER, John Joseph, Doctor
    76 Western Avenue
    Woodley
    RG5 3BH Reading
    Berkshire
    Director
    76 Western Avenue
    Woodley
    RG5 3BH Reading
    Berkshire
    British16376810001
    WHISKIN, Robin Stuart
    42 Crown Street
    Redbourn
    AL3 7PF St Albans
    Hertfordshire
    Director
    42 Crown Street
    Redbourn
    AL3 7PF St Albans
    Hertfordshire
    British603210001
    WHITTY, Brian Howard
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    Director
    Ruxley House Rowney Green Lane
    Rowney Green
    B48 7QF Alvechurch
    Worcestershire
    British36622750002

    ¿Tiene SD DECISIONS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 20 feb 1981
    Entregado el 12 mar 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £50,000
    Breve descripción
    Charge entire undertaking present debenture ranks immediately behind a mortgage and general charge and a debenture made between the company and business intelligence services LTD.
    Personas con derecho
    • Business Intelligence Services LTD
    Transacciones
    • 12 mar 1981Registro de una carga
    Mortgage & general charge
    Creado el 18 dic 1980
    Entregado el 31 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £30,000
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Business Intelligence Services LTD
    Transacciones
    • 31 dic 1980Registro de una carga
    Debenture
    Creado el 18 dic 1980
    Entregado el 31 dic 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £102,000
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Personas con derecho
    • Business Intelligence Services LTD
    Transacciones
    • 31 dic 1980Registro de una carga
    Letter of offset
    Creado el 10 jun 1977
    Entregado el 15 jun 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due by the macintosh consultants co LTD & another
    Breve descripción
    Credit balances of any accounts held by the bank in the companys name.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 15 jun 1977Registro de una carga
    • 16 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 18 feb 1971
    Entregado el 24 feb 1971
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 feb 1971Registro de una carga
    • 16 abr 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    ¿Tiene SD DECISIONS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    28 jun 2017Inicio de la liquidación
    26 jun 2020Fecha de disolución
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0