CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC046004 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
- Hoteles y alojamientos similares (55100) / Actividades de alojamiento y de servicios de comida
¿Dónde se encuentra CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| GLH HOTELS MANAGEMENT (UK) LIMITED | 07 jun 2013 | 07 jun 2013 |
| GUOMAN HOTEL MANAGEMENT (UK) LIMITED | 28 sept 2007 | 28 sept 2007 |
| GUOMAN HOTEL MANAGEMENT LIMITED | 09 may 2007 | 09 may 2007 |
| THISTLE HOTELS (MANAGEMENT) LIMITED | 30 ago 1989 | 30 ago 1989 |
| SHETLAND HOTELS (LERWICK) LIMITED | 03 oct 1968 | 03 oct 1968 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 jun 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 mar 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 30 jun 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 08 sept 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 ago 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2025 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2024 | 31 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2024 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 28 jun 2024
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christian Karl Nothhaft como director el 15 may 2024 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Chew Seong Aun como director el 15 may 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2023 | 34 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Gavin Stephen Taylor el 10 feb 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Richard Edward Hutton como director el 09 oct 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2023 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Estado de capital tras una asignación de acciones el 30 mar 2023
| 3 páginas | SH01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2022 | 34 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jonathan Mark Scott como director el 07 feb 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Memorándum y Estatutos | 6 páginas | MA | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Jonathan Mark Scott como director el 05 dic 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed glh hotels management (uk) LIMITED\certificate issued on 01/11/22 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Ms Cynthia Cheng el 14 oct 2022 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 30 jun 2021 | 37 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 ago 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Notification de Glh Ip Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2017 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Leng Chan Quek en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 20 jun 2017 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Chew Seong Aun como director el 02 ago 2021 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABBERTON-COE, Richard | Secretario | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | 262955090001 | |||||||
| CHENG, Cynthia | Director | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | Hong Kong | Hong Konger | 283808200002 | |||||
| HUTTON, Richard Edward | Director | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | England | British | 314463350001 | |||||
| NOTHHAFT, Christian Karl | Director | Central Street EC1V 8AJ London 110 England | Hong Kong | German | 323131720001 | |||||
| TAYLOR, Gavin Stephen | Director | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | England | British | 123305580002 | |||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Secretario | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| BLACKWELL, Seok Hui, Ms. | Secretario | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | Singaporean | 140636810001 | ||||||
| BOLTON, George Francis | Secretario | 61 Comiston View EH10 6LZ Edinburgh Midlothian | British | 6950001 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Secretario | Swallow Cottage Main Road North HP4 1QZ Dagnall Herts | British | 82666030004 | ||||||
| DURANT, Ian Charles | Secretario | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | British | 150020002 | ||||||
| HIRANI, Sheena | Secretario | Sandhurst Road NW9 9LJ London 113 United Kingdom | British | 131588880004 | ||||||
| HOWDEN, Graham | Secretario | 56 Tinshill Road LS16 7DU Leeds West Yorkshire | British | 116608840001 | ||||||
| HSIEH-LIN, Jeanette Ling | Secretario | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | 175606320001 | |||||||
| KEDDIE, Fiona | Secretario | Level 6 124-125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | 166644930001 | |||||||
| MCGUIRK, Julie | Secretario | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | Other | 140811890001 | ||||||
| MUI, Susan Lim Geok | Secretario | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | 178139340001 | |||||||
| NG, Jocelyn | Secretario | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | 165860420001 | |||||||
| AMARSI, Arun | Director | Suite Flat 1 Bostock House 97-99 Park Street W1K 7HA London | United Kingdom | New Zealand | 79964960003 | |||||
| BAILEY, Steven Clive | Director | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | United Kingdom | British | 95753690002 | |||||
| BAXANDALL, Catherine Elizabeth | Director | Bordley Easby Drive LS29 9BE Ilkley West Yorkshire | British | 27825440001 | ||||||
| BOYLE, Andrew Iain | Director | 28 Woodhill Rise Cookridge LS16 7DB Leeds West Yorkshire | British | 58475810001 | ||||||
| BURKE, Michael Ian | Director | 24 Talbot Road Highgate N6 4QR London | British | 58500900003 | ||||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Director | Swallow Cottage Main Road North HP4 1QZ Dagnall Herts | United Kingdom | British | 82666030004 | |||||
| CATTERMOLE, Ian Kendall | Director | Swallow Cottage Main Road North HP4 1QZ Dagnall Herts | United Kingdom | British | 82666030004 | |||||
| DANGERFIELD, Tony Matthew | Director | 81 Wattleton Road HP9 1RS Beaconsfield Buckinghamshire | New Zealand | 85590000001 | ||||||
| DENOMA, Michael Bernard | Director | Albyn Terrace AB10 1YP Aberdeen 13 Scotland | United Kingdom | American | 172368780002 | |||||
| DURANT, Ian Charles | Director | 57 The Avenue Kew TW9 2AL Richmond Surrey | United Kingdom | British | 150020002 | |||||
| FAIRLEY, Neil Duff | Director | 72 Carr Road Calverley LS28 5RH Leeds West Yorkshire | England | British | 78198900001 | |||||
| FIGGE, Heiko | Director | Cambridge Street G2 3HN Glasgow 36 | United Kingdom | German | 151977350003 | |||||
| GALLAGHER, Neil | Director | Level 6 124-125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | England | British | 192634310024 | |||||
| HARRISON, Martin | Director | 3 Ellesmere Road TW1 2DJ Twickenham London | British | 72249470001 | ||||||
| HERBERT, Peter Michael | Director | Level 6 124-125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | England | British | 179772960001 | |||||
| HIRANI, Sheena | Director | The Glasgow Thistle Hotel 36 Cambridge Street G2 3HN Glasgow | England | British | 131588880004 | |||||
| HO, Kah Meng | Director | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | Singapore | Malaysian | 190005810001 | |||||
| HUGHES, Andy | Director | Cambridge Street G2 3HN Glasgow 36 Scotland | United Kingdom | British | 158531230001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CLERMONT HOTEL MANAGEMENT LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glh Ip Holdings Limited | 20 jun 2017 | Central Street EC1V 8AJ London 110 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Mr Leng Chan Quek | 06 abr 2016 | 2 Semple Street EH3 8BL Edinburgh C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp Scotland | Sí | ||||||||||
Nacionalidad: Malaysian País de residencia: Malaysia | |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0