EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Activa |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC048530 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
- Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. (74909) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Dirección de la sede social | 27 George Street EH2 2PA Edinburgh Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Vencido | No |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 may 2026 |
| Próximas cuentas vencen el | 28 feb 2027 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 may 2025 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 21 feb 2026 |
|---|---|
| Próxima declaración de confirmación vence | 07 mar 2026 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 21 feb 2025 |
| Vencido | No |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 31 may 2025 | 14 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2025 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 107 George Street Edinburgh EH2 3ES Scotland a 27 George Street Edinburgh EH2 2PA el 31 ene 2025 | 1 páginas | AD01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2024 | 31 páginas | AA | ||
Nombramiento de Ms Jill Shaw Andrew como director el 27 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Nombramiento de Caitlin Mary Keegan como director el 27 nov 2024 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Michael Joseph Maloco como director el 27 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Cese del nombramiento de Kevin Mcluskey como director el 27 nov 2024 | 1 páginas | TM01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2023 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Bruce Spence como director el 01 ene 2023 | 2 páginas | AP01 | ||
Cese del nombramiento de Ann Elizabeth Fleming como director el 31 dic 2022 | 1 páginas | TM01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2022 | 31 páginas | AA | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Nombramiento de Mr Ben Daniel Cook como director el 01 ene 2022 | 2 páginas | AP01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2021 | 31 páginas | AA | ||
Cese del nombramiento de Alexander Ogilvie Pratt como director el 30 nov 2021 | 1 páginas | TM01 | ||
Nombramiento de Mr Peter Ronald Rutherford Sturrock como director el 01 oct 2021 | 2 páginas | AP01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
Cuentas consolidadas preparadas hasta el 31 may 2020 | 31 páginas | AA | ||
Cambio de datos del director Miss Ann Elizabeth Fleming el 17 dic 2020 | 2 páginas | CH01 | ||
Cese del nombramiento de Gordon John Kerr como director el 24 nov 2020 | 1 páginas | TM01 | ||
Domicilio social registrado cambiado de 90a George Street Edinburgh Midlothian EH2 3DF a 107 George Street Edinburgh EH2 3ES el 07 nov 2020 | 1 páginas | AD01 | ||
Declaración de confirmación presentada el 21 feb 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||
¿Quiénes son los directivos de EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPENCE, Bruce | Secretario | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | British | 95715240001 | ||||||
| ANDREW, Jill Shaw | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 276348490001 | |||||
| COOK, Ben Daniel | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | United Kingdom | British | 225993700001 | |||||
| DIAMOND, Andrew Russell | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 172941410001 | |||||
| HILTON, Paul | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 182537820001 | |||||
| KEEGAN, Caitlin Mary | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | Irish | 329802400001 | |||||
| MORGAN, Claire Louise | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 264149610001 | |||||
| SPENCE, Bruce | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 303819130001 | |||||
| STURROCK, Peter Ronald Rutherford | Director | George Street EH2 2PA Edinburgh 27 Scotland | Scotland | British | 278829110001 | |||||
| MORTON FRASER | Secretario corporativo | 30/31 Queen Street EH2 1JX Edinburgh Midlothian | 61803790002 | |||||||
| AIKEN, Peter David | Director | Westwood Kings Road EH32 0NN Longniddry East Lothian | British | 1335570001 | ||||||
| BORROWMAN, David Haig | Director | Elmbank Lovers Loan FK14 7AB Dollar Clackmannanshire | British | 116941900001 | ||||||
| BROWN, Scott Alexander | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | Scottish | 80426870003 | |||||
| CALDER, Susan Jane | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | British | 91161970001 | |||||
| CLARK, George Barrie | Director | 7 Newbattle Terrace EH10 4RU Edinburgh | United Kingdom | British | 476120001 | |||||
| CLARK, James Graham | Director | East Wing Laverockdale House 68 Dreghorn Loan EH13 0DB Edinburgh Midlothian | British | 817710001 | ||||||
| CUBIE, Andrew, Sir | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | United Kingdom | British | 11741100003 | |||||
| DRYSDALE, Thomas Henry | Director | 14 Murrayfield Drive EH12 6EB Edinburgh | British | 205210001 | ||||||
| FAIRWEATHER, Ian Cameron | Director | 14 Ravelston House Road EH4 3LR Edinburgh | Scotland | British | 728930002 | |||||
| FLEMING, Ann Elizabeth | Director | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 230533090002 | |||||
| FORSTER, Craig Mercer | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | British | 157551260001 | |||||
| GIFFORD, David Alan | Director | 43 Woodlands Drive Crossford KY12 8QE Dunfermline Fife | British | 133940001 | ||||||
| GIFFORD, Douglas Dale | Director | Hallburn Cottage Crieff Road KY12 9TB Hillend Fife | British | 83809090001 | ||||||
| HARTLEY, Alan James | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | United Kingdom | British | 73024380001 | |||||
| HOWIE, Robert Steuart | Director | 7 Hillpark Brae EH4 7TD Edinburgh | United Kingdom | British | 476150003 | |||||
| HUNTER, Stewart Lindsay Wilson | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | British | 65745580005 | |||||
| KERR, Gordon John | Director | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 4668400001 | |||||
| LOUDON, Richard Donald | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | British | 273830001 | |||||
| MALOCO, Michael Joseph | Director | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 112727220001 | |||||
| MARSHALL, Stewart Young | Director | Laurelbank Park Road EH3 6LA Dalkeith Midlothian | United Kingdom | British | 383740002 | |||||
| MCEWAN, Ronald John | Director | 90a George Street Edinburgh EH2 3DF Midlothian | Scotland | British | 181234880001 | |||||
| MCLUSKEY, Kevin | Director | George Street EH2 3ES Edinburgh 107 Scotland | Scotland | British | 253126280001 | |||||
| MUIR, William Affleck | Director | 63 Belgrave Road Corstorphine EH12 6NH Edinburgh | British | 35517210002 | ||||||
| PATERSON, Dianne Elizabeth | Director | 18 Clarendon Crescent EH4 1PU Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 81218360001 | |||||
| PEDDIE, Kyle Arthur David | Director | 29 Hermitage Gardens EH10 6AZ Edinburgh | Scotland | British | 167470400001 |
¿Cuáles son las últimas declaraciones sobre personas con control significativo para EDINBURGH SOLICITORS' PROPERTY CENTRE LIMITED?
| Notificado el | Cesado el | Declaración |
|---|---|---|
| 21 feb 2017 | La empresa sabe o tiene motivos razonables para creer que no existe ninguna persona registrable o entidad jurídica relevante registrable en relación con la empresa. |
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0