SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaSALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC049239
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    • Otra venta al por menor de nuevos productos en tiendas especializadas (no galerías de arte comerciales ni ópticos) (47789) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas

    ¿Dónde se encuentra SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Dirección de la sede social
    1 Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    SALON SERVICES (HAIRDRESSING SUPPLIES) LIMITED27 sept 197127 sept 1971

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta30 sept 2021

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cuentas de exención total completas preparadas hasta el 30 sept 2021

    10 páginasAA

    Estado de capital el 12 abr 2022

    • Capital: GBP 1
    5 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resoluciones

    £2,460,344 standing to the credit of the company's capital contribution reserve capitalised to sally uk holdngs LTD 26/01/2022
    RES13
    incorporation

    Resolución de modificación de los Artículos de Asociación

    RES01

    Estado de capital tras una asignación de acciones el 26 ene 2022

    • Capital: GBP 2,465,344
    3 páginasSH01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2022 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2020

    11 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2021 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2019

    14 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2020 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Nina Azemoudeh como secretario el 13 nov 2019

    1 páginasTM02

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2018

    15 páginasAA

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cuentas completas preparadas hasta el 30 sept 2017

    14 páginasAA

    Cese del nombramiento de Joanne Sarah Finch como director el 30 mar 2018

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Ms Heidi Van Ocken como director el 23 mar 2018

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Olivier Badezet como director el 23 mar 2018

    2 páginasAP01

    Declaración de confirmación presentada el 08 feb 2018 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    Modification des détails de Sally Uk Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 07 feb 2018

    2 páginasPSC05

    ¿Quiénes son los directivos de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BADEZET, Olivier
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Director
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    FranceFrench245094380001
    SCARR, Warren Peter
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    EnglandBritish187830740001
    VAN OCKEN, Heidi
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    Director
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Ground Floor, Inspired,
    Berkshire
    England
    BelgiumBelgian245092140001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Secretario
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    British610080001
    AZEMOUDEH, Nina
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Secretario
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    British148931910001
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Secretario
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    British76739920001
    AITKEN, Brian
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    Director
    6 Balruddery Place
    Bishopbriggs
    G64 1JB Glasgow
    ScotlandBritish610080001
    BURNS, Margaret Bell
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Director
    8 Windhill Park
    Waterfoot, Eaglesham
    G76 0HH Glasgow
    Scotland, UkBritish55852770003
    CONNOLLY, Michael John
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    Director
    73 Lochhead Avenue
    Lochwinnoch
    PA12 4AW Glasgow
    Renfrewshire
    United KingdomBritish117746340001
    DEWEY, Michael John
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    UkAmerican199356850001
    DIAMOND, Robin C
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    Director
    Glavecottage, 41 Spa Road
    BT24 8PT Ballynahinch
    Co.Down
    British610710006
    FAULKNER, Mark
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    Director
    Wolf Run
    76226 Bartonville
    304
    Texas
    Usa
    UsaAmerican136766440001
    FINCH, Joanne Sarah
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    Director
    Rutland Court
    EH3 8EY Edinburgh
    1
    Scotland
    United KingdomBritish158146620001
    HEGARTY, Gerard P
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    Director
    Glen Imm
    KA7 4ES Alloway
    Ayrshire
    ScotlandBritish610090002
    HEGARTY, Maureen
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    Director
    Glen Imm
    Alloway
    Ayrshire
    Scotland
    British17646720001
    HULL, Richard George
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    Director
    Belvedere House
    Belvedere Drive
    RG14 7DB Newbury
    Berkshire
    EnglandBritish108758410001
    MACDONOUGH, Gordon S
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    Nethermill Drumore Road
    Killearn
    G63 9NX Glasgow
    Lanarkshire
    ScotlandBritish610120003
    NICHOLSON, Alistair
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    Director
    1a Bellvue Road
    Kirkintilloch
    Glasgow
    British610690007
    NORTH, David John
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    Director
    White Lodge
    4 Hill Rise
    SL9 9BH Chalfont St Peter
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish76739920001
    PECKHAM, Stephen
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    Director
    Wharfedale Road
    Winnersh Triangle
    RG41 5TP Wokingham
    210
    Berkshire
    Uk
    EnglandBritish69764870003
    POSTON, John
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    Director
    5 Minoru Place
    RG42 4HS Binfield
    Berkshire
    American97966830002
    WINTERHALTER, Gary Gene
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    Director
    702 Sunny Haven Court
    Highland Village
    Texas 75077
    United States
    American113530080001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD.?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    Sally Uk Holdings Limited
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    06 abr 2016
    Easthampstead Road
    RG12 1YQ Bracknell
    Inspired, Ground Floor
    Berkshire
    England
    No
    Forma jurídicaCompany Limited By Shares
    País de registroEngland
    Autoridad legalCompanies Act 2006
    Lugar de registroRegister Of Companies
    Número de registro05836805
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.

    ¿Tiene SALON SERVICES (HAIR AND BEAUTY SUPPLIES) LTD. alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 30 ene 2004
    Entregado el 16 feb 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease over block 7, evanton drive, thornliebank industrial estate, glasgow GLA124713 GLA15264.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 16 feb 2004Registro de un cargo (410)
    • 10 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 20 jun 1990
    Entregado el 02 jul 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Plot 69 (flat 83/8) lancefield quay glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 02 jul 1990Registro de una carga
    • 05 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 abr 1989
    Entregado el 20 abr 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    2.37 acres at hillington industrial estate, glasgow (82/90 kelvin avenue, hillington).
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 abr 1989Registro de una carga
    • 10 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 ene 1989
    Entregado el 23 ene 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The dome, 66/74 broomielaw glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 23 ene 1989Registro de una carga
    • 10 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 abr 1988
    Entregado el 14 abr 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Ground lying north of broomielaw containing 197 square yards and 5 square feet.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 14 abr 1988Registro de una carga
    • 10 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 feb 1988
    Entregado el 22 feb 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    5-9 oswald street, glasgow 3-9 oswald street, glasgow 54-62 broomielaw, glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 22 feb 1988Registro de una carga
    • 10 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 14 feb 1986
    Entregado el 27 feb 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    29/31/33/35 bridge st, glasgow 151/153/155 oxford st, glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 27 feb 1986Registro de una carga
    • 05 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 26 mar 1984
    Entregado el 12 abr 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Lease 12A cloisters court see page 2 doc 51.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 12 abr 1984Registro de una carga
    • 15 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 sept 1981
    Entregado el 25 nov 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Subjects north east of said subjects.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 nov 1982Registro de una carga
    • 05 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 07 sept 1981
    Entregado el 25 nov 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    134 to 150 broomielaw, 4 to 12 james watt street, glasgow.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 25 nov 1982Registro de una carga
    Floating charge
    Creado el 23 nov 1976
    Entregado el 01 dic 1976
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 01 dic 1976Registro de una carga
    • 22 feb 2007Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Gr. Midlothian standard security
    Creado el 12 nov 1975
    Entregado el 20 nov 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Ground floor & basement premises known as 50/52 bernard st. Leith, in the city of edinburgh & county of midlothian.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 nov 1975Registro de una carga
    • 05 dic 2006Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0