R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC050238 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
- Comercio al por mayor no especializado (46900) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
| Dirección de la sede social | 240 Edmiston Drive Glasgow G51 2YT |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2016 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 11 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Cancelación total de la carga 6 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Notification de Wesco Aircraft International Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 sept 2016 | 2 páginas | PSC02 | ||||||||||
Cessation de Haas Tcm Group of the Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 26 sept 2016 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 8 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 05 dic 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 dic 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Denise Frances Callaghan como director el 23 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Denise Frances Callaghan como director el 23 nov 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2014 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Andrew Drummond como director el 31 ago 2012 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Alexander Murray como director el 30 abr 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thaddeus Jude Fortin como director el 31 dic 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Greg Alan Hann como director el 31 mar 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Evan Gutknecht como director el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Gerald Holland como secretario el 30 abr 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James Evan Gutknecht como secretario el 30 abr 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr John Gerald Holland como director el 22 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Greg Alan Hann como director el 22 sept 2014 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Bock como director el 05 sept 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shireen Elizabeth Greer como director el 28 feb 2014 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 05 dic 2014 avec liste complète des actionnaires | 10 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLLAND, John Gerald | Secretario | Avenue Stanford 91355 Valencia 24911 California United States | 197845820001 | |||||||
| HOLLAND, John Gerald | Director | Avenue Stanford 91355 Valencia 24911 California United States | United States | American | 196794230001 | |||||
| MURRAY, Alexander | Director | Avenue Stanford 91355 Valencia 24911 California United States | United States | British | 197848860001 | |||||
| RENEHAN, Thomas Scott | Director | Crawley RH10 9TY West Sussex Newton Road United Kingdom | United States | American | 166618190001 | |||||
| BEAUMONT, Richard John Kirby | Secretario | 10 Milverton Terrace CV32 5BA Leamington Spa Warwickshire | British | 98953190001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Secretario | Thornbury Cottage Chalkhill Coleshill HP7 0LY Amersham Buckinghamshire | British | 61929330004 | ||||||
| DUNCAN, James Crabb | Secretario | 20 Hawthorn Avenue PA8 7BU Erskine Renfrewshire | British | 58711040001 | ||||||
| GUTKNECHT, James Evan, Mr. | Secretario | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | United States | 118752400001 | ||||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Secretario | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| MACGREGOR, Iain Roberts | Secretario | 331 Glasgow Road PA1 3BA Paisley Renfrewshire | Scottish | 64083150002 | ||||||
| MCBURNEY, James | Secretario | Backwood Hall East Boathouse Lane CH64 3SZ Parkgate Neston | British | 5855500001 | ||||||
| WILSON, Angela Marie | Secretario | 96 Hamilton Avenue G41 4EX Glasgow | British | 37051750003 | ||||||
| BEAUMONT, Richard John Kirby | Director | 10 Milverton Terrace CV32 5BA Leamington Spa Warwickshire | British | 98953190001 | ||||||
| BOCK, William | Director | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | Usa | Us Citizen | 150691740001 | |||||
| BOUCHER, Jonathan | Director | 33 Taylor Lane 10528 NY Harrison New York | American | 129903800001 | ||||||
| BROWNLEE, Albert Christopher | Director | 20 Lochend Drive Bearsden G61 1ED Glasgow Lanarkshire | British | 191410002 | ||||||
| BRUCE, Jean | Director | 36 Neilsland Square G53 5HA Glasgow Lanarkshire | British | 191420001 | ||||||
| CALLAGHAN, Denise Frances | Director | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | Scotland | British | 88627250002 | |||||
| DRUMMOND, Andrew | Director | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | British | 48912830001 | ||||||
| FORTIN, Thaddeus Jude | Director | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | United States | 129904110001 | ||||||
| GREER, Shireen Elizabeth, Mrs. | Director | Newton Road Crawley RH10 9TY West Sussex Haas Group International United Kingdom | Usa | British | 163159520001 | |||||
| GUTKNECHT, James Evan, Mr. | Director | Newton Road RH10 9TY Crawley Aeropia House West Sussex United Kingdom | Usa | United States | 118752400001 | |||||
| HANN, Greg Alan | Director | Avenue Stanford 91355 Valencia 24911 California Usa | California Usa | American | 196785890001 | |||||
| HOBBS, Jeffrey Jacques | Director | 1 Cedar Copse BR1 2NY Bromley Kent | British | 3252730001 | ||||||
| HU, Eion | Director | 177 East, 79th St, Apt.9 10075 NY New York New York United States | United States | 129904070001 | ||||||
| LIDDLE, Matthew | Director | 54 High Street MK45 5DY Flitton Bedfordshire | United Kingdom | British | 35090550001 | |||||
| MARTIN, David Barrington | Director | 6 Copse Lane The Copse Hamble SO31 4QH Southampton | British | 44386840006 | ||||||
| MCBURNEY, James | Director | Backwood Hall West Boathouse Lane CH64 3SZ Parkgate Neston | England | British | 191400001 | |||||
| MOSS, Andrew Brian | Director | Saddlebow Cottage Saddlebow Lane CV35 8PQ Claverdon Warwickshire | England | British | 161928410001 | |||||
| ROBERTSON, Douglas Grant | Director | Blackmore Grange Blackmore End WR8 0EE Hanley Swan Worcestershire | England | British | 123487130001 | |||||
| SNOWDON, Clive John | Director | New End Barn Spernall Lane Great Alne B49 6JD Alcester Warwickshire | United Kingdom | British | 32242700001 | |||||
| WILLARD, Dean | Director | Ronda Road 93953 CA Pebble Beach 3961 California | Other | 129662730001 | ||||||
| WILSON, Angela Marie | Director | 96 Hamilton Avenue G41 4EX Glasgow | British | 37051750003 | ||||||
| WILSON, William | Director | Sheildaig Farm Upeer Stoneymollan Road Balloch Alexandria | British | 191390003 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wesco Aircraft International Holdings Limited | 26 sept 2016 | Riverside Drive BD19 4DH Cleckheaton Lawrence House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
| Haas Tcm Group Of The Uk Limited | 06 abr 2016 | Crawley RH10 9TY West Sussex Newton Road United Kingdom | Sí | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 01 feb 2012 Entregado el 21 feb 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 19 ene 2010 Entregado el 06 feb 2010 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 ene 1997 Entregado el 17 feb 1997 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 31 dic 1992 Entregado el 19 ene 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Plot of ground extending to 753.27 square metres or thereby at crown street ayr known as and forming 13 to 17 crown street ayr. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 27 may 1991 Entregado el 17 jun 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Flat 5, 34 speirs wharf, glasgow gla 77844. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 oct 1988 Entregado el 08 nov 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole property of the company and undertakings. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene R.D. TAYLOR & COMPANY LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0