CASTLE STREET NOMINEES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | CASTLE STREET NOMINEES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada por garantía sin capital social |
| Número de empresa | SC050721 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | No |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
- Empresa inactiva (99999) / Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales
¿Dónde se encuentra CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Rathbones Group Plc 10 George Street EH2 2PF Edinburgh |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 30 sept 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 30 jun 2025 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jun 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 09 jul 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 25 jun 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Domicilio social registrado cambiado de C/O Rathbones Group Plc 10 George Street Edinburgh EH2 2PF a C/O Rathbones Group Plc 10 George Street Edinburgh EH2 2PF el 10 jul 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 10 George Street Edinburgh EH2 2PF Scotland a C/O Rathbones Group Plc 10 George Street Edinburgh EH2 2PF el 03 jul 2025 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Christopher David Peto como director el 16 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Iain William Hooley como director el 16 jun 2025 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Robert Paul Stockton como director el 16 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Simon Thomas Lloyd como director el 16 jun 2025 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de William Ruthven Gemmell como director el 18 dic 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Quartermile One Lauriston Place Edinburgh EH3 9EN Scotland a 10 George Street Edinburgh EH2 2PF el 05 jul 2024 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours prolongé du 31 mar 2024 au 30 sept 2024 | 1 páginas | AA01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Jennifer Elizabeth Mathias como director el 31 dic 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 2 páginas | AA | ||||||||||
Cambio de datos del director Ms Jennifer Elizabeth Mathias el 17 oct 2023 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Ali Johnson como secretario el 21 sept 2023 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Nombramiento de Ms Jennifer Elizabeth Mathias como director el 21 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Robert Paul Stockton como director el 21 sept 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 25 jun 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Murray Asset Management Uk Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 28 feb 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 3 Glenfinlas Street Edinburgh EH3 6AQ a Quartermile One Lauriston Place Edinburgh EH3 9EN el 08 feb 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Details Removed Under Section 1095 como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de Hugh Patrick Younger como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Carole Hope como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de John Kenneth Scott Moncrieff como director el 31 ene 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 2 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNSON, Ali | Secretario | 10 George Street EH2 2PF Edinburgh C/O Rathbones Group Plc | 314203840001 | |||||||
| HOOLEY, Iain William | Director | Gresham Street EC2V 7QN London 33 England | England | British | 153896520001 | |||||
| PETO, Christopher David | Director | Gresham Street EC2V 7QN London 33 England | England | British | 336948990001 | |||||
| MBM SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Secretario corporativo | Floor 125 Princes Street EH2 4AD Edinburgh 5th United Kingdom | 133157900001 | |||||||
| MURRAY BEITH MURRAY WS | Secretario corporativo | 39 Castle Street EH2 3BH Edinburgh Midlothian | 660870001 | |||||||
| ADDIS, Neil Michael | Director | 65 South Beechwood EH12 5YS Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 91852100001 | |||||
| BELL, Jonathan Richard Miles | Director | 29 Ladysmith Road EH9 3EU Edinburgh Midlothian | British | 71586100002 | ||||||
| BERRY, William | Director | 11a Saxe Coburg Place EH3 5BR Edinburgh | British | 46255350002 | ||||||
| BIGGAR, John Morrison Hay | Director | 11 Cluny Gardens EH10 6BH Edinburgh Midlothian | British | 9501220001 | ||||||
| BLACK, Charles Richard | Director | 2a Abbotsford Park EH10 5DX Edinburgh | Scotland | British | 7600470004 | |||||
| BURNET, George Wardlaw | Director | Rose Court Inveresk Village EH21 7TD Musselburgh Midlothian | British | 46268800001 | ||||||
| BURNETT, Alexander Donald | Director | Netherby Road EH5 3LX Edinburgh 46 | Scotland | British | 33393540001 | |||||
| BURNS, George | Director | 26 Little Road EH16 6SQ Edinburgh Midlothian | British | 44196850001 | ||||||
| CALDER, David William | Director | 8 Cypress Glade Adambrae EH54 9JH Livingston West Lothian | Scotland | British | 91852220001 | |||||
| FILLEUL, Richard Frederic | Director | 12 Keith Place KY12 7SR Dunfermline Fife | British | 201380002 | ||||||
| FINLAYSON, William Alexander | Director | 6 Garscube Terrace EH12 6BQ Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 39300940001 | |||||
| FLYNN, Austin | Director | 15 Ross Gardens EH9 3BS Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 87705150001 | |||||
| FORD, Patrick John | Director | 1 St Vincent Street EH3 6SW Edinburgh Midlothian | British | 774340001 | ||||||
| FORD, Patrick John | Director | 3 Comely Bank Row EH4 1DZ Edinburgh | British | 2395340001 | ||||||
| GEMMELL, William Ruthven | Director | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 37153310003 | |||||
| GERVER, Alexander Nathaniel | Director | 1 Orchardhead Loan EH16 6HW Edinburgh | British | 41137970002 | ||||||
| HARVEY-JAMIESON, Rodger Ridout | Director | 19 Dean Terrace EH4 1NL Edinburgh | Scotland | British | 34336790001 | |||||
| HOGFORS-STEWART, Eva Elisabeth | Director | 11 Russell Place EH5 3HQ Edinburgh Midlothian | Swedish | 774350001 | ||||||
| HOPE, Carole | Director | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | Scotland | British | 29441180002 | |||||
| LLOYD, Simon Thomas | Director | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | United Kingdom | British | 71586130002 | |||||
| LOCKE, Margaret Luise Stirling | Director | 22 Melville Terrace EH9 1LR Edinburgh Midlothian | British | 774360001 | ||||||
| MATHIAS, Jennifer Elizabeth | Director | Lauriston Place EH3 9EN Edinburgh Quartermile One Scotland | Wales | British | 121078120005 | |||||
| MORE, Francis Adam John | Director | 12 Kingsburgh Road EH12 6DZ Edinburgh Midlothian | British | 247000001 | ||||||
| POLLOCK, Nigel James | Director | Newmains Dryburgh St Boswells TD6 0RQ Melrose Roxburghshire | Scotland | British | 335320002 | |||||
| ROBSON, Michael Gordon | Director | The Old School House 2, Baird Road EH28 8RA Ratho Edinburgh | Scotland | British | 123980270001 | |||||
| SCOTT, Graham William Richard | Director | 102 Polwarth Gardens EH11 1LH Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 116107210001 | |||||
| SCOTT MONCRIEFF, John Kenneth | Director | Glenfinlas Street EH3 6AQ Edinburgh 3 United Kingdom | Scotland | British | 42638160001 | |||||
| STEPHEN, Andrew Johnston | Director | 7 St. Ronans Terrace EH10 5NG Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 87241840001 | |||||
| STEWART, Mark Edward | Director | 2f1, 10 Forbes Road EH10 4ED Edinburgh Midlothian | British | 66954940001 | ||||||
| STOCKTON, Robert Paul | Director | George Street EH2 2PF Edinburgh 10 Scotland | England | British | 120520560001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de CASTLE STREET NOMINEES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray Asset Management Uk Limited | 06 abr 2016 | Gresham Street EC2V 7QN London 30 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene CASTLE STREET NOMINEES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0