PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC050835 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Dirección de la sede social | Halliburton House Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| NORTH SEA ASSETS LIMITED | 22 jun 1972 | 22 jun 1972 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2018 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gaceta final disuelta tras la liquidación | 1 páginas | GAZ2 | ||||||||||
Cuenta final antes de la disolución en MVL (cuenta final adjunta) | 12 páginas | LIQ13(Scot) | ||||||||||
Cese del nombramiento de Martin Robert White como director el 31 dic 2021 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Estado de capital el 17 sept 2020
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nombramiento de Mr Wael Mekkawy como director el 01 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 3 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Nombramiento de Shaikh Usman como director el 28 feb 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Thomas Kuzhuvommannil Mathew como director el 28 feb 2020 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Scot Clifton el 02 abr 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2018 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2017 | 14 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Matthew Betts como director el 08 dic 2017 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Robert White como director el 08 dic 2017 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2016 | 13 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 jun 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 07 jun 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLIFTON, Scot | Secretario | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | British | 139856420001 | ||||||
| CLIFTON, Scot | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | Scotland | British | 139856420001 | |||||
| MEKKAWY, Wael | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | Scotland | Egyptian | 264116610002 | |||||
| USMAN, Shaikh | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | Indian | 269146770001 | |||||
| BROWN, Graham Christopher | Secretario | Flat 4 82 Belsize Park Gardens Hampstead NW3 4NG London | British | 106493880001 | ||||||
| CRAWLEY, Peter John | Secretario | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 91521200006 | ||||||
| DAVIS, Richard Paul | Secretario | Ambersham House Estuary Crescent Shotley Gate IP9 2QA Ipswich Suffolk | British | 9506230001 | ||||||
| DEERING, John Edward | Secretario | Blenheim Place AB25 2DL Aberdeen 129 Aberdeenshire | British | 131261430001 | ||||||
| FARLEY, Andrew Daniel | Secretario | Flat 1 22 Harcourt Terrace SW10 9JR London | British | 75086910001 | ||||||
| FLINDERS, Harold Derek | Secretario | 23 Thetford Road KT3 5DN New Malden Surrey | British | 65317780001 | ||||||
| GARRETT, Anthony John | Secretario | 8 Grasmere Close GU1 2TG Guildford Surrey | British | 220420001 | ||||||
| GLYNN, Andrew David | Secretario | 44 Holburn Road AB10 6ET Aberdeen | British | 54450910002 | ||||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Secretario | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| ORR, Raymond William | Secretario | 19 Lawson Avenue AB31 3TW Banchory Kincardineshire | British | 1179560001 | ||||||
| TOCHER, Judith Robertson | Secretario | Blacktop House, Blacktop Kingswells AB15 8QJ Aberdeen | British | 82086030001 | ||||||
| WILLIAMS, Michael James John | Secretario | West Steading Mains Of Inverey AB3113NY Banchory Kincardineshire | British | 54494520001 | ||||||
| BETTS, Matthew | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | British | 119391640001 | |||||
| BOWYER, Michael Lewis | Director | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 43449270009 | ||||||
| BUCHANAN, Alasdair Ian | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House Scotland | Scotland | British | 162046510001 | |||||
| CHAPMAN, Gordon Robin | Director | Pen Y Bryn Upper Raby Road CH64 7TY Neston Cheshire | England | British | 29030650001 | |||||
| CRAVEN WALKER, Antony | Director | Square Du Val De La Cambre 3 1050 Bruxelles Belgium | British | 70900640001 | ||||||
| DENMAN, Henry Wynne | Director | The Penthouse Old Avenue St Georges Hill KT13 0QB Weybridge Surrey | British | 771670001 | ||||||
| FITZGERALD, Mel Oliver | Director | 3 Marlyns Drive Burpham GU4 7LS Guildford Surrey | United Kingdom/England | Irish | 69993790001 | |||||
| FORD, Gregory Brent | Director | 7 Prospect Hill Road Bielside AB15 9AN Aberdeen | Usa | 54533770001 | ||||||
| HEATH, Stuart Matthew | Director | Beside Novotel Hotel Trade Centre PO BOX 3111 Dubai 8th Floor Convention Tower United Arab Emirates | United Arab Emirates | British | 173991180001 | |||||
| HERD, Ian Riddoch Williamson | Director | 49 Abbotswell Drive AB12 5QP Aberdeen | British | 77264220001 | ||||||
| HOUSTON, John Joseph | Director | Deveron Facility Howe Moss Place, Dyce AB21 0GS Aberdeen | British | 81041240005 | ||||||
| JAMES, David Noel | Director | Suite 531 Premier House 10 Greycoat Place SW1P 1SB London | British | 41668080002 | ||||||
| JOHNSTON, David Alexander | Director | Howe Moss Crescent Dyce AB21 0GN Aberdeen Halliburton House | United Kingdom | British | 125502250001 | |||||
| KALBORG, Ted Gunnar Christer | Director | 22 Pelham Crescent SW7 2NR London | England | Swedish | 8637550001 | |||||
| LINDSELL, Philip Edmund | Director | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
| MAHON, Barry Anthony | Director | 133 North Deeside Road Milltimber AB13 0JS Aberdeen | Irish | 91976230001 | ||||||
| MAIR, John Arthur | Director | 9a Ferryhill Place AB11 7SE Aberdeen | United Kingdom | British | 54533170001 | |||||
| MATHEW, Thomas Kuzhuvommannil | Director | Citibank Tower Al-Qutayat Street Dubai 14th Floor United Arab Emirates | United Arab Emirates | Indian | 186849530001 | |||||
| METSON, Peter Alexander | Director | Mayfield Malcolm Road Peterculter AB1 0NX Aberdeen Grampian | Usa | 37748950002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halliburton Holdings (No 3) | 07 jun 2016 | Howe Moss Crescent AB21 0GN Dyce Halliburton House Aberdeen United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Agreement (fixed charge) | Creado el 15 dic 1987 Entregado el 30 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All r f p shares and all f p loan notes and all fourth shares to which the company is entitled. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Agreement floating charge | Creado el 15 dic 1987 Entregado el 30 dic 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All r f p shares and all f p loan rates and all the fourth shares to which the company is entitled. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 25 ago 1986 Entregado el 05 sept 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene PETROLEUM ENGINEERING SERVICES LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0