NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED

NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaNEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC051116
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    • (6110) /

    ¿Dónde se encuentra NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    Dirección de la sede social
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    P&O NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED12 nov 200412 nov 2004
    CARAVANS INTERNATIONAL FINANCE LIMITED31 ene 199131 ene 1991
    CARAVAN FINANCE LIMITED30 dic 198830 dic 1988
    CARAVANS INTERNATIONAL FINANCE LIMITED31 jul 197231 jul 1972

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2009

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    Domicilio social registrado cambiado de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ el 02 nov 2010

    2 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 14 oct 2010

    LRESSP

    Nombramiento de Mr Martyn Clive Allen como director

    3 páginasAP01

    Cese del nombramiento de James Burridge como director

    2 páginasTM01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2009

    14 páginasAA

    legacy

    3 páginasMG02s

    legacy

    3 páginasMG02s

    Déclaration annuelle établie au 01 feb 2010 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital09 feb 2010

    Estado de capital el 09 feb 2010

    • Capital: GBP 250,000
    SH01

    Cambio de datos del secretario John Kilby el 22 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director John Kilby el 22 dic 2009

    2 páginasCH01

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2008

    14 páginasAA

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    4 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    4 páginas363a

    legacy

    1 páginas287

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2007

    14 páginasAA

    legacy

    2 páginas363a

    Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2006

    14 páginasAA

    legacy

    7 páginas363s

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Secretario
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    British76247880001
    ALLEN, Martyn Clive
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Director
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    United KingdomBritish117739980001
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Director
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    EnglandBritish76247880001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    GITTINS, Paul
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    Secretario
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    British45660860003
    NIXON, Raymond
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    Secretario
    Holly House The Steadings
    Wicker Lane, Guilden Sutton
    CH3 7EL Chester
    Cheshire
    British36433110016
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Director
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BARCLAY, William Gordon
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    Director
    The Coulin
    122 Stanstead Road
    CR3 6AE Caterham
    Surrey
    British33196560002
    BASSINDALE, Graham John
    7 Saxon Way
    CB11 4EQ Saffron Walden
    Essex
    Director
    7 Saxon Way
    CB11 4EQ Saffron Walden
    Essex
    British486580001
    BOCHENSKI, Anthony Joseph John
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    Director
    Greenacres
    Bryn Offa Lane
    CH7 6RQ Mold
    Flintshire
    United KingdomBritish145644720001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Director
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    BUSH, Claude Harry
    8 Pentre Close
    Ashton
    CH3 8BR Chester
    Director
    8 Pentre Close
    Ashton
    CH3 8BR Chester
    British427540001
    COSTELLO, Thomas
    Claddagh Shay Lane
    Oscroft
    CH3 8NW Tarvin
    Chester
    Director
    Claddagh Shay Lane
    Oscroft
    CH3 8NW Tarvin
    Chester
    British961140001
    CURREY, Robin David
    4 Dormywood
    HA4 7UW Ruislip
    Middlesex
    Director
    4 Dormywood
    HA4 7UW Ruislip
    Middlesex
    EnglandBritish2580240001
    GITTINS, Paul
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    Director
    7 Vaughans Lane
    Great Boughton
    CH3 5XF Chester
    Cheshire
    EnglandBritish45660860003
    HALLIWELL, Christopher Roger
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    Director
    3 Hough Green
    CH4 8JG Chester
    British4254150002
    HAN, Philip James
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    Director
    124 Mather Avenue
    L18 7HB Liverpool
    Merseyside
    EnglandBritish74160910001
    KING, Derek
    Landfall
    CW6 0SG Kelsall
    Cheshire
    Director
    Landfall
    CW6 0SG Kelsall
    Cheshire
    British486600001
    LARGE, Ronald Herbert
    32 Mount Drive
    CW5 6JG Nantwich
    Cheshire
    Director
    32 Mount Drive
    CW5 6JG Nantwich
    Cheshire
    British486610001
    MERCER, John Alexander
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    Director
    Llwyn-Y-Cyll
    Lixwm
    CH8 8LY Holywell
    Clwyd
    British4672880001
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Director
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Director
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PINFOLD, Roger John
    Roseland
    80 Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Director
    Roseland
    80 Camp Road
    SL9 7PB Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    EnglandEnglish486620002
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Director
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    REID, George Gibson
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    Director
    46/1 Morningside Park
    EH10 5HA Edinburgh
    Lothian
    British95498730001
    RITCHIE, Carol Ann
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    Director
    34 Hob Hey Lane
    Culcheth
    WA3 4NW Warrington
    Cheshire
    EnglandBritish46402710001
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Director
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SALVERDA, Arnold Ate
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Director
    Brugakker 6547
    3704 Rk Zeist
    Netherlands
    Dutch101663120001
    TOWN, Lindsay John
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    Director
    10 Ferndale
    TN2 3PB Tunbridge Wells
    Kent
    EnglandBritish64287260001
    TROSSELL, Steven Paul
    98 Weston Way
    CB8 7SF Newmarket
    Suffolk
    Director
    98 Weston Way
    CB8 7SF Newmarket
    Suffolk
    British1105010001
    VAN SLOBBE, Rutger Paul Marie
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Director
    Oranje Nassaulaan 54b
    FOREIGN 1075 Ar Amsterdam
    Netherlands
    Dutch97369340002
    WEBSTER, Alistair Linn
    1 Muirfield Drive
    EH52 6BU Uphall
    West Lothian
    Director
    1 Muirfield Drive
    EH52 6BU Uphall
    West Lothian
    British60101190001
    WOODERSON, Michael
    17 Mortimer Court
    KY11 9UQ Dalgety Bay
    Fife
    Director
    17 Mortimer Court
    KY11 9UQ Dalgety Bay
    Fife
    ScotlandBritish73899660001

    ¿Tiene NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Deed of mortgage
    Creado el 10 nov 2004
    Entregado el 26 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Company's right, title and interest in and to the containership M.V. p&o nedlloyd southampton.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC
    Transacciones
    • 26 nov 2004Registro de un cargo (410)
    • 24 mar 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)
    Deed of covenant
    Creado el 09 nov 2004
    Entregado el 26 nov 2004
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Right, title and interest in and to the containership M.V. p&o nedlloyd southampton.
    Personas con derecho
    • Halifax PLC
    Transacciones
    • 26 nov 2004Registro de un cargo (410)
    • 01 abr 2010Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (MG02s)

    ¿Tiene NEDLLOYD SOUTHAMPTON LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    25 ago 2011Fecha de disolución
    14 oct 2010Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0