APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaAPPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC052644
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    c/o WRIGHT, JOHNSTON & MACKENZIE LLP
    302 St. Vincent Street
    G2 5RZ Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2018

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    legacy

    1 páginasSH20

    Estado de capital el 14 ago 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2020 sin actualizaciones

    3 páginasCS01

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2019 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    Cese del nombramiento de Matthew Bishop como director el 01 ene 2019

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Mr David John Muir como director el 01 ene 2019

    2 páginasAP01

    legacy

    44 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2018 con actualizaciones

    4 páginasCS01

    legacy

    49 páginasPARENT_ACC

    legacy

    1 páginasAGREEMENT1

    legacy

    3 páginasGUARANTEE1

    Declaración de confirmación presentada el 01 jun 2017 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    legacy

    51 páginasPARENT_ACC

    legacy

    4 páginasAGREEMENT1

    legacy

    4 páginasGUARANTEE1

    ¿Quiénes son los directivos de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FINCH, Mark
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    175639530001
    FINCH, Mark Charles
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish175612870001
    MUIR, David John
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish254017640001
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Secretario
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    149299350001
    MAHAFFEY, Matthew Ian
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    Secretario
    23 St Oswalds Road
    Fulford
    YO1 4PF York
    North Yorkshire
    British507940001
    WARD, Andrew Ian
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    Secretario
    6 Coniston Way
    LS22 6TT Wetherby
    West Yorkshire
    British360770001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Secretario
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Uk74385360001
    MATHESON & CO LIMITED
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    Secretario corporativo
    3 Lombard Street
    EC3V 9AQ London
    1947590001
    ATKIN, John Richard
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    Baillie Gate
    Queens Drive
    LS29 9QW Ilkley
    West Yorkshire
    British20102900001
    BEATTIE, Craig Alan
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish177627900001
    BEYNON, Peter
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    Director
    Stonehurst Elm Lane
    Copdock
    IP8 3ET Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish38504390006
    BISHOP, Matthew
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish206755450002
    CHAMBERS, Paul Jonathan
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    Director
    24 Constable Road
    Ben Rhydding
    LS29 8RW Ilkley
    West Yorkshire
    British1188140001
    HERBERT, Mark Philip
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish123285980005
    HOUSTON, Samuel George
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    Director
    Flat 59 Medland House
    11 Branch Road
    E14 7JT London
    British75730290003
    JONES, Alun Morton
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    Director
    Fen Walk
    IP12 4BG Woodbridge
    Fen House
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish12785600004
    MACNAMARA, Richard James
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    Director
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish149294820002
    POTTS, Derek
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    Director
    55 East Street
    Coggeshall
    CO6 1SJ Colchester
    Essex
    United KingdomBritish52485510001
    RITCHIE, John Muir
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    Director
    High House
    Snipe Farm Road
    IP13 6SL Clopton
    Suffolk
    British22325820001
    STUART, John Morris
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    Director
    Cromdale 26 Foxglove Avenue
    LS8 2QR Leeds
    West Yorkshire
    British507950001
    WATSON, Deirdre Mary Alison
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    Director
    51 Park Avenue
    Hutton
    CM13 2QP Brentwood
    Essex
    EnglandUk74385360001
    WILLIAMS, Steven Wyn
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    Director
    199 Finchampstead Road
    RG40 3HE Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish54580940001
    WILLIAMSON, Michael Granville
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    Director
    Church Green
    Old Church Lane Pateley Bridge
    HG3 5LZ Harrogate
    North Yorkshire
    British57360160001
    WITT, John Raymond
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Director
    28 Westerfield Road
    IP4 2YJ Ipswich
    Suffolk
    Canadian51303670001

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    06 abr 2016
    The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9YQ Colchester
    770
    Essex
    United Kingdom
    No
    Forma jurídicaLimited By Shares
    País de registroEngland And Wales
    Autoridad legalUnited Kingdom (England And Wales)
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registro192238
    Naturaleza del control
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.
    • La persona posee, directa o indirectamente, más del 75% de los derechos de voto en la empresa.
    • La persona tiene el derecho, directa o indirectamente, de nombrar o destituir a la mayoría de la junta directiva de la empresa.

    ¿Tiene APPLEYARD PROPERTIES (SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 26 ene 1983
    Entregado el 31 ene 1983
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All moneys due, or to become due by appleyard group PLC
    Breve descripción
    1) 50.08 poles & 89.52 poles, troon ayr. 2) 3.30 acres, 0.58 acres and 0.11 acres at western road, kilmarnock, ayr.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 31 ene 1983Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 25 nov 1982
    Entregado el 10 dic 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Barclays Bank PLC
    Transacciones
    • 10 dic 1982Registro de una carga
    • Tiene modificaciones en las prohibiciones
    Standard security
    Creado el 20 sept 1982
    Entregado el 29 sept 1982
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    (I) 50.08 poles and (ii) 89.52 poles, both in the burgh of troon, parish of dundonald and county of ayr (I) 3.30 acres, (ii) 0.58 acres and (iii) 0.11 acres, all at western road, kilmarnock, ayrshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 29 sept 1982Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 20 jul 1981
    Entregado el 24 jul 1981
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    1.13 acres, 38784 square feet and 0.031 of an acre all in renfrew and 18 holmston road, ayr, ayrshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 jul 1981Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 07 oct 1980
    Entregado el 22 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    Nil, an ad fachim praestandium obligation
    Breve descripción
    Westhill, prieston road bridge of weir.
    Personas con derecho
    • David Mclintock
    Transacciones
    • 22 oct 1980Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 24 sept 1980
    Entregado el 07 oct 1980
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    The whole assets of the company.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 oct 1980Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0