RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC053733 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Dirección de la sede social | Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street G2 1BP Glasgow Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| KYLE AND CARRICK HOLDINGS LIMITED | 01 ago 1973 | 01 ago 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2022 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Ruby Dco Twenty One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||||||
Modification des détails de Ayrshire Pharmaceuticals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2023 | 2 páginas | PSC05 | ||||||||||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland a Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP el 18 sept 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Graham Wiseman como director el 31 ago 2023 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Nombramiento de Thorsten Sprank como director el 31 ago 2023 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Certificado de cambio de nombre Company name changed kyle and carrick holdings LIMITED\certificate issued on 04/09/23 | 3 páginas | CERTNM | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Estado de capital el 15 ago 2023
| 3 páginas | SH19 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 3 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2023 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 3 páginas | AA | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Wendy Margaret Hall como director el 09 sept 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Nichola Louise Legg como secretario el 09 sept 2022 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||||||||||||||
Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones | 2 páginas | SH08 | ||||||||||||||||||||||
Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones | 2 páginas | SH10 | ||||||||||||||||||||||
Declaración de los objetos de la sociedad | 2 páginas | CC04 | ||||||||||||||||||||||
Memorándum y Estatutos | 33 páginas | MA | ||||||||||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Nombramiento de Graham Wiseman como director el 07 sept 2022 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||||||||||||||
Cese del nombramiento de Christian Keen como director el 18 may 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPRANK, Thorsten | Director | Crays Avenue BR5 3RS Orpington Office 5, International House England | England | German | 203900280002 | |||||
| BRIERLEY, Jennifer Anne | Secretario | Sapphire Court Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | British | 118563210001 | ||||||
| BUCKELL, Stephen William | Secretario | Wykin House Wykin LE10 3PN Hinckley Leicestershire | British | 20341960001 | ||||||
| DAVIES, John Richard Bridge | Secretario | Amberley 5 Primrose Hill Waste Lane CW6 0PE Kelsall Cheshire | British | 51554100001 | ||||||
| GILMOUR, David Strachan | Secretario | 5 Laigh Mount KA7 4QS Ayr South Ayrshire Scotland | British | 52130850001 | ||||||
| HEATON, Janet Ruth | Secretario | 7 Hunters Row Portland Street LE9 1TQ Cosby Leicestershire | British | 81228260001 | ||||||
| LEGG, Nichola Louise | Secretario | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | 163214890001 | |||||||
| NASH, Andrew | Secretario | Lych Gates Angel Street Upper Bentley B97 5TA Redditch Worcestershire | British | 48592890001 | ||||||
| RAINEY, Gary | Secretario | 95 Greenacres KA22 7PR Ardrossan Ayrshire | British | 3535890001 | ||||||
| SADLER, John Michael | Secretario | 12 Cransley Grove B91 3ZA Solihull West Midland | British | 44018260001 | ||||||
| SMERDON, Peter | Secretario | 40 Stoneton Crescent Balsall Common CV7 7QG Coventry Warwickshire | British | 16898700002 | ||||||
| BEER, Thorsten | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 172030260001 | |||||
| COCKBURN, Henry James Kemp | Director | 16 Dalzell Avenue ML1 2BX Motherwell Lanarkshire | British | 504660001 | ||||||
| FELLOWS, Jonathan | Director | 26 Ladywood Road Four Oaks B74 2QN Sutton Coldfield West Midlands | England | British | 118296490001 | |||||
| GILBERT, George Andrew | Director | Tredawn White Plains KA7 4 Ayr | British | 469190001 | ||||||
| HALL, Wendy Margaret | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 172979860001 | |||||
| HILGER, Marcus | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Germany | German | 238936580003 | |||||
| HOOD, John | Director | 27 Medina House, Diglis Dock Road WR5 3DD Worcester | British | 39644740002 | ||||||
| JOHNSTONE, Ian | Director | 47 Adele Street ML1 2QE Motherwell Lanarkshire | Scotland | British | 58656120002 | |||||
| KEEN, Christian | Director | Hampden Park Industrial Estate G42 0PH Glasgow 204 Polmadie Road Scotland | England | British | 54544790004 | |||||
| KERSHAW, Graham Anthony | Director | Selsley House Westhorpe LE16 9UL Sibbertoft Leicestershire | United Kingdom | British | 8991780003 | |||||
| LIPP, Hanns Martin | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | United Kingdom | German | 220582440001 | |||||
| LLOYD, Allen John | Director | Yew House Freasley B78 2EY Tamworth Staffordshire | British | 2270630001 | ||||||
| LLOYD, Peter Edward | Director | Southfield Coventry Road CV8 2FT Kenilworth Warwickshire | British | 35546210001 | ||||||
| MCCONNELL, Walter Scott | Director | Braehead Of Priestgill ML10 6PS Strathaven | British | 469160001 | ||||||
| MEISTER, Stefan Mario | Director | Rosengartenstrasse 19 70184 Stuttgart Germany | Swiss | 43550520003 | ||||||
| MISCHKE, Gerhard Viktor | Director | Whitehill Farmhouse Alderminster CV37 8BW Stratford Upon Avon Warwickshire | Germany | 62107000001 | ||||||
| PRINGLE, John Stock | Director | Upper Carbarns Farm Netherton ML2 0RW Wishaw | British | 355710003 | ||||||
| RILLIE, George Davidson | Director | 11 Arnprior Place Alloway KA7 4PT Ayr Ayrshire | British | 88210002 | ||||||
| RILLIE, George Davidson | Director | 11 Arnprior Place Alloway KA7 4PT Ayr Ayrshire | British | 88210002 | ||||||
| SHEPHERD, William | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | Great Britain | British | 162873980001 | |||||
| SMERDON, Peter | Director | Walsgrave Triangle CV2 2TX Coventry Sapphire Court England | England | British | 16898700002 | |||||
| STEELE, Richard John | Director | 10 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Derbyshire | England | British | 1415570001 | |||||
| TAYLOR, Andrew James | Director | 7 Milton Gardens Calderbraes G71 6EB Uddingston | British | 29348070001 | ||||||
| TURNER, Richard Gill | Director | The Old Coach House Mill Lane Sheepy Parva CV9 3RL Atherstone Warwickshire | British | 51796560002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruby Dco Twenty One Limited | 06 abr 2016 | West George Street G2 1BP Glasgow Clyde Offices, 2nd Floor, 48 Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 04 may 1990 Entregado el 14 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Long lease of shop 178 main street auchinleck, ayrshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 04 may 1990 Entregado el 14 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 27 townhead street cumnock, ayr. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 04 may 1990 Entregado el 14 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop at 67-73 high street, maybole ayrshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 13 abr 1990 Entregado el 02 may 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 123/129 high st lanark 116/118 north vennel lanark. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 05 feb 1990 Entregado el 14 feb 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 64 mid street bathgate. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 12 oct 1989 Entregado el 20 oct 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Unit 4 & 4A glasgow road burnbank glasgow lan 57118. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 10 mar 1987 Entregado el 19 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 268 glasgow rd blantyre. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 17 nov 1986 Entregado el 04 dic 1986 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción (1) 270/272 glasgow road, blantyre (2) one up left 4 joanna terrace, blantyre one up right 4 joanna terrace blantyre regd title no lan 20237. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 1984 Entregado el 10 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises at 48 hanover street stranraer wigtownshire. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 1984 Entregado el 10 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises at 19 the foregate kilmarnock. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 1984 Entregado el 10 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises at 33 burnbank road, hamilton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 1984 Entregado el 10 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Shop premises at 57 portland place hamilton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 02 may 1984 Entregado el 10 may 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Tennents interest in lease of shop premises known as 15 burnbank centre glasgow rd burnbank. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 22 mar 1984 Entregado el 28 mar 1984 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0