RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Personas con control significativo
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRUBY DCO TWENTY TWO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC053733
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Scotland
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    KYLE AND CARRICK HOLDINGS LIMITED01 ago 197301 ago 1973

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 mar 2022

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    1 páginasDS01

    Modification des détails de Ruby Dco Twenty One Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 18 sept 2023

    2 páginasPSC05

    Modification des détails de Ayrshire Pharmaceuticals Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 04 sept 2023

    2 páginasPSC05

    Domicilio social registrado cambiado de 204 Polmadie Road Hampden Park Industrial Estate Glasgow G42 0PH Scotland a Clyde Offices, 2nd Floor, 48 West George Street Glasgow G2 1BP el 18 sept 2023

    1 páginasAD01

    Cese del nombramiento de Graham Wiseman como director el 31 ago 2023

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Thorsten Sprank como director el 31 ago 2023

    2 páginasAP01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Sole director appointment 31/08/2023
    RES13

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed kyle and carrick holdings LIMITED\certificate issued on 04/09/23
    3 páginasCERTNM
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name04 sept 2023

    Cambio de nombre por resolución

    NM01
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    change-of-name

    Resolución de cambio de nombre de la empresa el 31 ago 2023

    RES15

    Estado de capital el 15 ago 2023

    • Capital: GBP 0.01
    3 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    3 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Declaración de confirmación presentada el 27 ene 2023 con actualizaciones

    5 páginasCS01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022

    3 páginasAA

    Cese del nombramiento de Wendy Margaret Hall como director el 09 sept 2022

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Nichola Louise Legg como secretario el 09 sept 2022

    1 páginasTM02

    Cambio de nombre o denominación de la clase de acciones

    2 páginasSH08

    Detalles de la variación de los derechos vinculados a las acciones

    2 páginasSH10

    Declaración de los objetos de la sociedad

    2 páginasCC04

    Memorándum y Estatutos

    33 páginasMA

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resoluciones

    Removal of restriction on authorised share capital/ ratification of directors actions 07/09/2022
    RES13
    capital

    Resolución de asignación de valores

    RES10
    capital

    Resolución de variación de los derechos o del nombre de las acciones

    RES12
    incorporation

    Resolución de adopción de los Artículos de Asociación

    RES01

    Nombramiento de Graham Wiseman como director el 07 sept 2022

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Christian Keen como director el 18 may 2022

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    SPRANK, Thorsten
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    Director
    Crays Avenue
    BR5 3RS Orpington
    Office 5, International House
    England
    EnglandGerman203900280002
    BRIERLEY, Jennifer Anne
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Sapphire Court
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    British118563210001
    BUCKELL, Stephen William
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    Secretario
    Wykin House
    Wykin
    LE10 3PN Hinckley
    Leicestershire
    British20341960001
    DAVIES, John Richard Bridge
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    Secretario
    Amberley
    5 Primrose Hill Waste Lane
    CW6 0PE Kelsall
    Cheshire
    British51554100001
    GILMOUR, David Strachan
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    Secretario
    5 Laigh Mount
    KA7 4QS Ayr
    South Ayrshire
    Scotland
    British52130850001
    HEATON, Janet Ruth
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    Secretario
    7 Hunters Row
    Portland Street
    LE9 1TQ Cosby
    Leicestershire
    British81228260001
    LEGG, Nichola Louise
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Secretario
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    163214890001
    NASH, Andrew
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    Secretario
    Lych Gates Angel Street
    Upper Bentley
    B97 5TA Redditch
    Worcestershire
    British48592890001
    RAINEY, Gary
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    Secretario
    95 Greenacres
    KA22 7PR Ardrossan
    Ayrshire
    British3535890001
    SADLER, John Michael
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    Secretario
    12 Cransley Grove
    B91 3ZA Solihull
    West Midland
    British44018260001
    SMERDON, Peter
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    Secretario
    40 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    Warwickshire
    British16898700002
    BEER, Thorsten
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman172030260001
    COCKBURN, Henry James Kemp
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    Director
    16 Dalzell Avenue
    ML1 2BX Motherwell
    Lanarkshire
    British504660001
    FELLOWS, Jonathan
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Director
    26 Ladywood Road
    Four Oaks
    B74 2QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118296490001
    GILBERT, George Andrew
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    Director
    Tredawn White Plains
    KA7 4 Ayr
    British469190001
    HALL, Wendy Margaret
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish172979860001
    HILGER, Marcus
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    GermanyGerman238936580003
    HOOD, John
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    Director
    27 Medina House, Diglis Dock Road
    WR5 3DD Worcester
    British39644740002
    JOHNSTONE, Ian
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    Director
    47 Adele Street
    ML1 2QE Motherwell
    Lanarkshire
    ScotlandBritish58656120002
    KEEN, Christian
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    Director
    Hampden Park Industrial Estate
    G42 0PH Glasgow
    204 Polmadie Road
    Scotland
    EnglandBritish54544790004
    KERSHAW, Graham Anthony
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    Director
    Selsley House
    Westhorpe
    LE16 9UL Sibbertoft
    Leicestershire
    United KingdomBritish8991780003
    LIPP, Hanns Martin
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    United KingdomGerman220582440001
    LLOYD, Allen John
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    Director
    Yew House
    Freasley
    B78 2EY Tamworth
    Staffordshire
    British2270630001
    LLOYD, Peter Edward
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    Director
    Southfield Coventry Road
    CV8 2FT Kenilworth
    Warwickshire
    British35546210001
    MCCONNELL, Walter Scott
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    Director
    Braehead Of Priestgill
    ML10 6PS Strathaven
    British469160001
    MEISTER, Stefan Mario
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Director
    Rosengartenstrasse 19
    70184 Stuttgart
    Germany
    Swiss43550520003
    MISCHKE, Gerhard Viktor
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Director
    Whitehill Farmhouse
    Alderminster
    CV37 8BW Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Germany62107000001
    PRINGLE, John Stock
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    Director
    Upper Carbarns Farm
    Netherton
    ML2 0RW Wishaw
    British355710003
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Director
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    RILLIE, George Davidson
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    Director
    11 Arnprior Place
    Alloway
    KA7 4PT Ayr
    Ayrshire
    British88210002
    SHEPHERD, William
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Great BritainBritish162873980001
    SMERDON, Peter
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    Director
    Walsgrave Triangle
    CV2 2TX Coventry
    Sapphire Court
    England
    EnglandBritish16898700002
    STEELE, Richard John
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    Director
    10 Newton Park
    Newton Solney
    DE15 0SX Burton On Trent
    Derbyshire
    EnglandBritish1415570001
    TAYLOR, Andrew James
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    Director
    7 Milton Gardens
    Calderbraes
    G71 6EB Uddingston
    British29348070001
    TURNER, Richard Gill
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    Director
    The Old Coach House Mill Lane
    Sheepy Parva
    CV9 3RL Atherstone
    Warwickshire
    British51796560002

    ¿Quiénes son las personas con control significativo de RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED?

    Personas con control significativo
    NombreNotificado elDirecciónCesado
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    06 abr 2016
    West George Street
    G2 1BP Glasgow
    Clyde Offices, 2nd Floor, 48
    Scotland
    No
    Forma jurídicaPrivate Company Limited By Shares
    País de registroScotland
    Autoridad legalCompanies Act 1985
    Lugar de registroCompanies House
    Número de registroSc040149
    Naturaleza del control
    • La persona tiene derecho a ejercer, o ejerce efectivamente, una influencia o control significativo sobre las actividades de una sociedad civil que, según la ley que la rige, no es una persona jurídica; y los miembros de esa sociedad civil (en esa calidad) poseen, directamente o indirectamente, más del 75% de las acciones de la compañía.

    ¿Tiene RUBY DCO TWENTY TWO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 14 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Long lease of shop 178 main street auchinleck, ayrshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 may 1990Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 14 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    27 townhead street cumnock, ayr.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 may 1990Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 04 may 1990
    Entregado el 14 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop at 67-73 high street, maybole ayrshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 may 1990Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 13 abr 1990
    Entregado el 02 may 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    123/129 high st lanark 116/118 north vennel lanark.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 02 may 1990Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 05 feb 1990
    Entregado el 14 feb 1990
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64 mid street bathgate.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 feb 1990Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 12 oct 1989
    Entregado el 20 oct 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Unit 4 & 4A glasgow road burnbank glasgow lan 57118.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 20 oct 1989Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 10 mar 1987
    Entregado el 19 mar 1987
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    268 glasgow rd blantyre.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 19 mar 1987Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 17 nov 1986
    Entregado el 04 dic 1986
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    (1) 270/272 glasgow road, blantyre (2) one up left 4 joanna terrace, blantyre one up right 4 joanna terrace blantyre regd title no lan 20237.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 04 dic 1986Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 may 1984
    Entregado el 10 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises at 48 hanover street stranraer wigtownshire.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1984Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 02 may 1984
    Entregado el 10 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises at 19 the foregate kilmarnock.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1984Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 may 1984
    Entregado el 10 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises at 33 burnbank road, hamilton.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1984Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 may 1984
    Entregado el 10 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Shop premises at 57 portland place hamilton.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1984Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 02 may 1984
    Entregado el 10 may 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Tennents interest in lease of shop premises known as 15 burnbank centre glasgow rd burnbank.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 may 1984Registro de una carga
    • 30 jul 1996Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Bond & floating charge
    Creado el 22 mar 1984
    Entregado el 28 mar 1984
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 28 mar 1984Registro de una carga
    • 20 may 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0