QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Liquidación |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC054465 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | Sí |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
- Comercio al por mayor de vino, cerveza, bebidas espirituosas y otras bebidas alcohólicas (46342) / Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas
¿Dónde se encuentra QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| MARBLEHEAD BRAND DEVELOPMENT LIMITED | 15 mar 1996 | 15 mar 1996 |
| MARBLEHEAD TRADING LIMITED | 13 feb 1987 | 13 feb 1987 |
| RIVINVEND LIMITED | 09 nov 1973 | 09 nov 1973 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Próximas cuentas | |
| Próximo período contable finaliza el | 31 mar 2024 |
| Próximas cuentas vencen el | 31 dic 2024 |
| Últimas cuentas | |
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 mar 2023 |
¿Cuál es el estado de la última declaración de confirmación para QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Vencido | Sí |
|---|---|
| Última declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ene 2025 |
| Próxima declaración de confirmación vence | 26 ene 2025 |
| Última declaración de confirmación | |
| Próxima declaración de confirmación cerrada hasta | 12 ene 2024 |
| Vencido | Sí |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cese del nombramiento de Alex Pollard como director el 17 sept 2024 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland a C/O Bdo Llp 2 Atlantic Square 31 York Street Glasgow G2 8NJ el 11 abr 2024 | 3 páginas | AD01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cancelación total de la carga SC0544650007 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC0544650009 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC0544650008 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2024 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2023 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY Scotland a 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 02 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de Quartermile One, 15 Lauriston Place Edinburgh EH3 9EP Scotland a 9 9 Haymarket Square Edinburgh EH3 8RY el 02 nov 2023 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 mar 2022 | 10 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Warren Michael Scott como director el 26 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de James David Lousada como director el 08 jul 2022 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2022 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2021 | 25 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 12 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2020 | 29 páginas | AA | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 mar 2019 | 24 páginas | AA | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 31 dic 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||
Registro de la carga SC0544650009, creada el 17 dic 2020 | 122 páginas | MR01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr James David Lousada el 19 nov 2020 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Alex Pollard como director el 07 jul 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Lousada como director el 07 oct 2020 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Clifford como secretario el 31 mar 2020 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISONE, Vincenzo | Director | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | Monaco | Italian | 152578310001 | |||||
| BOOTH, Esther | Secretario | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | 238800260001 | |||||||
| BROWN, Sophie | Secretario | Clayton Road Birchwood WA3 6PH Warrington Distribution Point, Melbury Park United Kingdom | 185803300001 | |||||||
| CLIFFORD, Michael | Secretario | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | 245504730001 | |||||||
| DORMAN, Arthur Brian | Secretario | Shawhill House Galston Road Hurlford KA1 5H2 Kilmarnock Strathclyde | British | 752770003 | ||||||
| HENDERSON, Samuel Joseph | Secretario | 105 Ormonde Avenue Netherlee G44 3SN Glasgow Lanarkshire | British | 461450001 | ||||||
| LISTER, Steven Geoffrey | Secretario | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | 215481910001 | |||||||
| LOVE, Robert | Secretario | 48 Grenville Drive Cambuslang G72 8DP Glasgow Lanarkshire | British | 1104220001 | ||||||
| ROBERTSON, Bryan Carey | Secretario | 16 Broomfield Avenue Newton Mearns G77 5HR Glasgow | British | 60602380002 | ||||||
| ROBERTSON, Carey | Secretario | 17-27 Station Road Milngavie G62 8PG Glasgow East Dunbartonshire | British | 146903990001 | ||||||
| STEEL, Robin Gray | Secretario | 48 Viewpark Drive Burnside G73 3QD Glasgow | British | 79076290001 | ||||||
| URE, Julie East | Secretario | 17 North Crescent Road KA22 8NA Ardrossan Ayrshire | British | 81670520003 | ||||||
| AGNEW, Richard Alexander | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | Scotland | British | 461440004 | |||||
| AMNER, Kenneth Ian Mcdonald | Director | 5 Kirkdene Grove Newton Mearns G77 5RW Glasgow Lanarkshire | British | 462540001 | ||||||
| AMNER, Kenneth Ian Mcdonald | Director | 5 Kirkdene Grove Newton Mearns G77 5RW Glasgow Lanarkshire | British | 462540001 | ||||||
| BROWN, Sophie Nina | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | United Kingdom | British | 184987420001 | |||||
| DORMAN, Arthur Brian | Director | Shawhill House Galston Road Hurlford KA1 5H2 Kilmarnock Strathclyde | British | 752770003 | ||||||
| GRAHAM, Heather Claire | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 27043920005 | |||||
| HENDERSON, Samuel Joseph | Director | 105 Ormonde Avenue Netherlee G44 3SN Glasgow Lanarkshire | British | 461450001 | ||||||
| HENDRY, James Williamson | Director | Timaru 37 Maclachlan Avenue FK6 5HF Denny Stirlingshire | British | 72259690001 | ||||||
| HENDRY, James Williamson | Director | Timaru 37 Maclachlan Avenue FK6 5HF Denny Stirlingshire | British | 72259690001 | ||||||
| KEITH, Richard Maxwell | Director | 14 Russell Place EH5 3HH Edinburgh Scotland | United Kingdom | British | 46747460001 | |||||
| LISTER, Steven Geoffrey | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire | England | British | 215478530001 | |||||
| LOUSADA, James David | Director | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | England | British | 152222000001 | |||||
| MORGAN, John White | Director | 21 Claremont Drive Bridge Of Allan FK9 4EE Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 35561700001 | |||||
| POLLARD, Alex | Director | 2 Atlantic Square 31 York Street G2 8NJ Glasgow C/O Bdo Llp | England | British | 275119170001 | |||||
| SALMON, Mike | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 180282760001 | |||||
| SCOTT, Warren Michael | Director | 15 Lauriston Place EH3 9EP Edinburgh Quartermile One, Scotland | England | British | 151869960001 | |||||
| STEEL, Robin Gray | Director | 48 Viewpark Drive Burnside G73 3QD Glasgow | British | 79076290001 | ||||||
| STEWARD, David | Director | 17-27 Station Road Milngavie G62 8PG Glasgow East Dunbartonshire | United Kingdom | British | 199652170001 | |||||
| STEWARD, David | Director | 42 Church Street Coggeshall CM7 5JY Braintree Essex | British | 47647120003 | ||||||
| WYKES, Emma Claire | Director | 1 Aurora Avenue Queens Quay G81 1BF Clydebank, Glasgow Suite 1/4 Titan Enterprise Dunbartonshire Scotland | United Kingdom | British | 179739820001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quintessential Spirits Uk Limited | 06 abr 2016 | Clayton Road Birchwood WA3 6PH Warrington Distribution Point, Melbury Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 17 dic 2020 Entregado el 22 dic 2020 | Satisfecho en su totalidad | ||
Breve descripción Property located at distribution point, melbury court, risley, warrington registered at the land registry with title number CH561943. UK trademark with application number UK00002428193 and registration number UK00002428193. For further details of land and intellectual property charged, please refer to the instrument. La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 03 dic 2018 Entregado el 05 dic 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 01 ago 2018 Entregado el 01 ago 2018 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| A registered charge | Creado el 10 jun 2015 Entregado el 12 jun 2015 | Satisfecho en su totalidad | ||
Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía fija: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 27 abr 2012 Entregado el 05 may 2012 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 10 abr 1989 Entregado el 18 abr 1989 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción 17 cloberfield milngavie dmb 16893. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of agreement | Creado el 19 jul 1988 Entregado el 03 ago 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción All sums invested with bank or bid deposit acc. No. 91003070 and interest accrued thereon. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 26 sept 1978 Entregado el 06 oct 1978 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
¿Tiene QUINTESSENTIAL BRANDS UK LIMITED algún caso de insolvencia?
| Número de expediente | Fechas | Tipo | Profesionales | Otro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidación voluntaria de socios |
|
|
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0