JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC054871 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
- Actividades de oficinas centrales (70100) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Registered Office Kintore AB51 0YQ Inverurie Aberdeenshire Scotland |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles son las últimas cuentas de JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2021 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 1 páginas | DS01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2023 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2021 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 1 Exchange Crescent Conference Square Edinburgh EH3 8UL a Registered Office Kintore Inverurie Aberdeenshire AB51 0YQ el 08 mar 2022 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2022 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2020 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||||||
Estado de capital el 12 may 2021
| 5 páginas | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2021 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2019 | 2 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2020 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Notification de Luc Jules Tack en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 01 abr 2019 | 2 páginas | PSC01 | ||||||||||||||
Cessation de Malcolm Stephen Mclellan en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 mar 2019 | 1 páginas | PSC07 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2018 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Cese del nombramiento de Malcolm Stephen Mclellan como director el 31 mar 2019 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2019 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2017 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2018 sin actualizaciones | 3 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2016 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 03 ene 2017 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2015 | 7 páginas | AA | ||||||||||||||
¿Quiénes son los directivos de JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCGUINESS, Iain | Secretario | Kintore AB51 0YQ Inverurie Registered Office Aberdeenshire Scotland | British | 96803030001 | ||||||
| HASPESLAGH, Stefaan Arthur | Director | Kintore AB51 0YQ Inverurie Registered Office Aberdeenshire Scotland | Belgium | Belgian | 197700340001 | |||||
| CULLEY, Darren | Secretario | St. Christoph Cottage CA4 8RJ Carlisle Cumbria | British | 94151280001 | ||||||
| GRAHAM, Sarah Evelyn | Secretario | Nethercroft Brisco CA4 0QN Carlisle Cumbria | British | 80554330001 | ||||||
| INNES, Eric David | Secretario | Upper Woodside Beechgrove DG10 9RU Moffat | British | 98205000001 | ||||||
| MCLELLAN, Malcolm Stephen | Secretario | Highfield Lodge Crowle Green, Crowle WR7 4AA Worcester Worcestershire | British | 94105400001 | ||||||
| WALLACE, Alexander Campbell | Secretario | Beechwood Bungalow Haywood Road DG10 9BU Moffat Dumfriesshire | British | 24916100001 | ||||||
| COOPER, Allan Cunningham | Director | The Old Vicarage Church Street, Stanwix CA3 9DJ Carlisle Cumbria | British | 24915880002 | ||||||
| DALSTRA, Alike Jan | Director | Blitergers 8 8401 Ma Gorredijk Netherlands | Dutch | 80554430001 | ||||||
| DAVIDSON, John Brian | Director | Alisons Bank Gretna CA6 5EP Carlisle Cumbria | British | 255280001 | ||||||
| DAVIDSON, June Sandison | Director | Alisons Bank Gretna CA6 5EP Carlisle Cumbria | British | 255290001 | ||||||
| DE MEUE, Bruno Peter Michel Oscar | Director | 107 Avenue Prince Albert 1410 Waterloo Brussels 1410 Belgium | Belgium | Belgian | 121036060001 | |||||
| ENTWISTLE, Raymond Marvin | Director | The Glebe Lauder TD2 6RW Berwickshire | Scotland | British | 892520001 | |||||
| GOMBERT, Willem Carel | Director | Amersfoordtlaan 87 HOLLAND 1171 Dn Badhoeveforp | Dutch | 63410630001 | ||||||
| GRAHAM, Sarah Evelyn | Director | Nethercroft Brisco CA4 0QN Carlisle Cumbria | England | British | 80554330001 | |||||
| INNES, Eric David | Director | Upper Woodside Beechgrove DG10 9RU Moffat | United Kingdom | British | 98205000001 | |||||
| INNES, Jannette Louise | Director | Glen Ericht DG10 9 Moffat Dumfriesshire | British | 255300001 | ||||||
| LUDLEY, Graeme Dennis | Director | April Cottage 9 Winser Road Rolvenden Layne TN17 4NL Cranbrook Kent | United Kingdom | British | 66754530003 | |||||
| MCLELLAN, Malcolm Stephen | Director | Collingford Gret Corby CA4 8NH Carlisle Cumbria | United Kingdom | British | 94105400003 | |||||
| MERTENS, Richard | Director | Maasstraat 107a Scherpenhevvel 3272 Belgium | Belgian | 66756110001 | ||||||
| TELGEN, Johan Henrik, Drs. | Director | Woudsingel 63 Heerenveen 8443 Dl The Netherlands | Netherlands | Dutch | 123271380001 | |||||
| VASSEUR, Albert | Director | 91 Avenue De L Hippodrome 49300 Cholet France | France | French | 95626950001 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado |
|---|---|---|---|
| Mr Luc Jules Tack | 01 abr 2019 | Kintore AB51 0YQ Inverurie Registered Office Aberdeenshire Scotland | No |
Nacionalidad: Belgian País de residencia: Belgium | |||
Naturaleza del control
| |||
| Mr Malcolm Stephen Mclellan | 06 abr 2016 | Conference Square EH3 8UL Edinburgh 1 Exchange Crescent | Sí |
Nacionalidad: British País de residencia: United Kingdom | |||
Naturaleza del control
| |||
¿Tiene JOHN DAVIDSON (HOLDINGS) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Bond & floating charge | Creado el 17 sept 1993 Entregado el 30 sept 1993 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 16 sept 1992 Entregado el 22 sept 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Legal mortgage | Creado el 24 jul 1980 Entregado el 01 ago 1980 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Leasehold factory premises situated at spencer bridge road, northampton. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of offset | Creado el 02 ago 1979 Entregado el 10 ago 1979 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All moneys due, or to become due from the company and others to the chargee | |
Breve descripción All accounts of the company with, and its liabilities to, lloyds bank LTD. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0