BRITSHIP TWO LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaBRITSHIP TWO LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC055006
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de BRITSHIP TWO LIMITED?

    • (7499) /

    ¿Dónde se encuentra BRITSHIP TWO LIMITED?

    Dirección de la sede social
    95 Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BLUE STAR LINE MARINE LIMITED18 sept 199618 sept 1996
    STAR OFFSHORE SERVICES MARINE LIMITED07 feb 197407 feb 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2008

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para BRITSHIP TWO LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Gaceta final disuelta tras la liquidación

    1 páginasGAZ2

    Acta de la reunión final de la liquidación voluntaria

    3 páginas4.26(Scot)

    Cambio de datos del secretario John Kilby el 22 dic 2009

    1 páginasCH03

    Cambio de datos del director John Kilby el 22 dic 2009

    2 páginasCH01

    Domicilio social registrado cambiado de Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd Aberdeen AB10 1DQ el 24 dic 2009

    1 páginasAD01

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    liquidation

    Acuerdo especial para la liquidación el 30 nov 2009

    LRESSP

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    legacy

    2 páginas419a(Scot)

    Certificado de cambio de nombre

    Company name changed blue star line marine LIMITED\certificate issued on 21/07/09
    2 páginasCERTNM

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2008

    4 páginasAA

    legacy

    3 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    3 páginas363a

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2007

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    7 páginas363s

    Cuentas preparadas hasta el 31 dic 2006

    4 páginasAA

    legacy

    2 páginas288a

    legacy

    1 páginas288b

    ¿Quiénes son los directivos de BRITSHIP TWO LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Secretario
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    British76247880001
    BURRIDGE, James George Thomas
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    Director
    Julien Road
    W5 4XA London
    5
    EnglandUnited Kingdom59355820001
    KILBY, John, Mr.
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    Director
    Bothwell Street
    G2 7JZ Glasgow
    95
    EnglandBritish76247880001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Secretario
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    British7865940001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Secretario
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Secretario
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    ZIMMER, Kaarina Ann
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    Secretario
    Riowstraat 43
    2585 Gs
    The Hague
    Netherlands
    British104894830001
    ALLEN, Martyn Clive
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    Director
    17 Inglis Road
    CO3 3HU Colchester
    Essex
    United KingdomBritish117739980001
    BRYCE, John Alexander
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    Craig Dorney
    Kinellar
    AB21 0SG Aberdeen
    Aberdeenshire
    ScotlandBritish69880420001
    CHEESEMAN, Guy Robert
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    Director
    60 St Johns Park
    Blackheath
    SE3 7JP London
    United KingdomBritish7865940001
    COLLINS, John Alexander, Sir
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    Director
    Flat 4
    63 Millbank Terraces
    SW1P 4RW London
    British53032980001
    COOPER, Robert Hamilton
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    Director
    Great Yews
    Lubbock Road
    BR7 5LA Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish11632250002
    CORK, Barry Philip Arthur
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    Director
    Wainstones
    1 Riversides Blackhall
    AB31 3PS Banchory
    Grampian
    British555660003
    CORNTHWAITE, Christopher John
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    Director
    24 The Drive
    TN13 3AE Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritish34530990002
    DAWS, Christopher
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    Director
    14 West Glebe
    AB3 2HZ Stonehaven
    Kincardineshire
    British555670001
    DEAR, Philip
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    Director
    61 Anderson Drive
    AB15 4UA Aberdeen
    British78057600001
    HABGOOD, David John Cecil
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    Director
    Richmond Cottage
    21 Ashley Park Avenue
    KT12 1ER Walton On Thames
    Surrey
    EnglandBritish29831660001
    MCGEOCH, Christopher
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    Director
    Longfield House
    Longfield Hill
    DA3 7AS Kent
    British40359510005
    MONEY, Timothy John
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    Director
    Riverdale
    148 Peperharow Road
    GU7 2PW Godalming
    Surrey
    EnglandBritish71374890003
    O'BRIEN, Bernadette Mary
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    Director
    10 Stormont Road
    Highgate
    N6 4NL London
    EnglandIrish95129740001
    PUSEY, Nigel Simon
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    Director
    Roslyns
    Water Lane
    CB9 7AL Helions Bumpstead
    Suffolk
    British83149350005
    ROBBIE, David Andrew
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    Director
    4 St Johns House 30 Smith Square
    SW1P 3HF London
    United KingdomBritish108246820001
    SPENCER-PAYNE, Christopher David
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    Director
    1 Beechgrove Gardens
    AB2 4HG Aberdeen
    Aberdeenshire
    British66395410001
    WALKER, Peter Arthur
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    Director
    64 Connaught Avenue
    Chingford
    E4 7AA London
    United KingdomBritish708770001
    WOODS, Robert Barclay
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    Director
    Old Rectory
    Frilsham
    RG18 9XH Newbury
    EnglandBritish154397820001

    ¿Tiene BRITSHIP TWO LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    General assignment
    Creado el 08 dic 1997
    Entregado el 29 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All rights title and interest in the assigned property mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personas con derecho
    • Credit Agricole Indosuez
    Transacciones
    • 29 dic 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 08 dic 1997
    Entregado el 29 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All rights, title and interest to an in th mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personas con derecho
    • Credit Agricole Indosuez
    Transacciones
    • 29 dic 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Ship mortgage
    Creado el 08 dic 1997
    Entregado el 29 dic 1997
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the mv "brisbane star" to be renamed "singapore star".
    Personas con derecho
    • Credit Agricole Indosuez
    Transacciones
    • 29 dic 1997Registro de un cargo (410)
    • 07 sept 2009Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    General assignment
    Creado el 10 ene 1996
    Entregado el 31 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Earnings and requisition compensation of the M.V. "sydney star".
    Personas con derecho
    • Banque Indosuez
    Transacciones
    • 31 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 19 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 10 ene 1996
    Entregado el 25 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.V. "sydney star"....see ch microfiche.
    Personas con derecho
    • Banque Indosuez
    Transacciones
    • 25 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 19 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority bahamas stat.mortgage
    Creado el 10 ene 1996
    Entregado el 25 ene 1996
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.V. "sydney star",nassau 343036 and boats,guns,ammunition,small arms and appertunances.
    Personas con derecho
    • Banque Indosuez
    Transacciones
    • 25 ene 1996Registro de un cargo (410)
    • 19 feb 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Assignment agreement
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descripción
    The earnings....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 09 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenants
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due by the company and another
    Breve descripción
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 09 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Second deed of covenants
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468, with the earnings and the requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Second priority bahamian ship mortgage
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenants
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenants
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451, with the earnings and requisition compensation....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 14 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Second assignment of earnings
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Assignment of earnings
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Assigned monies"....... See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Queensland star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 358737.
    Personas con derecho
    • National Westminster Bank PLC
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Assignment of earnings
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Assigned monies"........ See ch microfiche for full details.
    Personas con derecho
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 14 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "America star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 341451.
    Personas con derecho
    • Lombard Leasing Metropolitan Limited
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 14 mar 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority bahamian ship mortgage
    Creado el 20 nov 1995
    Entregado el 07 dic 1995
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    "Brisbane star", registered at the port of nassau, bahamas, off no 723468.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 dic 1995Registro de un cargo (410)
    • 09 sept 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    First priority statutory mortgage
    Creado el 30 abr 1992
    Entregado el 07 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Personas con derecho
    • The Secretary of State for Trade and Industry
    Transacciones
    • 07 may 1992Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Second priority statutory mortgage
    Creado el 30 abr 1992
    Entregado el 07 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus" official number 702738.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 may 1992Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 29 abr 1992
    Entregado el 07 may 1992
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £7,400,000
    Breve descripción
    64/64TH shares in the M.V. "star pegasus".
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 may 1992Registro de un cargo (410)
    • 20 may 1997Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Delivery order
    Creado el 22 mar 1991
    Entregado el 28 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    All materials, engines and machinery of yard no. 603.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 1991Registro de una carga
    • 14 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    3RD priority mortgage
    Creado el 22 mar 1991
    Entregado el 28 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in "star altair" official no. 701173.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 1991Registro de una carga
    • 14 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 22 mar 1991
    Entregado el 28 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.V. "star altair" official no 701173.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 1991Registro de una carga
    • 14 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Deed of covenant
    Creado el 22 mar 1991
    Entregado el 28 mar 1991
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    64/64TH shares in M.V. "star capella" official no 701153.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 28 mar 1991Registro de una carga
    • 14 abr 1998Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)

    ¿Tiene BRITSHIP TWO LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    27 jul 2010Fecha de disolución
    30 nov 2009Inicio de la liquidación
    Liquidación voluntaria de socios
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    Notasscottish-insolvency-info

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0