GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC055629 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
- Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas
¿Dónde se encuentra GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
| Dirección de la sede social | Regency House Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife United Kingdom |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BETT HOMES (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED | 27 abr 2005 | 27 abr 2005 |
| BETT HOMES (SCOTLAND) LIMITED | 29 ene 2004 | 29 ene 2004 |
| BETT HOMES LIMITED | 11 nov 1992 | 11 nov 1992 |
| BETT ESTATES LIMITED | 09 may 1986 | 09 may 1986 |
| SPALDING (INSURANCE BROKERS) LIMITED | 09 may 1974 | 09 may 1974 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2010 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida | 1 páginas | SOAS(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Cambio de datos del director Mr Neil Fitzsimmons el 01 nov 2011 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Nombramiento de Elizabeth Catchpole como director el 20 jun 2012 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 mar 2012 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cese del nombramiento de James Mclellan Kirkpatrick como director el 11 jul 2011 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Estado de capital el 09 sept 2011
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 1 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Déclaration annuelle établie au 13 mar 2011 avec liste complète des actionnaires | 6 páginas | AR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 mar 2011 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Gaffney como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 12 mar 2010 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 02 feb 2010 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSEY, Joanne Elizabeth | Secretario | Ridgeway Road RH1 6PQ Redhill 35 Surrey United Kingdom | 147809240001 | |||||||
| CATCHPOLE, Elizabeth Margaret | Director | High Street TN16 1RG Westerham 30 Kent United Kingdom | England | British | 154997530001 | |||||
| FITZSIMMONS, Neil | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | United Kingdom | British | 69006050003 | |||||
| LEWIS, Colin Edward | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Wales | Welsh | 59395180001 | |||||
| GANDHI, Devendra | Secretario | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | British | 75350600002 | ||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Secretario | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | British | 11498320001 | ||||||
| MASON, Eddie Roy | Secretario | 14 John Huband Drive Birkhill DD2 5RY Dundee | British | 606150007 | ||||||
| ANDERSON, Alexander | Director | 34 Ledcameroch Gardens FK15 0GZ Dunblane Perthshire | Scotland | British | 114144470001 | |||||
| BARLOW, David St John | Director | Inglewood Slaley NE47 0AA Hexham | British | 40287360005 | ||||||
| BETT, Iain Charles Rattray | Director | Kingennie House Kingennie DD5 3RD Dundee | Scotland | British | 95179330001 | |||||
| CALDER, John Murray | Director | 69 Camphill Road Broughty Ferry DD5 2LY Dundee | British | 318650001 | ||||||
| CHURCH, Charles | Director | 6 Lynebank Grove Newton Mearns G77 5GB Glasgow | United Kingdom | British | 79873860001 | |||||
| CLARK, James | Director | 48 Garvine Road Coylton KA6 6NZ Ayr | British | 37854600001 | ||||||
| CLELLAND, Lorraine Agnes | Director | 9 Alexander Gordon Drive Monifieth DD5 4HD Dundee Angus | British | 102629370001 | ||||||
| DAVIDSON, Kareen | Director | 85 Loughborough Road KY1 3DD Kirkcaldy Fife | British | 44746080001 | ||||||
| DIPRE, John Vivian | Director | The Warren KT21 2SE Ashtead Hollybank Surrey | United Kingdom | British | 9018280015 | |||||
| DIPRE, Remo | Director | The Pines Farm Lane KT21 1LU Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 35117250001 | |||||
| DOUGLAS, Keith Richard | Director | Lilac Cottage Castlehill Main Street FK8 3DN Kippen Stirlingshire | United Kingdom | British | 91229410003 | |||||
| GAFFNEY, David | Director | Crossgates Road, Halbeath KY11 7EG Dunfermline, Fife Regency House United Kingdom | Scotland | British | 84605410002 | |||||
| GANDHI, Devendra | Director | The Knoll KT22 8XH Leatherhead 5 Surrey | England | British | 75350600002 | |||||
| GIBSON, Alexander | Director | 117 Strathern Road Broughty Ferry DD5 1JR Dundee Angus | British | 318180001 | ||||||
| GRANT, Alexander James | Director | 52 Wester Inshes Court IV2 5HS Inverness Inverness Shire | British | 107801990001 | ||||||
| HALDANE, Kenneth Douglas | Director | 64 Victoria Road PA2 9PT Paisley Renfrewshire | United Kingdom | British | 94477860001 | |||||
| HANNA, Ronald George | Director | 34 Primrose Bank Road EH5 3JF Edinburgh Midlothian | United Kingdom | British | 8506940001 | |||||
| HAWKSBY, Terry | Director | Newbigging Farmhouse Tibbermore PH1 1QH Perth Perthshire | United Kingdom | British | 93733930001 | |||||
| HITCHEN, David James | Director | 4 Carrongrove Avenue Carron FK2 8NG Falkirk | British | 60512890001 | ||||||
| INNES, John Gordon | Director | 14 Limeview Road Glenburn PA2 8ND Paisley Renfrewshire | British | 72090910001 | ||||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| KIRKPATRICK, James Mclellan | Director | 35 Cardowan Road Stepps G33 6HJ Glasgow Lanarkshire | United Kingdom | British | 102797820001 | |||||
| LAVELLE, Dominic Joseph | Director | Ashley Road KT18 5AZ Epsom Ashley House Surrey United Kingdom | United Kingdom | British | 137285750001 | |||||
| LEITCH, Gerald | Director | 24 Mary Fisher Crescent G82 1BF Dumbarton Dunbartonshire | British | 110231420001 | ||||||
| LYON, Steven | Director | 44 Maule Street DD7 6AB Carnoustie Angus | Uk | British | 97482510001 | |||||
| MCBRIDE, Alexander Clunie | Director | 6 Cupar Road KY8 6DQ Lundin Links The Stables Fife United Kingdom | Scotland | British | 147233120001 | |||||
| MCGOWAN, James Joseph | Director | 66 Mulben Crescent Crookston G53 7EH Glasgow | British | 77647430001 | ||||||
| MITCHELL, Ronald | Director | 7 Albert Road Broughty Ferry DD5 1AY Dundee Angus | British | 318190001 |
¿Tiene GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 14 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 30 dic 2008 Entregado el 08 ene 2009 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 may 2003 Entregado el 03 jun 2003 | Pendiente | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of offset | Creado el 10 abr 1984 Entregado el 24 abr 1984 | Pendiente | Cantidad garantizada All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and/or others | |
Breve descripción The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of spalding (insurance brokers) LTD. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0