GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaGLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC055629
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    • Compañía no comercial (74990) / Actividades profesionales, científicas y técnicas

    ¿Dónde se encuentra GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Regency House
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    United Kingdom
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BETT HOMES (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED27 abr 200527 abr 2005
    BETT HOMES (SCOTLAND) LIMITED29 ene 200429 ene 2004
    BETT HOMES LIMITED11 nov 199211 nov 1992
    BETT ESTATES LIMITED09 may 198609 may 1986
    SPALDING (INSURANCE BROKERS) LIMITED09 may 197409 may 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta31 dic 2010

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    La acción de exclusión voluntaria ha sido suspendida

    1 páginasSOAS(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Cambio de datos del director Mr Neil Fitzsimmons el 01 nov 2011

    2 páginasCH01

    Nombramiento de Elizabeth Catchpole como director el 20 jun 2012

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01
    Presentaciones asociadas
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital14 mar 2012

    Estado de capital el 14 mar 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Cese del nombramiento de James Mclellan Kirkpatrick como director el 11 jul 2011

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2010

    6 páginasAA

    Estado de capital el 09 sept 2011

    • Capital: GBP 1
    4 páginasSH19

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Resoluciones

    Resolutions
    1 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    Déclaration annuelle établie au 13 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 páginasAR01

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 páginasAR01

    Cese del nombramiento de David Gaffney como director

    1 páginasTM01

    Cuentas para una empresa inactiva preparadas hasta el 31 dic 2009

    6 páginasAA

    Nombramiento de Mr Colin Edward Lewis como director

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Neil Fitzsimmons como director

    2 páginasAP01

    Déclaration annuelle établie au 12 mar 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 páginasAR01

    Domicilio social registrado cambiado de 50 Lothian Road Festival Square Edinburgh EH3 9WJ el 02 feb 2010

    1 páginasAD01

    Cambio de datos del director David Gaffney el 29 ene 2010

    2 páginasCH01

    Cese del nombramiento de Dominic Lavelle como director

    1 páginasTM01

    ¿Quiénes son los directivos de GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    MASSEY, Joanne Elizabeth
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ridgeway Road
    RH1 6PQ Redhill
    35
    Surrey
    United Kingdom
    147809240001
    CATCHPOLE, Elizabeth Margaret
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    Director
    High Street
    TN16 1RG Westerham
    30
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish154997530001
    FITZSIMMONS, Neil
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    United KingdomBritish69006050003
    LEWIS, Colin Edward
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    WalesWelsh59395180001
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Secretario
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    British75350600002
    JOHNSON, Robin Simon
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Secretario
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    British11498320001
    MASON, Eddie Roy
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    Secretario
    14 John Huband Drive
    Birkhill
    DD2 5RY Dundee
    British606150007
    ANDERSON, Alexander
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    Director
    34 Ledcameroch Gardens
    FK15 0GZ Dunblane
    Perthshire
    ScotlandBritish114144470001
    BARLOW, David St John
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    Director
    Inglewood
    Slaley
    NE47 0AA Hexham
    British40287360005
    BETT, Iain Charles Rattray
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    Director
    Kingennie House
    Kingennie
    DD5 3RD Dundee
    ScotlandBritish95179330001
    CALDER, John Murray
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    Director
    69 Camphill Road
    Broughty Ferry
    DD5 2LY Dundee
    British318650001
    CHURCH, Charles
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    Director
    6 Lynebank Grove
    Newton Mearns
    G77 5GB Glasgow
    United KingdomBritish79873860001
    CLARK, James
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    Director
    48 Garvine Road
    Coylton
    KA6 6NZ Ayr
    British37854600001
    CLELLAND, Lorraine Agnes
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    Director
    9 Alexander Gordon Drive
    Monifieth
    DD5 4HD Dundee
    Angus
    British102629370001
    DAVIDSON, Kareen
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    Director
    85 Loughborough Road
    KY1 3DD Kirkcaldy
    Fife
    British44746080001
    DIPRE, John Vivian
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    Director
    The Warren
    KT21 2SE Ashtead
    Hollybank
    Surrey
    United KingdomBritish9018280015
    DIPRE, Remo
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    Director
    The Pines
    Farm Lane
    KT21 1LU Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish35117250001
    DOUGLAS, Keith Richard
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    Director
    Lilac Cottage Castlehill
    Main Street
    FK8 3DN Kippen
    Stirlingshire
    United KingdomBritish91229410003
    GAFFNEY, David
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    Director
    Crossgates Road, Halbeath
    KY11 7EG Dunfermline, Fife
    Regency House
    United Kingdom
    ScotlandBritish84605410002
    GANDHI, Devendra
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    Director
    The Knoll
    KT22 8XH Leatherhead
    5
    Surrey
    EnglandBritish75350600002
    GIBSON, Alexander
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    Director
    117 Strathern Road
    Broughty Ferry
    DD5 1JR Dundee
    Angus
    British318180001
    GRANT, Alexander James
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    Director
    52 Wester Inshes Court
    IV2 5HS Inverness
    Inverness Shire
    British107801990001
    HALDANE, Kenneth Douglas
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    Director
    64 Victoria Road
    PA2 9PT Paisley
    Renfrewshire
    United KingdomBritish94477860001
    HANNA, Ronald George
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    Director
    34 Primrose Bank Road
    EH5 3JF Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish8506940001
    HAWKSBY, Terry
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    Director
    Newbigging Farmhouse
    Tibbermore
    PH1 1QH Perth
    Perthshire
    United KingdomBritish93733930001
    HITCHEN, David James
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    Director
    4 Carrongrove Avenue
    Carron
    FK2 8NG Falkirk
    British60512890001
    INNES, John Gordon
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    Director
    14 Limeview Road
    Glenburn
    PA2 8ND Paisley
    Renfrewshire
    British72090910001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102797820001
    KIRKPATRICK, James Mclellan
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    35 Cardowan Road
    Stepps
    G33 6HJ Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish102797820001
    LAVELLE, Dominic Joseph
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    Director
    Ashley Road
    KT18 5AZ Epsom
    Ashley House
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritish137285750001
    LEITCH, Gerald
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    Director
    24 Mary Fisher Crescent
    G82 1BF Dumbarton
    Dunbartonshire
    British110231420001
    LYON, Steven
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    Director
    44 Maule Street
    DD7 6AB Carnoustie
    Angus
    UkBritish97482510001
    MCBRIDE, Alexander Clunie
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    Director
    6 Cupar Road
    KY8 6DQ Lundin Links
    The Stables
    Fife
    United Kingdom
    ScotlandBritish147233120001
    MCGOWAN, James Joseph
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    Director
    66 Mulben Crescent
    Crookston
    G53 7EH Glasgow
    British77647430001
    MITCHELL, Ronald
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    Director
    7 Albert Road
    Broughty Ferry
    DD5 1AY Dundee
    Angus
    British318190001

    ¿Tiene GLADEDALE (CENTRAL SCOTLAND) LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Debenture
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 14 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 14 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 30 dic 2008
    Entregado el 08 ene 2009
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 ene 2009Registro de un cargo (410)
    Floating charge
    Creado el 21 may 2003
    Entregado el 03 jun 2003
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 03 jun 2003Registro de un cargo (410)
    Letter of offset
    Creado el 10 abr 1984
    Entregado el 24 abr 1984
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All moneys due, or to become due by bett brothers PLC and/or others
    Breve descripción
    The balances at credit of any accounts held by the bank of scotland in name of spalding (insurance brokers) LTD.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 24 abr 1984Registro de una carga

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0