RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Insolvencia
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaRICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC055754
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvencia
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    • (6024) /

    ¿Dónde se encuentra RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Dirección de la sede social
    Pricewaterhousecoopers
    PO BOX 90 Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    RICHARD LAWSON MOTOR COMPANY LIMITED08 jun 197408 jun 1974

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta04 ene 2003

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    1 páginasOC-DV

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Orden judicial

    Order of court - dissolution void
    1 páginasOC-DV

    Boletín oficial final disuelto por cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ2

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación obligatoria

    1 páginasGAZ1

    Aviso de finalización automática de la administración

    7 páginas2.21B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    8 páginas2.20B(Scot)

    Aviso de extensión del período de administración

    2 páginas2.22B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    8 páginas2.20B(Scot)

    Aviso de extensión del período de administración

    2 páginas2.22B(Scot)

    Informe de progreso del administrador

    10 páginas2.20B(Scot)

    legacy

    1 páginas287

    legacy

    40 páginas2.18B(Scot)

    Declaración de asuntos

    37 páginas2.15B(Scot)

    legacy

    1 páginas288b

    Declaración de la propuesta del administrador

    40 páginas2.16B(Scot)

    Nombramiento de un administrador

    3 páginas2.11B(Scot)

    legacy

    1 páginas288b

    legacy

    8 páginas363s

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 04 ene 2003

    20 páginasAA

    Cuentas consolidadas preparadas hasta el 30 dic 2001

    21 páginasAA

    legacy

    9 páginas363s

    ¿Quiénes son los directivos de RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    FYFE, Alexander
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    Secretario
    27 Seaforth Crescent
    Broughty Ferry
    DD5 1QD Dundee
    Angus
    British72003050001
    GISVOLD, Rune
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Director
    Iver Holters Vei 36
    N1710 Kolbotn
    Norway
    Norwegian85499620001
    HOLM, Aage Sturtzel
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Director
    Bekkeveien 1b
    1336 Sandvika
    Norway
    Norwegian66364500001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Secretario
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    British543350001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Secretario
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Secretario
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002
    BRUERS, Georges
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Director
    Guyotdreef 26
    2930 Brasschaat
    Belgium
    Belgium33794790001
    COWIE, John Michael
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    Director
    Glasgow Road
    PH2 0LU Perth
    123
    Perthshire
    ScotlandBritish543350001
    EUREN, Bengt Ingvar Lennart
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Director
    Vindragarvagen 12
    Stockholm
    11750
    Sweden
    Swedish57830000001
    HAGEL, Lennart Nils Fredrik
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    Director
    Trossvagen 2
    S 181 66 Lidingo
    Sweden
    SwedenSwedish36224910001
    HAYNES, Peter Davis
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    Director
    19 Buckland
    Shoeburyness
    SS3 8BD Southend On Sea
    Essex
    British3387810001
    LAWSON, Richard Herring
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    Director
    Over Pilmore
    Invergowrie
    DD2 5EL Dundee
    ScotlandBritish146501290001
    LAWSON, Susan Janet
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    Director
    Winsterley 23 Reres Road
    Broughty Ferry
    DD5 2QA Dundee
    Angus
    British166750001
    MACKAY, Ian
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    Director
    Tall Chambers
    45 Saint Wilfrids Road
    DN4 6AB Doncaster
    South Yorks
    British85693920001
    NICOLL, Douglas John
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    Director
    5 Mayville Gardens
    Trinity
    EH5 3DB Edinburgh
    Midlothian
    British166730001
    OLSSON, Christer Bengt
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Director
    Grev Turegatan 75
    S-114 38
    Stockholm
    Sweden
    Swedish21234530001
    REEVES, Martin Charles
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    Director
    Crestover Christmas Hill
    South Wonston
    SO21 3ES Winchester
    Hampshire
    British22890000001
    SKAUG, Odd Ingar
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Director
    Mariesvei 18b
    N-1363 Hevik
    Norway
    Norwegian64835160001
    STYER, Richard
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    Director
    Minimus Cottage
    BA7 7DJ Castle Cary
    Somerset
    British1133930001
    VAN MOL, Walter Petrus Maria
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Director
    Rood Borstlaan 17
    FOREIGN 2660 Antwerp
    Belgium
    Dutch5666990001
    WILSON, Kenneth
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    24 Etive Drive
    Giffnock
    G46 6PN Glasgow
    Lanarkshire
    British53458580002

    ¿Tiene RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Floating charge
    Creado el 31 ago 1999
    Entregado el 17 sept 1999
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Legal charge over property known as lima, block a, bourne business park, weybridge; fixed charges over assets; floating charge over same.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 17 sept 1999Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 31 ene 1997
    Entregado el 07 feb 1997
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Area of ground on the south east side of cortachy road,kirriemuir.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 07 feb 1997Registro de un cargo (410)
    Legal charge
    Creado el 08 feb 1995
    Entregado el 20 feb 1995
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Land on the south side of rossfield road, ellesmere port, cheshire.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 20 feb 1995Registro de un cargo (410)
    Bond & floating charge
    Creado el 13 jun 1994
    Entregado el 21 jun 1994
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 21 jun 1994Registro de un cargo (410)
    Standard security
    Creado el 02 feb 1989
    Entregado el 08 feb 1989
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Cortachir road kirriemuir, angus.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 08 feb 1989Registro de una carga
    • 12 abr 1995Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Legal charge
    Creado el 25 nov 1988
    Entregado el 05 dic 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Parcel of land and buildings thereon situate the south side of rossfield road ch 131908.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 05 dic 1988Registro de una carga
    • 22 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Aircraft mortgage
    Creado el 21 mar 1988
    Entregado el 29 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    £88,200 and all sums due or to become due
    Breve descripción
    One 1976 cessing 421C golden eagle aircraft reg. Mark g-rlmc serial no-421C 0118.
    Personas con derecho
    • Lombard North Central PLC
    Transacciones
    • 29 mar 1988Registro de una carga
    • 22 jun 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    Standard security
    Creado el 01 feb 1988
    Entregado el 08 feb 1988
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Piece of ground lying on or towards the southeast side of cortachy road in the parish of kirriemuir and county of angus (formerly forfar) sometime forming part of the lands and estate of hillhead in said parish and county and (second) all and whole that area or piece of ground in the said parish and county extending to thirty four decimal parts of a hectare or thereby.
    Personas con derecho
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transacciones
    • 08 feb 1988Registro de una carga
    Standard security
    Creado el 25 ene 1983
    Entregado el 10 feb 1983
    Pendiente
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Garage and warehouse premises at 51 dundonald street, dundee, angus.
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 10 feb 1983Registro de una carga
    Bond & floating charge
    Creado el 03 oct 1975
    Entregado el 13 oct 1975
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transacciones
    • 13 oct 1975Registro de una carga
    • 04 ago 1994Declaración de satisfacción de una carga en su totalidad o en parte (419a)
    • Tiene modificaciones en la orden:

    ¿Tiene RICHARD LAWSON AUTO LOGISTICS LIMITED algún caso de insolvencia?

    Número de expedienteFechasTipoProfesionalesOtro
    1
    FechaTipo
    14 sept 2004Inicio de la administración
    13 jun 2006Fin de la administración
    En administración
    NombreRolDirecciónNombrado elCesado el
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Profesional
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    John Bruce Cartwright
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Profesional
    Po Box 90
    Erskine House
    EH2 4NH 68-73 Queen Street
    Edinburgh
    Robert Hunt
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Profesional
    Cornwall Court
    19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Profesional
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Graham Douglas Frost
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh
    Profesional
    Erskine House
    68 Queen Street
    EH2 4NF Edinburgh

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0