PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC057099 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
- Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo
¿Dónde se encuentra PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O Wyman Gordon Houston Road EH54 5BZ Houston Industrial Estate Livingtson |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| BARONSHIRE ENGINEERING LIMITED | 31 ene 1975 | 31 ene 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 03 abr 2011 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Resoluciones Resolutions | 2 páginas | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 1 páginas | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 páginas | CAP-SS | ||||||||||
Estado de capital el 18 dic 2013
| 4 páginas | SH19 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 1 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 2 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Russell Scott Pattee como director el 26 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Orla Begley como director el 26 sept 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Paul Edelstyn como director el 26 sept 2013 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Anthony Cooke como director el 26 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Shawn Rene Hagel como director el 26 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Steven Craig Blackmore como director el 26 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Roger Paul Becker como director el 26 sept 2013 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Exercice comptable en cours raccourci du 30 sept 2012 au 01 abr 2012 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2013 | 17 páginas | AR01 | ||||||||||
Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2012 au 30 sept 2012 | 3 páginas | AA01 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2012 | 17 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 03 abr 2011 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2011 avec liste complète des actionnaires | 17 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 28 mar 2010 | 12 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 03 abr 2010 avec liste complète des actionnaires | 17 páginas | AR01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2009 | 12 páginas | AA | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEGLEY, Orla | Secretario | Mount Catherine IRISH Clonara County Clare Ireland | Irish | 110696690001 | ||||||
| BEGLEY, Orla | Director | C/O Wyman Gordon Houston Road EH54 5BZ Houston Industrial Estate Livingtson | Ireland | Irish | 181954690001 | |||||
| EDELSTYN, Paul | Director | C/O Wyman Gordon Houston Road EH54 5BZ Houston Industrial Estate Livingtson | Great Britain | British | 75860830006 | |||||
| BEYER, Ruth | Secretario | 13563 Southwood Court 97035 Lake Oswego Oregon Usa | American | 48728090001 | ||||||
| GALLACHER, Paul Francis | Secretario | 28 Newmill Road KA3 4BA Dunlop Ayrshire | British | 82858290001 | ||||||
| SINCLAIR, Scott | Secretario | 6 Lodge Crescent PA13 4PZ Kilmacolm Renfrewshire | British | 92313470001 | ||||||
| STEEL, Agnes | Secretario | 2 Taylor Brown Close Stewarton KA3 5DG Kilmarnock Ayrshire | British | 923350002 | ||||||
| TUCKER, David John | Secretario | 7 Greenhill Avenue Giffnock G46 6QX Glasgow | British | 82818150001 | ||||||
| BECKER, Roger Paul | Director | Sw River Dr 97201 Portland 1930 Oregon America | United States | American | 136281750001 | |||||
| BLACKMORE, Steven Craig | Director | Portland 4430 Se Windsor Ct Oregon Usa | United States | American | 129100160001 | |||||
| CAWTE, John Dennis | Director | Tigh An Rhu Prieston Road PA11 3AW Bridge Of Weir Renfrewshire | Scotland | British | 64703090001 | |||||
| COOKE, Roger Anthony | Director | 1910 Sw Myrtle Street 97201 Portland Oregon United States | Usa | Usa | 134747640001 | |||||
| CROMBIE, Robert | Director | 1 Barrachnie Court Garrowhill G69 6PZ Glasgow | British | 923380002 | ||||||
| DONEGAN, Mark | Director | 2130 Windham Oaks Court West Linn Or 97068 Usa | American | 90933260002 | ||||||
| HAGEL, Shawn Rene | Director | 14979 Sw Juliet Terrace 972274 Tigard Oregon United States | United States | American | 133366200001 | |||||
| HAWKES, Geoffrey A | Director | 2810 Nw Beuhla Vista Terrace Portland Oregon 97210 Usa | Us Citizen | 76227940001 | ||||||
| HELBLING, Paul Arthur | Director | 13139 Rummel Creek Road 77079 Houston Texas Usa | American | 57213870001 | ||||||
| JASPERSON, Michael, Vice President | Director | 1315 Cricklewood Spring Texas 77379 Usa | American | 91100260001 | ||||||
| JOHNSON, James Andrist | Director | 11245 Sw Lynnridge Portland Oregon 97225 Usa | American | 50206970001 | ||||||
| KENNEDY, Neil John | Director | 10 Kirkland Park ML10 6AR Strathaven Lanarkshire | Scotland | British | 55112000001 | |||||
| LARSSON, William Dean | Director | 1865 Palisades Terrace Lake Oswego Oregon 97034 Usa | American | 96758530001 | ||||||
| LILLA, John Daryl | Director | 38 Pleasant Bend Drive 77382 The Woodlands Texas Usa | American | 57213860001 | ||||||
| MCCORMICK, William Charles | Director | 3479 Cascade Terrace OR 97068 West Linn Oregon Usa | United States | 69289590001 | ||||||
| MCDERMID, James Edward | Director | 157 Old Castle Road G44 5TJ Glasgow Lanarkshire | British | 64197810001 | ||||||
| NORRIS, David Warren | Director | 62 Morning Cloud 77381 The Woodlands Texas Usa | American | 57213900001 | ||||||
| PATTEE, Russell Scott | Director | Se Norwood Loop Happy Valley 11444 Oregon 97086 United States | United States | American | 132606280001 | |||||
| RAGAN, Donna Christine | Director | 4981 Mapleton Drive West Linn Oregon 97068 Usa | American | 52777980001 | ||||||
| RIEDEL, Steven Charles | Director | 23200 Sw Stafford Hill 97068 West Linn Oregon Usa | American | 57213640001 | ||||||
| ROBBINS, Wayne, President | Director | 7 Meadows Rose Place The Woodlands Texas 77392 Usa | American | 91100120001 | ||||||
| ROSKOPF, Mark R | Director | 9708 Nw Golden Avenue FOREIGN Vancouver Wa 98665 Usa | American | 92313320001 | ||||||
| SOK, Albertus Coert | Director | M Wibautstraat 14 9728M4 Groningen Netherlands | Dutch | 85498070001 | ||||||
| STEEL, Agnes | Director | 2 Taylor Brown Close Stewarton KA3 5DG Kilmarnock Ayrshire | British | 923350002 | ||||||
| STEEL, Ian | Director | 11 Holehouse Road KA30 1JH Largs Ayrshire | British | 64761770002 | ||||||
| STEEL, Thomas | Director | 3 Sandlewood Court Stewartfield East Kilbride Glasgowe | British | 923370003 | ||||||
| TUCKER, David John | Director | 7 Greenhill Avenue Giffnock G46 6QX Glasgow | British | 82818150001 |
¿Tiene PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| Standard security | Creado el 26 feb 1985 Entregado el 04 mar 1988 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Block 6 units 5/6 thornlie bank ind estate glasgow. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 04 oct 1977 Entregado el 11 oct 1977 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0