PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED

PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED

  • Visión general
  • Resumen
  • Propósito
  • Dirección
  • Nombres anteriores
  • Cuentas
  • Presentaciones
  • Directivos
  • Gravámenes
  • Fuente de datos
  • Visión general

    Nombre de la empresaPCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED
    Estado de la empresaDisuelta
    Forma jurídicaSociedad de responsabilidad limitada
    Número de empresa SC057099
    JurisdicciónEscocia
    Fecha de constitución
    Fecha de cese

    Resumen

    Tiene PSCs súper segurosNo
    Tiene gravámenes
    Tiene historial de insolvenciaNo
    La sede social está en disputaNo

    ¿Cuál es el propósito de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    • Otras actividades de apoyo a los negocios n.c.p. (82990) / Actividades administrativas y de apoyo

    ¿Dónde se encuentra PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Dirección de la sede social
    C/O Wyman Gordon
    Houston Road
    EH54 5BZ Houston Industrial Estate
    Livingtson
    Dirección de la sede social no entregableNo

    ¿Cuáles fueron los nombres anteriores de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Nombres anteriores de la empresa
    Nombre de la empresaDesdeHasta
    BARONSHIRE ENGINEERING LIMITED31 ene 197531 ene 1975

    ¿Cuáles son las últimas cuentas de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Últimas cuentas
    Últimas cuentas cerradas hasta03 abr 2011

    ¿Cuáles son las últimas presentaciones para PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Presentaciones
    FechaDescripciónDocumentoTipo

    Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ2(A)

    Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria

    1 páginasGAZ1(A)

    Solicitud de exclusión de la empresa del registro

    3 páginasDS01

    Resoluciones

    Resolutions
    2 páginasRESOLUTIONS
    Acuerdos
    CategoríaFechaDescripciónTipo
    capital

    Resolución de reducción del capital social emitido

    RES06

    legacy

    1 páginasSH20

    legacy

    1 páginasCAP-SS

    Estado de capital el 18 dic 2013

    • Capital: GBP 1.00
    4 páginasSH19

    Cancelación total de la carga 1

    1 páginasMR04

    Cancelación total de la carga 2

    1 páginasMR04

    Cese del nombramiento de Russell Scott Pattee como director el 26 sept 2013

    1 páginasTM01

    Nombramiento de Orla Begley como director el 26 sept 2013

    2 páginasAP01

    Nombramiento de Mr Paul Edelstyn como director el 26 sept 2013

    2 páginasAP01

    Cese del nombramiento de Roger Anthony Cooke como director el 26 sept 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Shawn Rene Hagel como director el 26 sept 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Steven Craig Blackmore como director el 26 sept 2013

    1 páginasTM01

    Cese del nombramiento de Roger Paul Becker como director el 26 sept 2013

    1 páginasTM01

    Exercice comptable en cours raccourci du 30 sept 2012 au 01 abr 2012

    3 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 03 abr 2013

    17 páginasAR01

    Exercice comptable précédent prolongé du 31 mar 2012 au 30 sept 2012

    3 páginasAA01

    Déclaration annuelle établie au 03 abr 2012

    17 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 03 abr 2011

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 abr 2011 avec liste complète des actionnaires

    17 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 28 mar 2010

    12 páginasAA

    Déclaration annuelle établie au 03 abr 2010 avec liste complète des actionnaires

    17 páginasAR01

    Cuentas completas preparadas hasta el 29 mar 2009

    12 páginasAA

    ¿Quiénes son los directivos de PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED?

    Directivos
    NombreNombrado elRenunció elRolDirecciónIdentificación de la empresaPaís de residenciaNacionalidadFecha de nacimientoOcupaciónNúmero
    BEGLEY, Orla
    Mount Catherine
    IRISH Clonara
    County Clare
    Ireland
    Secretario
    Mount Catherine
    IRISH Clonara
    County Clare
    Ireland
    Irish110696690001
    BEGLEY, Orla
    C/O Wyman Gordon
    Houston Road
    EH54 5BZ Houston Industrial Estate
    Livingtson
    Director
    C/O Wyman Gordon
    Houston Road
    EH54 5BZ Houston Industrial Estate
    Livingtson
    IrelandIrish181954690001
    EDELSTYN, Paul
    C/O Wyman Gordon
    Houston Road
    EH54 5BZ Houston Industrial Estate
    Livingtson
    Director
    C/O Wyman Gordon
    Houston Road
    EH54 5BZ Houston Industrial Estate
    Livingtson
    Great BritainBritish75860830006
    BEYER, Ruth
    13563 Southwood Court
    97035 Lake Oswego
    Oregon
    Usa
    Secretario
    13563 Southwood Court
    97035 Lake Oswego
    Oregon
    Usa
    American48728090001
    GALLACHER, Paul Francis
    28 Newmill Road
    KA3 4BA Dunlop
    Ayrshire
    Secretario
    28 Newmill Road
    KA3 4BA Dunlop
    Ayrshire
    British82858290001
    SINCLAIR, Scott
    6 Lodge Crescent
    PA13 4PZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    Secretario
    6 Lodge Crescent
    PA13 4PZ Kilmacolm
    Renfrewshire
    British92313470001
    STEEL, Agnes
    2 Taylor Brown Close
    Stewarton
    KA3 5DG Kilmarnock
    Ayrshire
    Secretario
    2 Taylor Brown Close
    Stewarton
    KA3 5DG Kilmarnock
    Ayrshire
    British923350002
    TUCKER, David John
    7 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QX Glasgow
    Secretario
    7 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QX Glasgow
    British82818150001
    BECKER, Roger Paul
    Sw River Dr
    97201 Portland
    1930
    Oregon
    America
    Director
    Sw River Dr
    97201 Portland
    1930
    Oregon
    America
    United StatesAmerican136281750001
    BLACKMORE, Steven Craig
    Portland
    4430 Se Windsor Ct
    Oregon
    Usa
    Director
    Portland
    4430 Se Windsor Ct
    Oregon
    Usa
    United StatesAmerican129100160001
    CAWTE, John Dennis
    Tigh An Rhu
    Prieston Road
    PA11 3AW Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    Director
    Tigh An Rhu
    Prieston Road
    PA11 3AW Bridge Of Weir
    Renfrewshire
    ScotlandBritish64703090001
    COOKE, Roger Anthony
    1910 Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    Oregon
    United States
    Director
    1910 Sw Myrtle Street
    97201 Portland
    Oregon
    United States
    UsaUsa134747640001
    CROMBIE, Robert
    1 Barrachnie Court
    Garrowhill
    G69 6PZ Glasgow
    Director
    1 Barrachnie Court
    Garrowhill
    G69 6PZ Glasgow
    British923380002
    DONEGAN, Mark
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    Director
    2130 Windham Oaks Court
    West Linn
    Or 97068
    Usa
    American90933260002
    HAGEL, Shawn Rene
    14979 Sw Juliet Terrace
    972274 Tigard
    Oregon
    United States
    Director
    14979 Sw Juliet Terrace
    972274 Tigard
    Oregon
    United States
    United StatesAmerican133366200001
    HAWKES, Geoffrey A
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Director
    2810 Nw Beuhla Vista Terrace
    Portland
    Oregon 97210
    Usa
    Us Citizen76227940001
    HELBLING, Paul Arthur
    13139 Rummel Creek Road
    77079 Houston
    Texas
    Usa
    Director
    13139 Rummel Creek Road
    77079 Houston
    Texas
    Usa
    American57213870001
    JASPERSON, Michael, Vice President
    1315 Cricklewood
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    Director
    1315 Cricklewood
    Spring
    Texas 77379
    Usa
    American91100260001
    JOHNSON, James Andrist
    11245 Sw Lynnridge
    Portland
    Oregon
    97225
    Usa
    Director
    11245 Sw Lynnridge
    Portland
    Oregon
    97225
    Usa
    American50206970001
    KENNEDY, Neil John
    10 Kirkland Park
    ML10 6AR Strathaven
    Lanarkshire
    Director
    10 Kirkland Park
    ML10 6AR Strathaven
    Lanarkshire
    ScotlandBritish55112000001
    LARSSON, William Dean
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    Director
    1865 Palisades Terrace
    Lake Oswego
    Oregon 97034
    Usa
    American96758530001
    LILLA, John Daryl
    38 Pleasant Bend Drive
    77382 The Woodlands
    Texas
    Usa
    Director
    38 Pleasant Bend Drive
    77382 The Woodlands
    Texas
    Usa
    American57213860001
    MCCORMICK, William Charles
    3479 Cascade Terrace
    OR 97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Director
    3479 Cascade Terrace
    OR 97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    United States69289590001
    MCDERMID, James Edward
    157 Old Castle Road
    G44 5TJ Glasgow
    Lanarkshire
    Director
    157 Old Castle Road
    G44 5TJ Glasgow
    Lanarkshire
    British64197810001
    NORRIS, David Warren
    62 Morning Cloud
    77381 The Woodlands
    Texas
    Usa
    Director
    62 Morning Cloud
    77381 The Woodlands
    Texas
    Usa
    American57213900001
    PATTEE, Russell Scott
    Se Norwood Loop
    Happy Valley
    11444
    Oregon 97086
    United States
    Director
    Se Norwood Loop
    Happy Valley
    11444
    Oregon 97086
    United States
    United StatesAmerican132606280001
    RAGAN, Donna Christine
    4981 Mapleton Drive
    West Linn
    Oregon
    97068
    Usa
    Director
    4981 Mapleton Drive
    West Linn
    Oregon
    97068
    Usa
    American52777980001
    RIEDEL, Steven Charles
    23200 Sw Stafford Hill
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    Director
    23200 Sw Stafford Hill
    97068 West Linn
    Oregon
    Usa
    American57213640001
    ROBBINS, Wayne, President
    7 Meadows Rose Place
    The Woodlands
    Texas 77392
    Usa
    Director
    7 Meadows Rose Place
    The Woodlands
    Texas 77392
    Usa
    American91100120001
    ROSKOPF, Mark R
    9708 Nw Golden Avenue
    FOREIGN Vancouver
    Wa 98665
    Usa
    Director
    9708 Nw Golden Avenue
    FOREIGN Vancouver
    Wa 98665
    Usa
    American92313320001
    SOK, Albertus Coert
    M Wibautstraat 14
    9728M4 Groningen
    Netherlands
    Director
    M Wibautstraat 14
    9728M4 Groningen
    Netherlands
    Dutch85498070001
    STEEL, Agnes
    2 Taylor Brown Close
    Stewarton
    KA3 5DG Kilmarnock
    Ayrshire
    Director
    2 Taylor Brown Close
    Stewarton
    KA3 5DG Kilmarnock
    Ayrshire
    British923350002
    STEEL, Ian
    11 Holehouse Road
    KA30 1JH Largs
    Ayrshire
    Director
    11 Holehouse Road
    KA30 1JH Largs
    Ayrshire
    British64761770002
    STEEL, Thomas
    3 Sandlewood Court
    Stewartfield
    East Kilbride
    Glasgowe
    Director
    3 Sandlewood Court
    Stewartfield
    East Kilbride
    Glasgowe
    British923370003
    TUCKER, David John
    7 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QX Glasgow
    Director
    7 Greenhill Avenue
    Giffnock
    G46 6QX Glasgow
    British82818150001

    ¿Tiene PCC FLOW TECHNOLOGIES LIMITED alguna carga?

    Gravámenes
    ClasificaciónFechasEstadoDetalles
    Standard security
    Creado el 26 feb 1985
    Entregado el 04 mar 1988
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Block 6 units 5/6 thornlie bank ind estate glasgow.
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 04 mar 1988Registro de una carga
    • 17 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)
    Floating charge
    Creado el 04 oct 1977
    Entregado el 11 oct 1977
    Satisfecho en su totalidad
    Cantidad garantizada
    All sums due or to become due
    Breve descripción
    Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital.
    Contiene una garantía flotante:
    Personas con derecho
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transacciones
    • 11 oct 1977Registro de una carga
    • 17 dic 2013Satisfacción de una carga (MR04)

    Fuente de datos

    • Companies House del Reino Unido
      El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros.
    • Licencia: CC0