THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED
Visión general
| Nombre de la empresa | THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED |
|---|---|
| Estado de la empresa | Disuelta |
| Forma jurídica | Sociedad de responsabilidad limitada |
| Número de empresa | SC058099 |
| Jurisdicción | Escocia |
| Fecha de constitución | |
| Fecha de cese |
Resumen
| Tiene PSCs súper seguros | No |
|---|---|
| Tiene gravámenes | Sí |
| Tiene historial de insolvencia | No |
| La sede social está en disputa | No |
¿Cuál es el propósito de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
- Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural (09100) / Explotación de minas y canteras
¿Dónde se encuentra THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Dirección de la sede social | C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum Aberdeenshire |
|---|---|
| Dirección de la sede social no entregable | No |
¿Cuáles fueron los nombres anteriores de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nombre de la empresa | Desde | Hasta |
|---|---|---|
| STOLT-NIELSEN SEAWAY (U.K.) LIMITED | 08 mar 1990 | 08 mar 1990 |
| STOLT-NIELSEN SEAWAY CONTRACTING LIMITED | 21 jun 1985 | 21 jun 1985 |
| STOLT-NEILSEN SEAWAY LIMITED | 02 jul 1975 | 02 jul 1975 |
¿Cuáles son las últimas cuentas de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Últimas cuentas | |
|---|---|
| Últimas cuentas cerradas hasta | 31 dic 2015 |
¿Cuáles son las últimas presentaciones para THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Fecha | Descripción | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boletín oficial final disuelto por cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ2(A) | ||||||||||
Primer aviso en el boletín oficial para la cancelación voluntaria | 1 páginas | GAZ1(A) | ||||||||||
Nombramiento de Mr James Henry John Marsh como secretario el 03 jul 2017 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael Hoggan como secretario el 03 jul 2017 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Solicitud de exclusión de la empresa del registro | 3 páginas | DS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 15 sept 2016 con actualizaciones | 4 páginas | CS01 | ||||||||||
Declaración de confirmación presentada el 08 sept 2016 con actualizaciones | 5 páginas | CS01 | ||||||||||
Cuentas completas preparadas hasta el 31 dic 2015 | 20 páginas | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 sept 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio de datos del director Mr Martin Graham Marsh el 01 sept 2015 | 2 páginas | CH01 | ||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2014 | 7 páginas | AA | ||||||||||
Cese del nombramiento de Michael John Howarth como director el 13 ago 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Giovanni Corbetta como director el 05 ago 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga SC0580990012 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 11 | 4 páginas | MR04 | ||||||||||
Domicilio social registrado cambiado de 123 Ashgrove Road West Aberdeen AB16 5FA a C/O James Fisher Offshore Limited North Meadows Oldmeldrum Aberdeenshire AB51 0GC el 12 feb 2015 | 1 páginas | AD01 | ||||||||||
Nombramiento de Michael Hoggan como secretario el 09 feb 2015 | 2 páginas | AP03 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Russell Smith como director el 09 feb 2015 | 1 páginas | TM01 | ||||||||||
Cese del nombramiento de David Russell Smith como secretario el 09 feb 2015 | 1 páginas | TM02 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Martin Graham Marsh como director el 09 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Nombramiento de Mr Michael John Howarth como director el 09 feb 2015 | 2 páginas | AP01 | ||||||||||
Cancelación total de la carga 10 | 1 páginas | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle établie au 08 sept 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 páginas | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cuentas para una empresa pequeña preparadas hasta el 31 dic 2013 | 6 páginas | AA | ||||||||||
Alteraciones a una garantía flotante | 11 páginas | 466(Scot) | ||||||||||
¿Quiénes son los directivos de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nombre | Nombrado el | Renunció el | Rol | Dirección | Identificación de la empresa | País de residencia | Nacionalidad | Fecha de nacimiento | Ocupación | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH, James Henry John | Secretario | Michaelson Road LA14 1HR Barrow-In-Furness Fisher House Cumbria United Kingdom | 235026530001 | |||||||
| CORBETTA, Giovanni | Director | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | Scotland | British | 160476180001 | |||||
| MARSH, Martin Graham | Director | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | United Kingdom | British | 194923760001 | |||||
| HOGGAN, Michael | Secretario | North Meadows AB51 0GC Oldmeldrum C/O James Fisher Offshore Limited Aberdeenshire United Kingdom | 194965170001 | |||||||
| SMITH, David Russell | Secretario | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | British | 20205140001 | ||||||
| PAULL & WILLIAMSONS | Secretario corporativo | Union Plaza (6th Floor) 1 Union Wynd AB10 1DQ Aberdeen | 24280001 | |||||||
| STOLT OFFSHORE M.S. LIMITED | Secretario corporativo | Bucksburn House Howes Road AB16 7QU Aberdeen Aberdeenshire | 74739410001 | |||||||
| ANDERSEN, Ole Christian | Director | 47 Marischal Street AB1 2AB Aberdeen | Norwegian | 1300200003 | ||||||
| ANDERSON, Ole Christian | Director | 33 Stenderveien 5542 Karsmund Haugesund | British | 1300200001 | ||||||
| BRANNAN, Thomas | Director | Cluniter Road Innellan PA23 7SA Dunoon 3 Calderwood | Scotland | British | 140573350001 | |||||
| BRUNNEN, Jeremy Alan | Director | 6 Clarence Lodge Middle Hill TW20 0NW Egham Surrey | British | 44706880003 | ||||||
| CHABAS, Bruno Yves Raymond | Director | 8 Western Road RG9 1JL Henley On Thames | French | 66271250006 | ||||||
| FRIKSTAD, Paul Arild | Director | 3a Rubislaw Don North AB15 4AL Aberdeen | Norwegian | 86298910001 | ||||||
| HIRST, Terence John | Director | 73 Kings Gate AB2 6BN Aberdeen Grampian Scotland | British | 39503560001 | ||||||
| HOWARTH, Michael John | Director | 123 Ashgrove Road West AB16 5FA Aberdeen National Hyperbaric Centre United Kingdom | United Kingdom | British | 172532620001 | |||||
| JOHN, Michael Dendle | Director | Dundas Yews EH34 5DS Pencaitland | British | 641280001 | ||||||
| LIE, Kaare Johannes | Director | Fiolvegen 1 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336280001 | ||||||
| MACKIE, Grahame John Sinclair | Director | 35 Hammersmith Road AB1 6NA Aberdeen Aberdeenshire | British | 676720001 | ||||||
| MELING, Jan Fredrik | Director | Naumdoelaveien 18 FOREIGN Haugesund Norway | Norwegian | 1336290001 | ||||||
| MIKAELSEN, Oeyvind | Director | Ragnh Ildsgate 48 4044 Hafrsejord Norway | Norwegian | 91267430001 | ||||||
| OAKLEY, Stuart David | Director | Castleton House 15 The Chanonry AB24 1RP Aberdeen Aberdeenshire Scotland | British | 38261820001 | ||||||
| SKOUVEROE, Jan Frithjof | Director | Lillevannsveien 12c FOREIGN 0390 Oslo 3 Norway | Norwegian | 25049690001 | ||||||
| SMITH, David Russell | Director | Manor House Midmar AB51 7LX Inverurie Aberdeenshire | Scotland | British | 20205140001 | |||||
| SVENSON, Einar Wold | Director | 3 Haraldskroken 4041 Hafrsfjord | British | 1396780001 | ||||||
| VOSSIER, Bernard Lucien | Director | Bede House Court 54 Don Street AB2 1UU Aberdeen | French | 44196670001 | ||||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Director | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 | |||||
| WEBSTER, Gary Roderick | Director | 3 Bograxie Burnhervie AB51 5LD Inverurie | Scotland | British | 1130100002 |
¿Quiénes son las personas con control significativo de THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED?
| Nombre | Notificado el | Dirección | Cesado | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Safety Management Limited | 06 abr 2016 | Oldmeldrum 4 AB51 0DG Inverurie Fisher Offshore Westbank Park Scotland | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Naturaleza del control
| |||||||||||||
¿Tiene THE NATIONAL HYPERBARIC CENTRE LIMITED alguna carga?
| Clasificación | Fechas | Estado | Detalles | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creado el 10 jun 2014 Entregado el 19 jun 2014 | Satisfecho en su totalidad | ||
La garantía flotante cubre todo: Sí Contiene una promesa negativa: Sí Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 14 dic 2004 Entregado el 17 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Tenants interest in 2.9 acres at 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 02 dic 2004 Entregado el 11 dic 2004 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 15 may 1992 Entregado el 27 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Leasehold interest in 123 ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 15 may 1992 Entregado el 27 may 1992 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Area of ground extending to 2.9 acres or thereby lying to the south-east of ashgrove road west, aberdeen. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Floating charge | Creado el 21 ene 1991 Entregado el 04 feb 1991 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 24 ago 1990 Entregado el 29 ago 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Undertaking and all property and assets present and future of the company including uncalled capital. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| ||||
| Standard security | Creado el 16 jul 1990 Entregado el 27 jul 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Transacciones
| ||||
| Standard security | Creado el 29 may 1990 Entregado el 06 jun 1990 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción Loirston cottage cove bay nigg. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 30 mar 1987 Entregado el 06 abr 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Letter of offset | Creado el 19 mar 1987 Entregado el 27 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due by seaway technology and another | |
Breve descripción Balances at credit of any accounts held by the governor and company of the bank of scotland in the name of stolt-nielsen seaway contracting limited. | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
| Bond & floating charge | Creado el 19 mar 1987 Entregado el 27 mar 1987 | Satisfecho en su totalidad | Cantidad garantizada All sums due or to become due | |
Breve descripción The whole assets of the company. Contiene una garantía flotante: Sí | ||||
Personas con derecho
| ||||
Transacciones
| ||||
Fuente de datos
- Companies House del Reino Unido
El registro oficial de empresas en el Reino Unido, que proporciona acceso público a información sobre empresas, como nombres, direcciones, administradores y registros financieros. - Licencia: CC0